PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED

PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03044788
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED?

    • fabbricazione di preparati farmaceutici (21200) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Granary, The Courtyard Barns Choke Lane
    Cookham Dean
    SL6 6PT Maidenhead
    Berkshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BUBBLECHARM LIMITED11 apr 199511 apr 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 03 giu 2021

    • Capitale: GBP 1.00
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account cancelled 01/06/2021
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2019

    26 pagineAA

    Cessazione della carica di Shafiq Choudhary come amministratore in data 30 set 2020

    1 pagineTM01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Shafiq Choudhary il 07 ago 2014

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Jorge Muntañola Prat come amministratore in data 19 feb 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Rene Just come amministratore in data 04 mar 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Konstantin Von Alvensleben come amministratore in data 03 mar 2020

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018

    25 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da PO Box SL6 6PT the Courtyard Barns the Courtyard Barns Choke Lane Maidenhead Berkshire SL6 6PT United Kingdom a The Granary, the Courtyard Barns Choke Lane Cookham Dean Maidenhead Berkshire SL6 6PT in data 15 lug 2019

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Rene Just come amministratore in data 23 gen 2019

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da The Granary Courtyard Barns Choke Lane Maidenhead Berkshire SL6 6PT a PO Box SL6 6PT the Courtyard Barns the Courtyard Barns Choke Lane Maidenhead Berkshire SL6 6PT in data 24 ott 2018

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Kevin James come amministratore in data 16 ott 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017

    25 pagineAA

    Cessazione della carica di Uwe Salzer come amministratore in data 31 ago 2018

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MUNTAÑOLA PRAT, Jorge
    Choke Lane
    Cookham Dean
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary, The Courtyard Barns
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Choke Lane
    Cookham Dean
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary, The Courtyard Barns
    Berkshire
    England
    SpainSpanish268494790001
    BERESFORD, William Reginald
    17 Old Hall Court
    SY14 8NE Malpas
    Cheshire
    Segretario
    17 Old Hall Court
    SY14 8NE Malpas
    Cheshire
    British43357210001
    BOULTON, Paul
    365 Atherton Road
    Hindley
    WN2 3XD Wigan
    Lancashire
    Segretario
    365 Atherton Road
    Hindley
    WN2 3XD Wigan
    Lancashire
    British38691820002
    NIGHTINGALE, John
    17 Waverton Mill Quays
    Waverton
    CH3 7PX Chester
    Cheshire
    Segretario
    17 Waverton Mill Quays
    Waverton
    CH3 7PX Chester
    Cheshire
    British43357120001
    BRIGHTON SECRETARY LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    Segretario nominato
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004700001
    BERESFORD, William Reginald
    17 Old Hall Court
    SY14 8NE Malpas
    Cheshire
    Amministratore
    17 Old Hall Court
    SY14 8NE Malpas
    Cheshire
    United KingdomBritish43357210001
    BOULTON, Paul
    Choke Lane
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary Courtyard Barns
    Berkshire
    Amministratore
    Choke Lane
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary Courtyard Barns
    Berkshire
    EnglandBritish38691820002
    CHOUDHARY, Shafiq Mohammed, Dr
    Choke Lane
    Cookham Dean
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary, The Courtyard Barns
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Choke Lane
    Cookham Dean
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary, The Courtyard Barns
    Berkshire
    England
    EnglandBritish109942870002
    DICKSON, Brian, Dr
    Choke Lane
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary Courtyard Barns
    Berkshire
    Amministratore
    Choke Lane
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary Courtyard Barns
    Berkshire
    UsaBritish7120320003
    JAMES, Kevin
    Choke Lane
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary Courtyard Barns
    Berkshire
    Amministratore
    Choke Lane
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary Courtyard Barns
    Berkshire
    United KingdomBritish159118070001
    JUST, Rene
    Choke Lane
    Cookham Dean
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary, The Courtyard Barns
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Choke Lane
    Cookham Dean
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary, The Courtyard Barns
    Berkshire
    England
    GermanyDanish255117780001
    NIGHTINGALE, John
    17 Waverton Mill Quays
    Waverton
    CH3 7PX Chester
    Cheshire
    Amministratore
    17 Waverton Mill Quays
    Waverton
    CH3 7PX Chester
    Cheshire
    British43357120001
    POOLE, Jeremy Frederick
    Crewe Hall
    Weston Road
    CW2 5XN Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    Crewe Hall
    Weston Road
    CW2 5XN Crewe
    Cheshire
    EnglandBritish34237410003
    SALZER, Uwe, Dr.
    Choke Lane
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary Courtyard Barns
    Berkshire
    Amministratore
    Choke Lane
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary Courtyard Barns
    Berkshire
    GermanyGerman213495730001
    VIGGARS, Julian George
    88 Whitbarrow Road
    WA13 9BA Lymm
    Cheshire
    Amministratore
    88 Whitbarrow Road
    WA13 9BA Lymm
    Cheshire
    United KingdomBritish122088920001
    VON ALVENSLEBEN, Konstantin
    Choke Lane
    Cookham Dean
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary, The Courtyard Barns
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Choke Lane
    Cookham Dean
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary, The Courtyard Barns
    Berkshire
    England
    GermanyGerman202414100001
    VON BUCHWALDT, Beatrix
    Choke Lane
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary Courtyard Barns
    Berkshire
    Amministratore
    Choke Lane
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary Courtyard Barns
    Berkshire
    GermanyGerman202414110001
    WHITEMORE, Robert Leonard
    The Dovecote
    Main Street
    YO26 8JR Hessay
    Yorkshire
    Amministratore
    The Dovecote
    Main Street
    YO26 8JR Hessay
    Yorkshire
    EnglandBritish98580600003
    WRIGHT, Philip John
    Choke Lane
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary Courtyard Barns
    Berkshire
    Amministratore
    Choke Lane
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary Courtyard Barns
    Berkshire
    EnglandBritish200818410001
    WYATT, Mark Andrew, Dr
    14 Victoria Road
    FY8 1LE Lytham St Annes
    Lancashire
    Amministratore
    14 Victoria Road
    FY8 1LE Lytham St Annes
    Lancashire
    EnglandBritish248335090001
    BRIGHTON DIRECTOR LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    Amministratore delegato nominato
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004690001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Riemser Pharma Uk Limited
    Courtyard Barns, Mount Farm
    Choke Lane
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary
    Berkshire
    England
    07 apr 2016
    Courtyard Barns, Mount Farm
    Choke Lane
    SL6 6PT Maidenhead
    The Granary
    Berkshire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    PECKFORTON PHARMACEUTICALS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 nov 2015
    Consegnato il 23 nov 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 mar 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 07 ago 2014
    Consegnato il 13 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 26 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 15 gen 2014
    Consegnato il 21 gen 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Gerri Henwood
    Transazioni
    • 21 gen 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 29 gen 2008
    Consegnato il 06 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 dic 2007
    Consegnato il 08 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or its nominees
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property present and future including goodwill uncalled share capital plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Risingstars Growth Fund Limited Partnership
    Transazioni
    • 08 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 dic 2007
    Consegnato il 08 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or its nominees
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property present and future including goodwill uncalled share capital plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The North West Business Investment Scheme
    Transazioni
    • 08 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 10 ott 2000
    Consegnato il 14 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 apr 2000
    Consegnato il 28 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the loan agreement of even date
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hh Investment Partners
    Transazioni
    • 28 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 08 dic 1999
    Consegnato il 17 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 apr 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 13 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 17 ott 1995
    Consegnato il 23 ott 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 23 ott 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit deed
    Creato il 08 giu 1995
    Consegnato il 20 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date
    Brevi particolari
    The interest in the interest earning account with the royal bank of scotland.
    Persone aventi diritto
    • James Andrew Gibson and Pauline Marina Gibson
    Transazioni
    • 20 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0