INTERNET NETWORK SERVICES LIMITED
Panoramica
Nome della società | INTERNET NETWORK SERVICES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03047165 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di INTERNET NETWORK SERVICES LIMITED?
- Altre attività di telecomunicazioni (61900) / Informazione e comunicazione
Dove si trova INTERNET NETWORK SERVICES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di INTERNET NETWORK SERVICES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
LABALITE LIMITED | 19 apr 1995 | 19 apr 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di INTERNET NETWORK SERVICES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per INTERNET NETWORK SERVICES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Tarek Sayed come amministratore in data 01 mag 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 mar 2017 | 16 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 224 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 ott 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||
Cessazione della carica di Vodafone Corporate Secretaries Limited come amministratore in data 31 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Vodafone Corporate Secretaries Limited come segretario in data 31 mag 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Vodafone Enterprise Corporate Secretaries Limited come segretario in data 31 mag 2017 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Nomina di Vodafone Enterprise Corporate Secretaries Limited come amministratore in data 31 mag 2017 | 2 pagine | AP02 | ||||||||||
Nomina di Mr Gregory Mook come amministratore in data 31 mag 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 18 apr 2017
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Tarek Sayed come amministratore in data 18 nov 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Mullock come amministratore in data 18 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 13 ott 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di INTERNET NETWORK SERVICES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Segretario | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 232519770001 | ||||||||||
MOOK, Gregory | Amministratore | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | British | Company Director | 212436560001 | ||||||||
VODAFONE ENTERPRISE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Amministratore | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 232519770001 | ||||||||||
BOLTON, Jonathan Mark | Segretario | 22 Winchester Drive HA5 1DB Pinner Middlesex | British | Company Secretary | 15931960005 | |||||||||
DAVIDSON, Lorraine | Segretario | 18b Denver Road N16 5JH London | British | 103543780001 | ||||||||||
HANSCOMB, Heledd Mair | Segretario | 63 Casewick Road SE27 0TB London | British | 66806360001 | ||||||||||
HANSCOMB, Heledd Mair | Segretario | 63 Casewick Road SE27 0TB London | British | 66806360001 | ||||||||||
MOORE, Paul Anthony | Segretario | Longshot Lane RG12 1XL Bracknell Waterside House Berkshire United Kingdom | 152558880001 | |||||||||||
STEEL, Nina Jane Louise | Segretario | 3 Stroud Road Wimbledon Park SW19 8DQ London | British | 40287550003 | ||||||||||
COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||||||
VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Segretario | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom |
| 75473330004 | ||||||||||
ALMEIDA, Richard Phillip | Amministratore | 22 Ivy Drive GU18 5YZ Lightwater Surrey | British | Consultant | 36280330002 | |||||||||
BOLTON, Jonathan Mark | Amministratore | 22 Winchester Drive HA5 1DB Pinner Middlesex | England | British | Company Secretary | 15931960005 | ||||||||
CHALLONER, Timothy William | Amministratore | 3 Stroud Road Wimbledon Park SW19 8DQ London | British | Computer Engineer | 74389320002 | |||||||||
CLAYDON, Kenneth Keith | Amministratore | 1 Parr House 12 Beaulieu Avenue E16 1TS London | British | Company Secretary | 60709330001 | |||||||||
COLES, Stephen James | Amministratore | 48 Ardmore Lane IG9 5SA Buckhurst Hill Essex | England | British | Chartered Accountant | 48921780001 | ||||||||
COLLATOS, William Peter | Amministratore | 25 Fountain Street FOREIGN Newton Massachusetts 02165 Usa | United States | Venture Capital | 67925850001 | |||||||||
COOPER, Nicholas Ian | Amministratore | 26 Red Lion Square WC1R 4HQ London 3rd Floor | Uk | British | Group General Counsel & Co Sec | 122128470002 | ||||||||
DAVIS, Philip Stephen James | Amministratore | Longshot Lane RG12 1XL Bracknell Waterside House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Lawyer | 135958960001 | ||||||||
DENOON-DUNCAN, Russell Euan | Amministratore | Rose Cottage Watts Road KT7 0BX Thames Ditton Surrey | British | Solicitor | 26310630001 | |||||||||
FITZ, Joseph Daniel | Amministratore | 35 Aria House 5-15 Newton Street Covent Garden WC2B 5EN London | British | Solicitor | 70579740002 | |||||||||
GIBSON, Ian Jeffrey | Amministratore | Stanmore House 3 Silverdale Road RH15 0ED Burgess Hill West Sussex | England | British | Accountant | 78528840005 | ||||||||
HANSCOMB, Heledd Mair | Amministratore | 63 Casewick Road SE27 0TB London | United Kingdom | British | Company Secretary | 66806360001 | ||||||||
HOGGARTH, Royston | Amministratore | The Barley House Hawks Meadow Snowford Hall Farm CV33 9ES Hunningham Warwickshire | England | British | Ceo Cable & Wireless Uk | 67927330001 | ||||||||
JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe | Amministratore | 25 Chiswick Quay W4 3UR London | England | British | Accountant | 108268030003 | ||||||||
KINCH, Alan Royston | Amministratore | Longshot Lane RG12 1XL Bracknell Waterside House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | English | Accountant | 163334420001 | ||||||||
LERWILL, Robert Earl | Amministratore | Water Street WC2R 3LA London 1 | British | Finance Director | 51239200003 | |||||||||
MACPHERSON, Ronald Thomas Stewart, Sir | Amministratore | 27 Archery Close W2 2BE London | British | Company Director | 49140580001 | |||||||||
MCGHEE, Neil Kenneth Ormrod | Amministratore | 12 Salisbury Road LE1 7QR Leicester Marlborough House Leicestershire | United Kingdom | British | Marketing | 112915690002 | ||||||||
MORGAN, Nicola Jane | Amministratore | 58 Farnham Road GU2 4PE Guildford Surrey | British | Accountant | 123399870001 | |||||||||
MULLOCK, Richard | Amministratore | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | British | Accountant | 193570430001 | ||||||||
NORTON, Graham Howard | Amministratore | Storrs Hill Cottage White Rose Lane GU22 7LB Woking Surrey | British | Uk Chief Financial Officer | 91014890001 | |||||||||
PHILLIP, Kerry | Amministratore | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire | United Kingdom | British | Solicitor | 185033430001 | ||||||||
SAYED, Tarek | Amministratore | Cypress Court GU25 4TB Virginia Water 1 England England | United Kingdom | British | Director | 215751210001 | ||||||||
SOLOMON, Liliana | Amministratore | 9 Bracknell Gardens NW3 7EE London | German | Cfo Gwuk | 100573180001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di INTERNET NETWORK SERVICES LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cable & Wireless Uk Holdings Limited | 06 apr 2016 | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
INTERNET NETWORK SERVICES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Rent deposit deed | Creato il 03 nov 1998 Consegnato il 06 nov 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee payable under a lease of even date and the deed | |
Brevi particolari £81,723.60; an interest bearing account in the name of the company and specifically designated ground floor the pinnacle deposit account, the amount stanidng thereto and all interest credited. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 06 mar 1998 Consegnato il 10 mar 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee payable under a lease dated 6TH march 1998 | |
Brevi particolari £118,841.85 and interest being the amount standing to the credit of an interest bearing account in the name of the tenant. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 10 ott 1996 Consegnato il 30 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0