HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED

HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03047787
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 4 Red Shute Hill Industrial Estate, Red Shute Hill
    Hermitage
    RG18 9QL Newbury
    Berkshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HUNT VALVES & FITTINGS LIMITED07 set 199507 set 1995
    HUNT VALVES LIMITED07 lug 199507 lug 1995
    RAYLORNET LIMITED20 apr 199520 apr 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Lynne Gilder come amministratore in data 06 ott 2017

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 20-22 Bedford Row London WC1R 4JS a Unit 4 Red Shute Hill Industrial Estate, Red Shute Hill Hermitage Newbury Berkshire RG18 9QL in data 22 feb 2017

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Jordan Company Secretaries Limited come segretario in data 17 nov 2016

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 mag 2016

    Stato del capitale al 23 mag 2016

    • Capitale: GBP 1,075,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di David Norman Reid Kemp come amministratore in data 07 mag 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 20 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 apr 2015

    Stato del capitale al 20 apr 2015

    • Capitale: GBP 1,075,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew David Ramage come segretario in data 30 nov 2014

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Andrew David Ramage come amministratore in data 30 nov 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Jordan Company Secretaries Limited come segretario in data 30 nov 2014

    2 pagineAP04

    Bilancio annuale redatto al 20 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 apr 2014

    Stato del capitale al 24 apr 2014

    • Capitale: GBP 1,075,000
    SH01

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 4

    2 pagineMR05

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2013 al 31 mar 2014

    1 pagineAA01

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    10 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew David Ramage il 01 apr 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Andrew David Ramage il 01 apr 2013

    2 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 20 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EVERETT, Peter John
    Meadow Way
    Rowledge
    GU10 4BS Farnham
    13
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Meadow Way
    Rowledge
    GU10 4BS Farnham
    13
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish98703960003
    MACKENZIE, Derrick Thomas Munro
    Lockview Drive
    Bridge Of Don
    AB23 8QF Aberdeen
    3
    United Kingdom
    Amministratore
    Lockview Drive
    Bridge Of Don
    AB23 8QF Aberdeen
    3
    United Kingdom
    United KingdomBritish151716530001
    HUNT, Barbara Anne
    The Drove House Drove Lane
    Cold Ash
    RG18 9NP Thatcham
    Berkshire
    Segretario
    The Drove House Drove Lane
    Cold Ash
    RG18 9NP Thatcham
    Berkshire
    British62854160001
    LATHAM, Anthony Robert
    London Bridge
    SE1 9QR London
    Bridge House
    United Kingdom
    Segretario
    London Bridge
    SE1 9QR London
    Bridge House
    United Kingdom
    British30869320001
    LATHAM, Anthony Robert
    Lone Elm
    46 Victoria Road
    OX14 1DQ Abingdon
    Oxfordshire
    Segretario
    Lone Elm
    46 Victoria Road
    OX14 1DQ Abingdon
    Oxfordshire
    British30869320001
    RAMAGE, Andrew David
    Kimmerghame Place
    EH4 2GD Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Kimmerghame Place
    EH4 2GD Edinburgh
    1
    United Kingdom
    174408750001
    JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED
    BS1 6JS Bristol
    21 St Thomas Street
    United Kingdom
    Segretario
    BS1 6JS Bristol
    21 St Thomas Street
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione00555893
    97584300001
    RM REGISTRARS LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Segretario nominato
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900000760001
    DRAPER, Steven
    London Bridge
    SE1 9QR London
    Bridge House
    United Kingdom
    Amministratore
    London Bridge
    SE1 9QR London
    Bridge House
    United Kingdom
    British85442360001
    GILDER, Lynne
    Baberton Crescent
    EH4 5BP Edinburgh
    28
    United Kingdom
    Amministratore
    Baberton Crescent
    EH4 5BP Edinburgh
    28
    United Kingdom
    United KingdomBritish174405730001
    HUNT, Barbara Anne
    The Drove House Drove Lane
    Cold Ash
    RG18 9NP Thatcham
    Berkshire
    Amministratore
    The Drove House Drove Lane
    Cold Ash
    RG18 9NP Thatcham
    Berkshire
    British62854160001
    HUNT, Geoffrey Douglas
    The Drove House Drove Lane
    Cold Ash
    RG18 9NP Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    The Drove House Drove Lane
    Cold Ash
    RG18 9NP Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish11605030001
    KEMP, David Norman Reid
    West End
    Bearsden
    G61 1DN Glasgow
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    West End
    Bearsden
    G61 1DN Glasgow
    8
    United Kingdom
    ScotlandBritish109664970001
    LATHAM, Anthony Robert
    London Bridge
    SE1 9QR London
    Bridge House
    United Kingdom
    Amministratore
    London Bridge
    SE1 9QR London
    Bridge House
    United Kingdom
    British30869320001
    RAMAGE, Andrew David
    Kimmerghame Place
    EH4 2GD Edinburgh
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Kimmerghame Place
    EH4 2GD Edinburgh
    1
    United Kingdom
    ScotlandBritish174406220002
    SMITH, Leslie Arthur David
    Countryside 13 Salisbury Road
    RG17 0LG Hungerford
    Berkshire
    Amministratore
    Countryside 13 Salisbury Road
    RG17 0LG Hungerford
    Berkshire
    British11647970002
    SMITH, Leslie Arthur David
    Squirrel Lodge The Mount
    Highclere
    RG15 9RA Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Squirrel Lodge The Mount
    Highclere
    RG15 9RA Newbury
    Berkshire
    British11647970001
    STEWART, Colin
    106 Craigiebuckler Avenue
    AB1 8PA Aberdeen
    Aberdeenshire
    Amministratore
    106 Craigiebuckler Avenue
    AB1 8PA Aberdeen
    Aberdeenshire
    British12242270001
    RM NOMINEES LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Amministratore delegato nominato
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900009140001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Hsp Group Limited
    Red Shute Hill Industrial Estate, Red Shute Hill
    Hermitage
    RG18 9QL Thatcham
    Unit 4
    England
    06 apr 2016
    Red Shute Hill Industrial Estate, Red Shute Hill
    Hermitage
    RG18 9QL Thatcham
    Unit 4
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione05078185
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of accession
    Creato il 21 mar 2013
    Consegnato il 02 apr 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each UK domiciled loan party to the UK facility secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The specified shares and all related distribution rights the blocked accounts and all monies standing to the credit of such blocked accounts and the debts represented by them all intellectual property rights and all right title and interest in and to the equipment see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America N.a, London Branch
    Transazioni
    • 02 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 gen 2014Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 28 set 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 16 giu 2004
    Consegnato il 07 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assignment of life policies
    Creato il 03 mag 1996
    Consegnato il 23 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other group company to the chargee on any account whatsoever including under the facilities agreement
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the policies and all moneys including bonuses accrued or which may accrue. Policy no.2795451LU for £1,000,000. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee and debenture
    Creato il 30 nov 1995
    Consegnato il 15 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0