HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03047787 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Unit 4 Red Shute Hill Industrial Estate, Red Shute Hill Hermitage RG18 9QL Newbury Berkshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HUNT VALVES & FITTINGS LIMITED | 07 set 1995 | 07 set 1995 |
| HUNT VALVES LIMITED | 07 lug 1995 | 07 lug 1995 |
| RAYLORNET LIMITED | 20 apr 1995 | 20 apr 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Lynne Gilder come amministratore in data 06 ott 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 apr 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 20-22 Bedford Row London WC1R 4JS a Unit 4 Red Shute Hill Industrial Estate, Red Shute Hill Hermitage Newbury Berkshire RG18 9QL in data 22 feb 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jordan Company Secretaries Limited come segretario in data 17 nov 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di David Norman Reid Kemp come amministratore in data 07 mag 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew David Ramage come segretario in data 30 nov 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew David Ramage come amministratore in data 30 nov 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Jordan Company Secretaries Limited come segretario in data 30 nov 2014 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 apr 2014 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 4 | 2 pagine | MR05 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2013 al 31 mar 2014 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 2 pagine | AUD | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew David Ramage il 01 apr 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Andrew David Ramage il 01 apr 2013 | 2 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 apr 2013 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVERETT, Peter John | Amministratore | Meadow Way Rowledge GU10 4BS Farnham 13 Surrey United Kingdom | England | British | 98703960003 | |||||||||
| MACKENZIE, Derrick Thomas Munro | Amministratore | Lockview Drive Bridge Of Don AB23 8QF Aberdeen 3 United Kingdom | United Kingdom | British | 151716530001 | |||||||||
| HUNT, Barbara Anne | Segretario | The Drove House Drove Lane Cold Ash RG18 9NP Thatcham Berkshire | British | 62854160001 | ||||||||||
| LATHAM, Anthony Robert | Segretario | London Bridge SE1 9QR London Bridge House United Kingdom | British | 30869320001 | ||||||||||
| LATHAM, Anthony Robert | Segretario | Lone Elm 46 Victoria Road OX14 1DQ Abingdon Oxfordshire | British | 30869320001 | ||||||||||
| RAMAGE, Andrew David | Segretario | Kimmerghame Place EH4 2GD Edinburgh 1 United Kingdom | 174408750001 | |||||||||||
| JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | BS1 6JS Bristol 21 St Thomas Street United Kingdom |
| 97584300001 | ||||||||||
| RM REGISTRARS LIMITED | Segretario nominato | Second Floor 80 Great Eastern Street EC2A 3RX London | 900000760001 | |||||||||||
| DRAPER, Steven | Amministratore | London Bridge SE1 9QR London Bridge House United Kingdom | British | 85442360001 | ||||||||||
| GILDER, Lynne | Amministratore | Baberton Crescent EH4 5BP Edinburgh 28 United Kingdom | United Kingdom | British | 174405730001 | |||||||||
| HUNT, Barbara Anne | Amministratore | The Drove House Drove Lane Cold Ash RG18 9NP Thatcham Berkshire | British | 62854160001 | ||||||||||
| HUNT, Geoffrey Douglas | Amministratore | The Drove House Drove Lane Cold Ash RG18 9NP Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 11605030001 | |||||||||
| KEMP, David Norman Reid | Amministratore | West End Bearsden G61 1DN Glasgow 8 United Kingdom | Scotland | British | 109664970001 | |||||||||
| LATHAM, Anthony Robert | Amministratore | London Bridge SE1 9QR London Bridge House United Kingdom | British | 30869320001 | ||||||||||
| RAMAGE, Andrew David | Amministratore | Kimmerghame Place EH4 2GD Edinburgh 1 United Kingdom | Scotland | British | 174406220002 | |||||||||
| SMITH, Leslie Arthur David | Amministratore | Countryside 13 Salisbury Road RG17 0LG Hungerford Berkshire | British | 11647970002 | ||||||||||
| SMITH, Leslie Arthur David | Amministratore | Squirrel Lodge The Mount Highclere RG15 9RA Newbury Berkshire | British | 11647970001 | ||||||||||
| STEWART, Colin | Amministratore | 106 Craigiebuckler Avenue AB1 8PA Aberdeen Aberdeenshire | British | 12242270001 | ||||||||||
| RM NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Second Floor 80 Great Eastern Street EC2A 3RX London | 900009140001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hsp Group Limited | 06 apr 2016 | Red Shute Hill Industrial Estate, Red Shute Hill Hermitage RG18 9QL Thatcham Unit 4 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
HS PIPEQUIPMENT (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of accession | Creato il 21 mar 2013 Consegnato il 02 apr 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each UK domiciled loan party to the UK facility secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The specified shares and all related distribution rights the blocked accounts and all monies standing to the credit of such blocked accounts and the debts represented by them all intellectual property rights and all right title and interest in and to the equipment see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 16 giu 2004 Consegnato il 07 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assignment of life policies | Creato il 03 mag 1996 Consegnato il 23 mag 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or any other group company to the chargee on any account whatsoever including under the facilities agreement | |
Brevi particolari All right title and interest in and to the policies and all moneys including bonuses accrued or which may accrue. Policy no.2795451LU for £1,000,000. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 30 nov 1995 Consegnato il 15 dic 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0