CROWN DILMUN

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCROWN DILMUN
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 03047853
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CROWN DILMUN?

    • (7415) /

    Dove si trova CROWN DILMUN?

    Indirizzo della sede legale
    20-22 Bedford Row
    London
    WC1R 4JS
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CROWN DILMUN?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2002

    Quali sono le ultime deposizioni per CROWN DILMUN?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Andrew John Edwards come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di un amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 giu 2010

    Stato del capitale al 11 giu 2010

    • Capitale: GBP 14,000,000
    SH01

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine244

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    6 pagine363s

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share pledge in fav bos 17/08/04
    RES13

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    3 pagine403b

    legacy

    3 pagine403b

    Chi sono gli amministratori di CROWN DILMUN?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JORDAN COMPANY SECRETARIES LIMITED
    21 St Thomas Street
    BS1 6JS Bristol
    Avon
    Segretario nominato
    21 St Thomas Street
    BS1 6JS Bristol
    Avon
    900008790001
    EDWARDS, Andrew John
    Westhumble Street
    RH5 6BS Dorking
    1 Burford Corner
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Westhumble Street
    RH5 6BS Dorking
    1 Burford Corner
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandEnglish124890630001
    FORD, Christopher Stewart Lacklan
    70 Pulteney Road
    E18 1PS London
    Segretario
    70 Pulteney Road
    E18 1PS London
    British60840120001
    GRYKO, Witold Jan
    25 Beech Hall Crescent
    Highams Park
    E4 9NW London
    Segretario
    25 Beech Hall Crescent
    Highams Park
    E4 9NW London
    United Kingdom20765220001
    MINCING LANE CORPORATE SERVICES LIMITED
    Pickfords Wharf
    Clink Street
    SE1 9DG London
    Segretario
    Pickfords Wharf
    Clink Street
    SE1 9DG London
    32940220004
    AL ARADI, Sameer Salman
    House 1257 Road 7325
    Area 373
    Manama
    Bahrain
    Amministratore
    House 1257 Road 7325
    Area 373
    Manama
    Bahrain
    Bahraini70954350001
    BUCKLAND, John Milford
    1 Hay Hill
    W1X 7LF London
    Amministratore
    1 Hay Hill
    W1X 7LF London
    British46831060003
    GAWTHORPE, Simon David
    Flat 9
    61 & 69 Mortlake High Street
    SW14 8HL London
    Amministratore
    Flat 9
    61 & 69 Mortlake High Street
    SW14 8HL London
    British141497020001
    GRYKO, Witold Jan
    25 Beech Hall Crescent
    Highams Park
    E4 9NW London
    Amministratore
    25 Beech Hall Crescent
    Highams Park
    E4 9NW London
    United KingdomUnited Kingdom20765220001
    KHOURI, William
    Little Greens
    3 Hill Waye
    SL9 8BH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Little Greens
    3 Hill Waye
    SL9 8BH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Usa62083250002
    MARLOWE, Walter Abraham
    13 Redcliffe Road
    SW10 9NR London
    Amministratore
    13 Redcliffe Road
    SW10 9NR London
    American50107210001
    MCILVENNY, Robin Hugh
    8 Cambridge Road
    HP9 1HW Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    8 Cambridge Road
    HP9 1HW Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British17898090002
    MINASHI, Mark Anthony
    21 Nightingale Road
    WD3 2DE Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    21 Nightingale Road
    WD3 2DE Rickmansworth
    Hertfordshire
    EnglandBritish61124920002
    SUTTON, Nicholas Nelson
    The Penthouse 25a Vincent House
    Vincent Square
    SW1P 2NB London
    Amministratore
    The Penthouse 25a Vincent House
    Vincent Square
    SW1P 2NB London
    British38171430006
    TUPPEN, Jackie Mi Sin
    Pickfords Wharf
    SE1 9DG Clink Street
    London
    Amministratore
    Pickfords Wharf
    SE1 9DG Clink Street
    London
    British42837080001
    CROWN DILMUN(UK)HOLDINGS PLC
    20-22 Bedford Row
    WC1R 4JS London
    Amministratore
    20-22 Bedford Row
    WC1R 4JS London
    81310260001

    CROWN DILMUN ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge of deposit
    Creato il 17 mar 2006
    Consegnato il 25 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit initially of £90,000 credited to account designation 96679611 with the bank and any addition to that deposit and any deposit from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from or out of such initial deposit or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Share pledge
    Creato il 17 ago 2004
    Consegnato il 27 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by crown dilmun (robertson street) limited and/ or the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Twi issued ordinary shres of !.00 each of the company together with all rights and all dividends and other distributions.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share charge
    Creato il 27 giu 2003
    Consegnato il 15 lug 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (and/or to the hedging counterparty) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the investments including all rights of enforcement of the same. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Assignation of rents
    Creato il 16 giu 2003
    Consegnato il 21 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rents, licence fees and premiums and other payments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 26 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 9TH may 2003
    Creato il 09 mag 2003
    Consegnato il 17 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £518,230 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    131 albion street glasgow and 60 -104 trongate glasgow t/no: GLA102505.
    Persone aventi diritto
    • Glasgow City Council
    Transazioni
    • 17 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 26 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 12TH july 2002
    Creato il 28 giu 2002
    Consegnato il 19 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from crown dilmun albion street (C.I.) limited to the chargee and/or to the hedging counter party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    1-31 albion street glasgow and 60 to 104 trongate glasgow t/no: GLA102505.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of deposit under seal -general (third party) charge
    Creato il 22 gen 2001
    Consegnato il 29 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from crown dilmun (westcliff village) limited (the "debtor") to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the issued share capital of the debtor (2 ordinary shares of £1), and/or proceeds of sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 18TH december 2000
    Creato il 30 nov 2000
    Consegnato il 02 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1-31 albion street and 60-104 trongate glasgow t/no: GLA102505.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share charge
    Creato il 19 mag 2000
    Consegnato il 24 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the investments and all dividends, interest and other money payable to the chargor in respect of the investments.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag
    Transazioni
    • 24 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share charge
    Creato il 19 mag 2000
    Consegnato il 24 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of fixed charge the investments and all dividends, interest and other money payable to the chargor in respect of the investments.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag
    Transazioni
    • 24 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 19 nov 1998
    Consegnato il 08 dic 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond in favour of the national house building council for £160,000
    Brevi particolari
    The sum of £160,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 96679611.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Share charge
    Creato il 30 gen 1998
    Consegnato il 11 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All liabilities of crown dilmun 5 LTD to the chargee on any account whatsoever and due from crown dilmun PLC under the share charge
    Brevi particolari
    (A) the investments;and (b) all dividends,interest and other money payable to itself in respect of the investments.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bhf-Bank Ag
    Transazioni
    • 11 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Equitable mortgage over securities
    Creato il 06 gen 1998
    Consegnato il 10 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or crown dilmun 4 limited to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the terms of the finance documents (as defined therein) or in connection with the loan facility or other financial accommodation from time to time granted pursuant thereto
    Brevi particolari
    All assets deriving from all shares in the borower to which the copany is beneficially entitled including all rights dividends interest income etc arising by way of conversion bonus exchange purchase or option etc. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Meespierson N.V.
    Transazioni
    • 10 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 23 apr 1997
    Consegnato il 01 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a bond in favour of the national house building council for £130,000
    Brevi particolari
    The sum of £130,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 96679611.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 24 apr 1996
    Consegnato il 30 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a bond in favour of the national house building council for £100,000
    Brevi particolari
    The sum of £100,000 now or to be held by the bank on an account numbered 96679611.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 30 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over credit balances
    Creato il 15 apr 1996
    Consegnato il 17 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a bond in favour of the national house building council for £100,000
    Brevi particolari
    The sum of £100,000 together with interest accrued now or to be held by the bank on an account numbered 96679611.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 09 giu 1995
    Consegnato il 20 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 09 giu 1995
    Consegnato il 20 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a bridgewater house 10-15 bridgewater square l/b of city of london t/no NGL243089 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0