PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED

PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03048528
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    • (3410) /

    Dove si trova PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ASSETCO PAPWORTH LIMITED23 mar 200423 mar 2004
    ADVANCED TRANSPORT TECHNOLOGY LIMITED21 apr 199521 apr 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 set 2011
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2012
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al21 apr 2017
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma05 mag 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    2 pagineF10.2

    **Parte della proprietà o attività è stata liberata dall'onere ** 9

    5 pagineMR05

    **Parte della proprietà o attività è stata liberata dall'onere ** 8

    5 pagineMR05

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Mark Clissett come amministratore

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2011 al 30 set 2011

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Philip Mcdaid come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 21 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 ott 2011

    Stato del capitale al 11 ott 2011

    • Capitale: GBP 60,000
    SH01

    Nomina di Continental Shelf 548 Limited come amministratore

    3 pagineAP02

    Nomina di Continental Shelf 547 Limited come amministratore

    3 pagineAP02

    Cessazione della carica di Scott Brown come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Philip Mcdaid come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Scott Brown come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark Anthony Clissett come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Marcus Shannon come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    17 pagineAA

    Cessazione della carica di Ricahrd Fulton come segretario

    2 pagineTM02

    Nomina di Scott Brown come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Raymond Flynn come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Scott Douglas Brown come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Ricahrd Fulton come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Michael Lavender come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 21 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    A deed of accession 09/02/2010
    RES13

    Chi sono gli amministratori di PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CONTINENTAL SHELF 547 LIMITED
    Field End Road
    HA4 0QH South Ruislip
    800
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Field End Road
    HA4 0QH South Ruislip
    800
    Middlesex
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione7669797
    163247510001
    CONTINENTAL SHELF 548 LIMITED
    Field End Road
    HA4 0QH South Ruislip
    800
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Field End Road
    HA4 0QH South Ruislip
    800
    Middlesex
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione7669811
    163247580001
    BROWN, Scott
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    Segretario
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    Australian154943660001
    FAIERS, Colin Charles
    4 Elm Way
    Willingham
    CB4 5JS Cambridge
    Canbridgeshire
    Segretario
    4 Elm Way
    Willingham
    CB4 5JS Cambridge
    Canbridgeshire
    British157295550001
    FULTON, Ricahrd
    Arthur Street
    BT1 4GA Belfast
    21
    Antrim
    Segretario
    Arthur Street
    BT1 4GA Belfast
    21
    Antrim
    British154196160001
    HENWOOD, Julian Richard
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    Segretario
    8 Brickyard Close
    CV7 7EN Balsall Common
    Warwickshire
    British65188860002
    LAVENDER, Michael David
    Forty Hill House
    EN2 9EU Forty Hill
    Middlesex
    Segretario
    Forty Hill House
    EN2 9EU Forty Hill
    Middlesex
    British149181030001
    LEWIN, Peter Jonathan
    2 Cormont Road
    SE5 9RA London
    Segretario
    2 Cormont Road
    SE5 9RA London
    British45962560004
    MATTHEWS, Michael James
    11 Caxton Lane
    Foxton
    CB2 6SR Cambridge
    Cambridgeshire
    Segretario
    11 Caxton Lane
    Foxton
    CB2 6SR Cambridge
    Cambridgeshire
    British9389260001
    WATSON, Philip George
    29 Northcroft
    SG19 1JJ Sandy
    Bedfordshire
    Segretario
    29 Northcroft
    SG19 1JJ Sandy
    Bedfordshire
    British42944690001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    SARCON COMPLIANCE LIMITED
    Murray House
    Murray Street
    BT1 6DN Belfast
    Antrim
    Segretario
    Murray House
    Murray Street
    BT1 6DN Belfast
    Antrim
    143646650001
    BROWN, Scott Douglas
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    Amministratore
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    EnglandAustralian183542790001
    CLISSETT, Mark Anthony
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    Amministratore
    800 Field End Road
    South Ruislip
    HA4 0QH Middlesex
    United KingdomBritish159159010001
    EDDY, Jonathan Charles Grenville
    Heath House
    Queen Mary Close
    GU51 4QR Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    Heath House
    Queen Mary Close
    GU51 4QR Fleet
    Hampshire
    British72062400003
    FAIERS, Colin Charles
    4 Elm Way
    Willingham
    CB4 5JS Cambridge
    Canbridgeshire
    Amministratore
    4 Elm Way
    Willingham
    CB4 5JS Cambridge
    Canbridgeshire
    United KingdomBritish157295550001
    FLYNN, Raymond Francis
    66 Kiln Park
    BT39 0BB Templepatrick
    County Antrim
    Northern Ireland
    Amministratore
    66 Kiln Park
    BT39 0BB Templepatrick
    County Antrim
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish119131330001
    HOUSDEN, Malcolm Brian
    16 The Woodlands
    Broom
    SG18 9NH Biggleswade
    Bedfordshire
    Amministratore
    16 The Woodlands
    Broom
    SG18 9NH Biggleswade
    Bedfordshire
    British31969440001
    LEWIN, Peter Jonathan
    2 Cormont Road
    SE5 9RA London
    Amministratore
    2 Cormont Road
    SE5 9RA London
    United KingdomBritish45962560004
    MCDAID, Philip
    Field End Road
    HA4 0QH South Ruislip
    800
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    Field End Road
    HA4 0QH South Ruislip
    800
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomIrish161036530001
    MELLON, Denis
    19 Homewood Road
    AL1 4BG St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    19 Homewood Road
    AL1 4BG St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish105707560001
    OLIVE, Michael Pelham Morris, Mr.
    Church Farm House
    Lower Basildon
    RG8 9NH Pangbourne
    Berkshire
    Amministratore
    Church Farm House
    Lower Basildon
    RG8 9NH Pangbourne
    Berkshire
    EnglandBritish36404130004
    REILLY, Paul
    Sonning Mead
    Thames Street
    RG4 6UR Sonning
    Berkshire
    Amministratore
    Sonning Mead
    Thames Street
    RG4 6UR Sonning
    Berkshire
    United KingdomBritish67639350002
    SCOTT, George Douglas
    Hill Farm House
    Holywell
    PE27 4TG Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Hill Farm House
    Holywell
    PE27 4TG Huntingdon
    Cambridgeshire
    British76708940001
    SHANNON, Marcus John
    48 Loughanmore Road
    BT41 2HN Dunadry
    County Antrim
    N Ireland
    Amministratore
    48 Loughanmore Road
    BT41 2HN Dunadry
    County Antrim
    N Ireland
    United KingdomBritish108366960001
    SMITH, David Michael
    9 Crowdon Drive
    CV32 6NX Royal Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    9 Crowdon Drive
    CV32 6NX Royal Leamington Spa
    Warwickshire
    British119131400001
    WATSON, Philip George
    29 Northcroft
    SG19 1JJ Sandy
    Bedfordshire
    Amministratore
    29 Northcroft
    SG19 1JJ Sandy
    Bedfordshire
    British42944690001
    WESTBURY, Peter
    Somerset Hill
    Holmbury St Mary
    RH5 6NR Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Somerset Hill
    Holmbury St Mary
    RH5 6NR Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish2193910001
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 ott 2008
    Consegnato il 16 ott 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ott 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2013Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Mortgage debenture
    Creato il 05 ott 2005
    Consegnato il 12 ott 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from sarcon vehicles limited to the chargee
    Brevi particolari
    The property k/a unit 1 papworth business park papworth everard cambridge & units 3/5 papworth business park papworth everard cambridge. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transazioni
    • 12 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2013Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Mortgage deed
    Creato il 01 nov 2004
    Consegnato il 03 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 5, papworth business park, cambridge. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 01 nov 2004
    Consegnato il 03 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 3, papworth business park, cambridge. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 03 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 09 mar 2000
    Consegnato il 11 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property being unit 3,papworth business park,cambridge.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    All assets debenture
    Creato il 11 ago 1999
    Consegnato il 14 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 14 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 lug 1999
    Consegnato il 15 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mag 1995
    Consegnato il 13 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an acquisition agreement dated 10 may 1995 or this debenture
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Papworth Trust
    Transazioni
    • 13 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 01 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mag 1995
    Consegnato il 06 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PAPWORTH SPECIALIST VEHICLES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 giu 2013Data della petizione
    19 ago 2013Inizio della liquidazione
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or London
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London
    Praticante
    2nd Floor, 4 Abbey Orchard Street
    Westminster
    SW1P 2HT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0