GREYFRIARS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

GREYFRIARS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGREYFRIARS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03049693
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GREYFRIARS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    • Gestione immobiliare dei residenti (98000) / Attività delle famiglie come datori di lavoro; attività di produzione di beni e servizi non differenziate delle famiglie per uso proprio

    Dove si trova GREYFRIARS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Seacourt Tower
    West Way
    OX2 0FB Oxford
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di GREYFRIARS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per GREYFRIARS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Walter Jen Bang Cha come amministratore in data 30 apr 2017

    1 pagineTM01
    X861X8Z6

    Nomina di Mr Matthew Simon Clarke come amministratore in data 10 mag 2019

    2 pagineAP01
    X861X916

    Cessazione della carica di Niall Patrick Brook come amministratore in data 30 apr 2019

    1 pagineTM01
    X861X91F

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    5 pagineDS01
    A64ENMUO

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 25 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 apr 2016

    Stato del capitale al 28 apr 2016

    • Capitale: GBP 2
    SH01
    X55RV7QA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Niall Patrick Brook il 07 set 2015

    2 pagineCH01
    X4YUO5Y0

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2015

    4 pagineAA
    A4MDK9BD

    Bilancio annuale redatto al 25 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 apr 2015

    Stato del capitale al 27 apr 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01
    X468UW0X

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2014

    4 pagineAA
    A4236C4R

    Bilancio annuale redatto al 25 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 apr 2014

    Stato del capitale al 25 apr 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01
    X36JYI8Y

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2013

    4 pagineAA
    A2ZJNOOZ

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2012 al 31 mag 2013

    3 pagineAA01
    A2H7OECA

    Bilancio annuale redatto al 25 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    X270U2X5

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Niall Patrick Brook il 01 gen 2013

    2 pagineCH01
    X26DFFYY

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011

    4 pagineAA
    A1KMVKMQ

    Nomina di Mr Walter Jen Bang Cha come amministratore

    2 pagineAP01
    X1DDYACA

    Nomina di Mr Niall Patrick Brook come amministratore

    2 pagineAP01
    X1DDYACI

    Bilancio annuale redatto al 25 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    X17L64YI

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2010

    5 pagineAA
    A4P1PXZP

    Bilancio annuale redatto al 25 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    XFOKBTMA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA
    ATWOSNUW

    Chi sono gli amministratori di GREYFRIARS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LINNELLS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    West Way
    OX2 0FB Oxford
    Seacourt Tower
    United Kingdom
    Segretario
    West Way
    OX2 0FB Oxford
    Seacourt Tower
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione3440292
    56066410006
    CLARKE, Matthew Simon
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3LG Eastleigh
    New Kings Court
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3LG Eastleigh
    New Kings Court
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant258825080001
    MISCAMPBELL, Andrew Ian Farquharson
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3LG Eastleigh
    New Kings Court
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3LG Eastleigh
    New Kings Court
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor100182470002
    LLOYD JONES, Rodyon Owen
    Greyfriars Court
    Paradise Square
    OX1 1BB Oxford
    Oxfordshire
    Segretario
    Greyfriars Court
    Paradise Square
    OX1 1BB Oxford
    Oxfordshire
    BritishSolicitor64432570001
    MISCAMPBELL, Andrew Ian Farquharson
    6 Hillesden Way
    MK18 1UE Buckingham
    Buckinghamshire
    Segretario
    6 Hillesden Way
    MK18 1UE Buckingham
    Buckinghamshire
    BritishSolicitor100182470001
    STEEL, Anna Harriet Preston
    12 King Edward Street
    OX1 4HX Oxford
    Oxfordshire
    Segretario
    12 King Edward Street
    OX1 4HX Oxford
    Oxfordshire
    BritishSolicitor37561950001
    TEMPLE, Euan Malcolm Forbes
    13 Burton Place
    Cowley
    OX4 2RQ Oxford
    Oxfordshire
    Segretario
    13 Burton Place
    Cowley
    OX4 2RQ Oxford
    Oxfordshire
    BritishSecretary74506930001
    THORN-DAVIS, Scott Peter
    20 Haddenham Road
    Kingsey
    HP17 8LS Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    20 Haddenham Road
    Kingsey
    HP17 8LS Aylesbury
    Buckinghamshire
    British68718610001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    BROOK, Niall Patrick
    Cranbourne Drive
    Otterbourne
    SO21 2ES Winchester
    75
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Cranbourne Drive
    Otterbourne
    SO21 2ES Winchester
    75
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor170708850003
    CHA, Walter Jen Bang
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3LG Eastleigh
    New Kings Court
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Tollgate
    Chandler's Ford
    SO53 3LG Eastleigh
    New Kings Court
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishSolicitor63471720003
    DEECH, John Stewart, Dr
    8 Hids Copse Road
    Cumnor Hill
    OX2 9JJ Oxford
    Amministratore
    8 Hids Copse Road
    Cumnor Hill
    OX2 9JJ Oxford
    EnglandBritishSolicitor4342650001
    GREGAN, Charles Patrick Gabriel
    Chapel Barn
    Lyneham
    OX7 6QL Chipping Norton
    Oxfordshire
    Amministratore
    Chapel Barn
    Lyneham
    OX7 6QL Chipping Norton
    Oxfordshire
    BritishSolicitor44688200001
    TEMPLE, Euan Malcolm Forbes
    13 Burton Place
    Cowley
    OX4 2RQ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    13 Burton Place
    Cowley
    OX4 2RQ Oxford
    Oxfordshire
    BritishSolicitor74506930001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    LINNELLS NOMINEES LIMITED
    West Way
    OX2 0FB Oxford
    Seacourt Tower
    Oxon
    United Kingdom
    Amministratore
    West Way
    OX2 0FB Oxford
    Seacourt Tower
    Oxon
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3358443
    100892390001

    GREYFRIARS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of collateral charge
    Creato il 29 ott 1999
    Consegnato il 04 nov 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from richard higginson jane elizabeth smith philip francis louis pennock clive ronald monkley william bellamy and catriona milner to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a lyppard grange medical centre ankerage green warnfon worcester.
    Persone aventi diritto
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 04 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage deed
    Creato il 07 set 1998
    Consegnato il 25 set 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from peter ralph mailer and louise barbara mailer to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a or being hardwick dene, hardlane, buckden huntingdon cambridgeshire together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time thereon by way of assignment the goodwill of the business. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Third party legal charge
    Creato il 04 nov 1997
    Consegnato il 15 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from peverel court limited to the chargee
    Brevi particolari
    Peverel court portway road stone aylesbury bucks by way of fixed charge the plant machinery fixtures fittings the furniture furnishings equipment tools and other chattels the present and future goodwill of any business and the proceeds of any insurance or the assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of collateral charge
    Creato il 27 ago 1997
    Consegnato il 17 set 1997
    In corso
    Importo garantito
    £185,000 an all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the legal charge dated 29TH september 1995 to which it is supplemental
    Brevi particolari
    L/H property k/a houghton regis bedfordshire. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 17 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of collateral charge
    Creato il 11 dic 1996
    Consegnato il 14 dic 1996
    In corso
    Importo garantito
    £450,000 due from dorothy margaret keighley, james pangbourne edmunds & nicholas harry anfiligoff to the chargee under the terms of a deed of legal charge dated 18TH may 1994
    Brevi particolari
    L/H land and premises known as cofton court medical centre longbridge lane longbridge.
    Persone aventi diritto
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 14 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 26 nov 1996
    Consegnato il 11 dic 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or peter ralph mailer and louise barbara mailer to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a the extension hardwick dene hardwick lane buckden cambridgeshire and goodwill of the business and benefit of licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Birmingham Midshires Building Society
    Transazioni
    • 11 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge by the company and by jeremy robert lucas henry stuart thackrah and david frederic appleyard as principal debtor
    Creato il 18 nov 1996
    Consegnato il 27 nov 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies now due or to become due from jeremy robert lucas and henry stuart thackrah and david frederic appleyard as principal debtor only to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The pre-preparatory department holmwood house chitts hill lexden colchester essex.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge by the company and jeremy robert lucas henry stuart thackrah and david frederic appleyard as principal debtor
    Creato il 18 nov 1996
    Consegnato il 27 nov 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies now due or to become due from jeremy robert lucas and henry stuart thackrah and david frederic appleyard as principal debtor only to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The arts and changing room block holmwood house chitts hill lexden colchester essex. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 19 apr 1996
    Consegnato il 27 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal mortgage l/h property k/a or being southwell private day nursery allenby road southwell nottinghamshire including the entirety of the property comprised in together with all buildings and fixtures thereon the goodwill of the company's business at the premises. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 27 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ott 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0