GREYFRIARS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
Panoramica
Nome della società | GREYFRIARS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03049693 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GREYFRIARS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
- Gestione immobiliare dei residenti (98000) / Attività delle famiglie come datori di lavoro; attività di produzione di beni e servizi non differenziate delle famiglie per uso proprio
Dove si trova GREYFRIARS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Seacourt Tower West Way OX2 0FB Oxford |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di GREYFRIARS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mag 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per GREYFRIARS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di Walter Jen Bang Cha come amministratore in data 30 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Matthew Simon Clarke come amministratore in data 10 mag 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Niall Patrick Brook come amministratore in data 30 apr 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 5 pagine | DS01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Niall Patrick Brook il 07 set 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 apr 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 apr 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mag 2013 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2012 al 31 mag 2013 | 3 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 apr 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Niall Patrick Brook il 01 gen 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2011 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Walter Jen Bang Cha come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Niall Patrick Brook come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 apr 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2010 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 apr 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2009 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GREYFRIARS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINNELLS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | West Way OX2 0FB Oxford Seacourt Tower United Kingdom |
| 56066410006 | ||||||||||
CLARKE, Matthew Simon | Amministratore | Tollgate Chandler's Ford SO53 3LG Eastleigh New Kings Court Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 258825080001 | ||||||||
MISCAMPBELL, Andrew Ian Farquharson | Amministratore | Tollgate Chandler's Ford SO53 3LG Eastleigh New Kings Court Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 100182470002 | ||||||||
LLOYD JONES, Rodyon Owen | Segretario | Greyfriars Court Paradise Square OX1 1BB Oxford Oxfordshire | British | Solicitor | 64432570001 | |||||||||
MISCAMPBELL, Andrew Ian Farquharson | Segretario | 6 Hillesden Way MK18 1UE Buckingham Buckinghamshire | British | Solicitor | 100182470001 | |||||||||
STEEL, Anna Harriet Preston | Segretario | 12 King Edward Street OX1 4HX Oxford Oxfordshire | British | Solicitor | 37561950001 | |||||||||
TEMPLE, Euan Malcolm Forbes | Segretario | 13 Burton Place Cowley OX4 2RQ Oxford Oxfordshire | British | Secretary | 74506930001 | |||||||||
THORN-DAVIS, Scott Peter | Segretario | 20 Haddenham Road Kingsey HP17 8LS Aylesbury Buckinghamshire | British | 68718610001 | ||||||||||
COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||||||
BROOK, Niall Patrick | Amministratore | Cranbourne Drive Otterbourne SO21 2ES Winchester 75 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 170708850003 | ||||||||
CHA, Walter Jen Bang | Amministratore | Tollgate Chandler's Ford SO53 3LG Eastleigh New Kings Court Hampshire United Kingdom | England | British | Solicitor | 63471720003 | ||||||||
DEECH, John Stewart, Dr | Amministratore | 8 Hids Copse Road Cumnor Hill OX2 9JJ Oxford | England | British | Solicitor | 4342650001 | ||||||||
GREGAN, Charles Patrick Gabriel | Amministratore | Chapel Barn Lyneham OX7 6QL Chipping Norton Oxfordshire | British | Solicitor | 44688200001 | |||||||||
TEMPLE, Euan Malcolm Forbes | Amministratore | 13 Burton Place Cowley OX4 2RQ Oxford Oxfordshire | British | Solicitor | 74506930001 | |||||||||
COMBINED NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||||||
COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||||||
LINNELLS NOMINEES LIMITED | Amministratore | West Way OX2 0FB Oxford Seacourt Tower Oxon United Kingdom |
| 100892390001 |
GREYFRIARS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Deed of collateral charge | Creato il 29 ott 1999 Consegnato il 04 nov 1999 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from richard higginson jane elizabeth smith philip francis louis pennock clive ronald monkley william bellamy and catriona milner to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari L/H property k/a lyppard grange medical centre ankerage green warnfon worcester. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage deed | Creato il 07 set 1998 Consegnato il 25 set 1998 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from peter ralph mailer and louise barbara mailer to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property k/a or being hardwick dene, hardlane, buckden huntingdon cambridgeshire together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery from time to time thereon by way of assignment the goodwill of the business. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Third party legal charge | Creato il 04 nov 1997 Consegnato il 15 nov 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from peverel court limited to the chargee | |
Brevi particolari Peverel court portway road stone aylesbury bucks by way of fixed charge the plant machinery fixtures fittings the furniture furnishings equipment tools and other chattels the present and future goodwill of any business and the proceeds of any insurance or the assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of collateral charge | Creato il 27 ago 1997 Consegnato il 17 set 1997 | In corso | Importo garantito £185,000 an all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the legal charge dated 29TH september 1995 to which it is supplemental | |
Brevi particolari L/H property k/a houghton regis bedfordshire. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of collateral charge | Creato il 11 dic 1996 Consegnato il 14 dic 1996 | In corso | Importo garantito £450,000 due from dorothy margaret keighley, james pangbourne edmunds & nicholas harry anfiligoff to the chargee under the terms of a deed of legal charge dated 18TH may 1994 | |
Brevi particolari L/H land and premises known as cofton court medical centre longbridge lane longbridge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 26 nov 1996 Consegnato il 11 dic 1996 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or peter ralph mailer and louise barbara mailer to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property k/a the extension hardwick dene hardwick lane buckden cambridgeshire and goodwill of the business and benefit of licences. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge by the company and by jeremy robert lucas henry stuart thackrah and david frederic appleyard as principal debtor | Creato il 18 nov 1996 Consegnato il 27 nov 1996 | In corso | Importo garantito All monies now due or to become due from jeremy robert lucas and henry stuart thackrah and david frederic appleyard as principal debtor only to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The pre-preparatory department holmwood house chitts hill lexden colchester essex. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge by the company and jeremy robert lucas henry stuart thackrah and david frederic appleyard as principal debtor | Creato il 18 nov 1996 Consegnato il 27 nov 1996 | In corso | Importo garantito All monies now due or to become due from jeremy robert lucas and henry stuart thackrah and david frederic appleyard as principal debtor only to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The arts and changing room block holmwood house chitts hill lexden colchester essex. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 19 apr 1996 Consegnato il 27 apr 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Legal mortgage l/h property k/a or being southwell private day nursery allenby road southwell nottinghamshire including the entirety of the property comprised in together with all buildings and fixtures thereon the goodwill of the company's business at the premises. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0