ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED

ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03050677
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED?

    • Attività di produzione di programmi televisivi (59113) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Media House Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GLOBAL RADIO EAST MIDLANDS LIMITED15 ago 200715 ago 2007
    CHRYSALIS RADIO EAST MIDLANDS LIMITED23 mag 200523 mag 2005
    CENTURY RADIO 106 LIMITED21 apr 199821 apr 1998
    RADIO 106 FM LIMITED03 set 199703 set 1997
    EAST MIDLANDS BROADCASTING COMPANY LIMITED04 lug 199504 lug 1995
    LATLEES LIMITED27 apr 199527 apr 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2019

    13 pagineAA

    legacy

    38 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 apr 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 03 dic 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 apr 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 10 dic 2018

    • Capitale: GBP 1,000.00
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Anthony Keenan il 25 set 2018

    2 pagineCH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAUER GROUP SECRETARIAT LIMITED
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Segretario
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione00944753
    159023720001
    FORD, Deidre Ann
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    United KingdomBritish109666380002
    KEENAN, Paul Anthony
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritish243390510001
    VICKERY, Sarah Jane
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritish119137220004
    BROWNLOW, Peter
    Quarry Bank Capon Hill
    CA8 1QN Brampton
    Cumbria
    Segretario
    Quarry Bank Capon Hill
    CA8 1QN Brampton
    Cumbria
    British4459070001
    CUSICK, Nicholas Jonathan Paul
    30 Longlands Road
    CA3 9AD Carlisle
    Segretario
    30 Longlands Road
    CA3 9AD Carlisle
    British50942120001
    EVANS, Mark Roy
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    British54693600002
    FITZJOHN, Julie
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    Segretario
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    British92875290001
    FLUET, Cliff
    11 Rokesly Avenue
    N8 8NS London
    Segretario
    11 Rokesly Avenue
    N8 8NS London
    British97684290001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    Segretario
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    British39878290001
    MCGARTOLL, Owen Raphael
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Segretario
    58 The Anchorage,
    Clarence Street
    IRISH Dun Laoghaire
    County Dublin
    Ireland
    Irish116537370001
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Segretario
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    POTTERELL, Clive Ronald
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    Segretario
    Magnolia Cottage 10 Newlands Avenue
    KT7 0HF Thames Ditton
    Surrey
    British3182530002
    SCHWARZ, Nathalie Esther
    Flat 10
    28 Belsize Avenue
    NW3 4AU London
    Segretario
    Flat 10
    28 Belsize Avenue
    NW3 4AU London
    British59245010001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    BAXTER, Travis
    Le Morpeth Terrace
    SW1P 1EW London
    Amministratore
    Le Morpeth Terrace
    SW1P 1EW London
    British26244380001
    BEESLEY, Thomas Andrew
    Field House
    Owthorpe Lane
    NG12 3EH Kinoulton
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Field House
    Owthorpe Lane
    NG12 3EH Kinoulton
    Nottinghamshire
    EnglandBritish41597780001
    BOWLER, Timothy Richard
    39a Burlington Road
    Sherwood
    NG5 2GR Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    39a Burlington Road
    Sherwood
    NG5 2GR Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish14072490001
    BROWNLOW, Peter
    Quarry Bank Capon Hill
    CA8 1QN Brampton
    Cumbria
    Amministratore
    Quarry Bank Capon Hill
    CA8 1QN Brampton
    Cumbria
    British4459070001
    BUCCI, Joanne
    Lodge House
    Lodge Lane
    NG13 8JN Screveton
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Lodge House
    Lodge Lane
    NG13 8JN Screveton
    Nottinghamshire
    EnglandBritish83777300001
    CANTLE, Edward Francis
    Parkside
    Wollaton
    NG8 2NP Nottingham
    112
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Parkside
    Wollaton
    NG8 2NP Nottingham
    112
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish124162790002
    COLES, Ronald John
    Manor Farm Main Street
    Upton
    NG23 5ST Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Manor Farm Main Street
    Upton
    NG23 5ST Newark
    Nottinghamshire
    British9159370001
    CONNOLE, Michael Damien
    117 Thornbury Road
    TW7 4ND Isleworth
    Middlesex
    Amministratore
    117 Thornbury Road
    TW7 4ND Isleworth
    Middlesex
    EnglandIrish47934750001
    DAVIDSON, Nicholas
    97 Pen Y Dre
    Rhiwbina
    CF14 6EL Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    97 Pen Y Dre
    Rhiwbina
    CF14 6EL Cardiff
    South Glamorgan
    British71050910001
    DAVIES, Paul Richard
    28 Roehampton Gate
    Roehampton
    SW15 5JS London
    Amministratore
    28 Roehampton Gate
    Roehampton
    SW15 5JS London
    British55332120002
    DOBSON, Maureen
    The Cottage
    Cottage Lane South Collingham
    NG23 7LJ Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Cottage
    Cottage Lane South Collingham
    NG23 7LJ Newark
    Nottinghamshire
    British27695370001
    EVANS, Mark Roy
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    Amministratore
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    EnglandBritish54693600002
    EVANS, Mark Roy
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    17 Carless Avenue
    B17 9BN Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish54693600002
    FAIR, Julie
    716 Kenilworth Road
    Balsall Common
    CV7 7HD Coventry
    West Midlands
    Amministratore
    716 Kenilworth Road
    Balsall Common
    CV7 7HD Coventry
    West Midlands
    EnglandBritish99687470001
    FAIRBURN, Paul Martin
    9 Tansley Gardens
    Dorridge
    B93 8UB Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    9 Tansley Gardens
    Dorridge
    B93 8UB Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish43039880003
    FIELDING, Samantha
    6 Periwood Grove
    Millhouses
    S8 0HX Sheffield
    Amministratore
    6 Periwood Grove
    Millhouses
    S8 0HX Sheffield
    British78849480001
    FITZJOHN, Julie
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    Amministratore
    Basement Flat
    78 Elgin Avenue
    W9 2HB London
    United KingdomBritish92875290001
    HARRIS, Peter Jonathan
    381 Wimbledon Park Road
    SW19 6PE London
    Amministratore
    381 Wimbledon Park Road
    SW19 6PE London
    EnglandBritish40917640001
    HIGGINS, Lisa
    86 Thornfield Road
    Linthorpe
    TS5 5BY Middlesbrough
    Cleveland
    Amministratore
    86 Thornfield Road
    Linthorpe
    TS5 5BY Middlesbrough
    Cleveland
    British87568370001
    HURSTHOUSE, Roger Stephen
    3 Elm Park
    Gonalston Lane Epperstone
    NG14 6BE Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    3 Elm Park
    Gonalston Lane Epperstone
    NG14 6BE Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish18715750002

    Chi sono le persone con controllo significativo di ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    06 apr 2016
    Peterborough Business Park
    Lynch Wood
    PE2 6EA Peterborough
    Media House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom (England)
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06898191
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ORION MEDIA (EAST MIDLANDS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 20 mag 2011
    Consegnato il 27 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the note issuer and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Price
    Transazioni
    • 27 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 05 mag 2010
    Consegnato il 20 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from orion media limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Matthew Paul Ramsbottom
    Transazioni
    • 20 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 29 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 05 mag 2010
    Consegnato il 20 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from orion media limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Robert John Norman
    Transazioni
    • 20 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 05 mag 2010
    Consegnato il 18 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the note issuer to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Geoffrey Percy
    Transazioni
    • 18 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 05 mag 2010
    Consegnato il 13 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from orion media holdings limited and any charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Global Radio Group Limited
    Transazioni
    • 13 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 31 lug 2009
    Consegnato il 06 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 31 lug 2009
    Consegnato il 06 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Philip Riley
    Transazioni
    • 06 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 31 lug 2009
    Consegnato il 06 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Antony Thomas Lloyd
    Transazioni
    • 06 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 lug 2009
    Consegnato il 05 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All land vested in or charged to the chargor, all fixtures and fittings attached to the land and all rents, all plant & machinery, contacts goodwill uncalled capital stocks shares patents copyrights and all other intellectual property rights. A floating charge over all the other property assets and rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An accession deed
    Creato il 02 lug 2008
    Consegnato il 09 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent for and on Behalf of the Secured Parties
    Transazioni
    • 09 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An accession deed
    Creato il 31 lug 2007
    Consegnato il 03 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All investments all plant and machinery the insurances all debts the goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Agent
    Transazioni
    • 03 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Consideration letter between the company and the governor and company of the bank of scotland (in its capacity as security trustee for and on behalf of the security beneficiaries ("the security trustee")
    Creato il 21 feb 2001
    Consegnato il 08 mar 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys as at 21 april 2000 or at any time thereafter owing to the security trustee and security beneficiaries by the principal debtors or any of them (where any company is also a principal debtor, the liability of such company to the security beneficiaries under the deed shall only have effect in relation to all the other principal debtors) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 mar 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 31 mar 1999
    Consegnato il 09 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 feb 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0