CIM MANAGEMENT 2 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | CIM MANAGEMENT 2 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03050683 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CIM MANAGEMENT 2 LIMITED?
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova CIM MANAGEMENT 2 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Whittington Hall Whittington Road, Whittington WR5 2ZX Worcester Worcestershire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CIM MANAGEMENT 2 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CIM MANAGEMENT LIMITED | 17 apr 2009 | 17 apr 2009 |
| CIM MANAGEMENT 2 LIMITED | 11 giu 2008 | 11 giu 2008 |
| CIM MANAGEMENT LIMITED | 28 set 1995 | 28 set 1995 |
| MOONSTRUCK LIMITED | 27 apr 1995 | 27 apr 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CIM MANAGEMENT 2 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per CIM MANAGEMENT 2 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 08 ago 2023
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 apr 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2021 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 apr 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2020 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 apr 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di David Charles Annetts come amministratore in data 01 lug 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 apr 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2018 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 apr 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Duncan James Moore come amministratore in data 31 mar 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Mark Andrew Reynolds il 09 nov 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2017 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 apr 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 apr 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 27 apr 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di CIM MANAGEMENT 2 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEMBERSTONE (SECRETARIES) LIMITED | Segretario | Whittington Road WR5 2ZX Worcester Whittington Hall Worcestershire United Kingdom |
| 77906620001 | ||||||||||
| BARKER, Andrew Martin | Amministratore | Whittington Road WR5 2ZX Worcester Whittington Hall Worcestershire | United Kingdom | British | 149813130009 | |||||||||
| MOORE, Duncan James | Amministratore | Whittington Hall Whittington Road, Whittington WR5 2ZX Worcester Worcestershire | England | British | 78671940006 | |||||||||
| REYNOLDS, Mark Andrew | Amministratore | Whittington Road WR5 2ZX Worcester Whittington Hall Worcestershire | United Kingdom | British | 41446640003 | |||||||||
| ANNETTS, David Charles | Segretario | The Snead Pensax WR6 6AG Abberley Worcestershire | British | 81373880001 | ||||||||||
| MURPHY, Michael Joseph | Segretario | 6 Barwick Road Up Hatherley GL51 5UY Cheltenham Gloucestershire | British | 31259900001 | ||||||||||
| ROGERS, Helen Frances Leigh | Segretario | 6 Severn Way GL19 4DA Apperley Gloucestershire | British | 73814460001 | ||||||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 | |||||||||||
| ANNETTS, David Charles | Amministratore | Whittington Road WR5 2ZX Worcester Whittington Hall Worcestershire | United Kingdom | British | 81373880001 | |||||||||
| ANNETTS, David Charles | Amministratore | The Snead Pensax WR6 6AG Abberley Worcestershire | United Kingdom | British | 81373880001 | |||||||||
| BARKER, Andrew Martin | Amministratore | Upper Birch Farm Shatterford DY12 1TR Bewdley Worcestershire | British | 54622310001 | ||||||||||
| BRUCKLAND, Andrew John | Amministratore | 18 Eldorado Road GL50 2PT Cheltenham Gloucestershire | England | British | 22103780002 | |||||||||
| UNDERHILL, Peter John | Amministratore | Maes Court Knighton On Teme WR15 8LY Tenbury Wells Worcestershire | British | 17203000001 | ||||||||||
| PEMBERSTONE (DIRECTORS) LIMITED | Amministratore | Whittington Road WR5 2ZX Worcester Whittington Hall Worcestershire United Kingdom |
| 82038280001 | ||||||||||
| PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED | Amministratore delegato nominato | 1 Park Row LS1 5AB Leeds | 900005000001 | |||||||||||
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Amministratore | 1 Park Row LS1 5AB Leeds West Yorkshire | 76579530001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CIM MANAGEMENT 2 LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pgl (201) Limited | 06 apr 2016 | Whittington Road WR5 2ZX Worcester Whittington Hall England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
CIM MANAGEMENT 2 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 03 giu 1999 Consegnato il 21 giu 1999 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the loan agreement dated 24 february 1999 | |
Brevi particolari The property known as rutherford house blackploe road worcester title number HW155958. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 03 giu 1999 Consegnato il 21 giu 1999 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the loan agreement dated 24 february 1999 | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 03 giu 1999 Consegnato il 11 giu 1999 | In corso | Importo garantito All moneys obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of any of the finance documents and/or in connection with the loan facility or other financial accommodation | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 18 mag 1998 Consegnato il 28 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h property k/a rutherford house blackpole road worcester.t/no.HW155958.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 23 feb 1996 Consegnato il 05 mar 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0