MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED

MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03059563
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED?

    • (9220) /

    Dove si trova MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    13 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 feb 2017

    14 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 feb 2016

    16 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 feb 2015

    20 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 27 feb 2014

    10 pagine4.68

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    2.34B

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:replacement of liquidator ;- s m rayment replaces a h beckingham 15/11/2013
    14 pagineLIQ MISC OC

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Cessazione della carica di Emmanuelle Namiech come amministratore

    1 pagineTM01

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    15 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 27 ago 2012

    15 pagine2.24B

    Cessazione della carica di Alison Rayson come amministratore

    2 pagineTM01

    Risultato della riunione dei creditori

    4 pagine2.23B

    Risultato della riunione dei creditori

    4 pagine2.23B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    92 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    14 pagine2.16B

    Dettagli del direttore cambiati per Alison Dawn Rayson il 21 ott 2011

    2 pagineCH01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Indirizzo della sede legale modificato da * 2Nd Floor Garfield House 86-88 Edgware Road London W2 2EA* in data 05 mar 2012

    2 pagineAD01

    legacy

    8 pagineMG01

    Nomina di Mrs Emmanuelle Namiech come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    20 pagineAA

    Nomina di Mr Mark Andrew Webster come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Miss Deborah Margaret Brown come segretario

    1 pagineAP03

    Chi sono gli amministratori di MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROWN, Deborah Margaret
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Segretario
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    162200060001
    WEBSTER, Mark Andrew
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritishDirector165027120001
    BURNS, Clive
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    Segretario
    The Cottage
    Lamer Hill Gate Lower Gustard Wood
    AL4 8RX Wheathampstead
    Hertfordshire
    British71073800001
    FERMAN, David Leonard Paul
    4 Church Farm Close
    Hoo
    ME3 9AY Rochester
    Kent
    Segretario
    4 Church Farm Close
    Hoo
    ME3 9AY Rochester
    Kent
    British35553740001
    GIBBONS, Nigel
    Ockford Wood Farm
    New Way
    GU7 2QL Godalming
    Surrey
    Segretario
    Ockford Wood Farm
    New Way
    GU7 2QL Godalming
    Surrey
    BritishAccountant39895440002
    KIRBY, Robert Henry
    Shortlands Road
    KT2 6HD Kingston-Upon-Thames
    36
    Surrey
    Segretario
    Shortlands Road
    KT2 6HD Kingston-Upon-Thames
    36
    Surrey
    British131528280001
    ROBERTS, Jeremy Charles
    14 Perryn House
    Bromyard Avenue
    W3 7JD London
    Segretario
    14 Perryn House
    Bromyard Avenue
    W3 7JD London
    BritishIn House Lawyer86671080001
    TAYLOR, Richard George
    72 Hall Green Lane
    Hutton
    CM13 2QT Brentwood
    Essex
    Segretario
    72 Hall Green Lane
    Hutton
    CM13 2QT Brentwood
    Essex
    British47989960001
    THOM, Alastair Stephen
    13 The Meadway
    IG9 5PG Buckhurst Hill
    Essex
    Segretario
    13 The Meadway
    IG9 5PG Buckhurst Hill
    Essex
    BritishExecutive Director9591260001
    CHETTLEBURGH INTERNATIONAL LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Segretario nominato
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000860001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Segretario
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    BURDICK, Charles James
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    Amministratore
    9 Ormonde Place
    SW1W 8HX London
    British-AmericanGroup Finance Director52311710004
    COOK, Stephen Sands
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    Amministratore
    24a Redcliffe Square
    SW10 9JY London
    BritishSolicitor73000530008
    GIBBONS, Nigel
    Ockford Wood Farm
    New Way
    GU7 2QL Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Ockford Wood Farm
    New Way
    GU7 2QL Godalming
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant39895440002
    HARMAN, Phillip Brent
    1 Cartwright Way
    Barnes
    SW13 8HD London
    Amministratore
    1 Cartwright Way
    Barnes
    SW13 8HD London
    New ZealanderCompany Manager51102310001
    LIGHTING, Jane Elizabeth Stuart
    Flat 1 2 Holford Road
    Hampstead
    NW3 1AD London
    Amministratore
    Flat 1 2 Holford Road
    Hampstead
    NW3 1AD London
    United KingdomBritishDirector49969850002
    LUIZ, Mark Walter
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    Amministratore
    165 Cranley Gardens
    N10 3AE London
    BritishAccountant37860010002
    NAMIECH, Emmanuelle
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    UkFrenchDirector165108170001
    OPIE, Lisa Moreen
    6 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 Millfield
    HP4 2PB Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritishTelevision Executive88563310001
    RAYSON, Alison Dawn
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritishManaging Director139392710003
    SMITH, Neil Reynolds
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    Amministratore
    Brettwood
    Green Lane Churt
    GU10 2PA Farnham
    Surrey
    BritishFinance Director79956240002
    STENHAM, Anthony William Paul
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    Amministratore
    4 The Grove
    Highgate
    N6 6JU London
    BritishDirector8281170001
    WALL, Malcolm Robert
    The Close
    2 Longfield Drive East Sheen
    SW14 7AU London
    Amministratore
    The Close
    2 Longfield Drive East Sheen
    SW14 7AU London
    EnglandBritishDirector178772080002
    WHEBLE, Anthony
    Oakway House
    5 Birchwood Road
    BR5 1NX Orpington
    Kent
    Amministratore
    Oakway House
    5 Birchwood Road
    BR5 1NX Orpington
    Kent
    BritishDirector67960870002
    CHETTLEBURGH'S LIMITED
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    Amministratore delegato nominato
    Temple House
    20 Holywell Row
    EC2A 4JB London
    900000850001
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Amministratore
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Amministratore
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 01 feb 2012
    Consegnato il 03 feb 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Metrodome Group PLC
    Transazioni
    • 03 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 24 gen 2011
    Consegnato il 28 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 28 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 19 feb 2008
    Consegnato il 27 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite debenture
    Creato il 03 mar 2006
    Consegnato il 10 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 10 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 10 mag 2005
    Consegnato il 18 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the chargors to the beneficiaries (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 18 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 02 mar 2000
    Consegnato il 16 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the beneficiaries (as defined) (in this capacity the "security trustee") under or pursuant to the transaction documents (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All stocks shares and securities of any kind whatsoever whether marketable or otherwise. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Toronto-Dominion Bank
    Transazioni
    • 16 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 giu 1995
    Consegnato il 26 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MINOTAUR INTERNATIONAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    28 feb 2012Inizio dell'amministrazione
    28 feb 2013Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Howard Beckingham
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Shay Bannon
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    2
    DataTipo
    28 feb 2013Inizio della liquidazione
    14 mag 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Howard Beckingham
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    James Joseph Bannon
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Sarah Megan Rayment
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0