VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED

VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVFS (SOUTHAMPTON) LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03059947
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    • fabbricazione di carrozzerie per veicoli a motore (eccetto roulotte) (29201) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Unit 8 Chickenhall Lane
    SO50 6RR Eastleigh
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VICTORIA FORGE (SOUTHAMPTON) LIMITED23 mag 199523 mag 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al23 mag 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma06 giu 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al23 mag 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Bilancio redatto al 31 dic 2023

    35 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 030599470013, creata il 25 giu 2024

    10 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Elaine Louise Maskelyne come amministratore in data 13 feb 2024

    1 pagineTM01

    Nomina di Emilio Jose Lopez Cantarero come amministratore in data 09 feb 2024

    2 pagineAP01

    Nomina di Gianfranco Natali come amministratore in data 09 feb 2024

    2 pagineAP01

    Nomina di Inigo Cano Arbaiza come amministratore in data 09 feb 2024

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2022

    29 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    30 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Faist Limited come persona con controllo significativo il 30 apr 2016

    2 paginePSC05

    Modifica dei dettagli di Mr Ashley Nicholas Morris come persona con controllo significativo il 01 ago 2019

    2 paginePSC04

    Notifica di Faist Limited come persona con controllo significativo il 30 apr 2016

    2 paginePSC02

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    29 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di John Hanlon come amministratore in data 03 dic 2020

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    28 pagineAA

    Nomina di Ms Xueqiong Yu come amministratore in data 01 ago 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Jason Jay Farrenden come amministratore in data 01 ago 2020

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Elaine Louise Maskelyne il 27 lug 2020

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Paula Denise Morton come segretario in data 12 dic 2019

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor North Dukes Court, 32 Duke Street St James's London SW1Y 6DF a Unit 8 Chickenhall Lane Eastleigh SO50 6RR in data 13 set 2019

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CANO ARBAIZA, Inigo
    Via Del Lavoro
    37067 Valeggio Sul Mincio (Vr)
    8
    Italy
    Amministratore
    Via Del Lavoro
    37067 Valeggio Sul Mincio (Vr)
    8
    Italy
    ItalySpanishCfo319912680001
    FARRENDEN, Jason Jay
    Chickenhall Lane
    SO50 6RR Eastleigh
    Unit 8
    England
    Amministratore
    Chickenhall Lane
    SO50 6RR Eastleigh
    Unit 8
    England
    EnglandBritishProduction And Operations Director273104540001
    LOPEZ CANTARERO, Emilio Jose
    Via Del Lavoro
    37067 Valeggio Sul Mincio (Vr)
    8
    Italy
    Amministratore
    Via Del Lavoro
    37067 Valeggio Sul Mincio (Vr)
    8
    Italy
    ItalySpanishCeo319913570001
    MORRIS, Ashley Nicholas
    Chickenhall Lane
    SO50 6RR Eastleigh
    Unit 8
    England
    Amministratore
    Chickenhall Lane
    SO50 6RR Eastleigh
    Unit 8
    England
    EnglandBritishSales Director206743740001
    NATALI, Gianfranco
    74 Boulevard Ditalie
    98000
    Monte-Carlo Sun Tour
    Monaco
    Amministratore
    74 Boulevard Ditalie
    98000
    Monte-Carlo Sun Tour
    Monaco
    MonacoItalianCeo319913060001
    YU, Xueqiong
    Chickenhall Lane
    SO50 6RR Eastleigh
    Unit 8
    England
    Amministratore
    Chickenhall Lane
    SO50 6RR Eastleigh
    Unit 8
    England
    ItalyChineseGroup Purchasing & Productivity Coordinator273984600001
    HURLSTONE, John Stephen
    Heatherlea Skipton Road
    Foulridge
    BB8 7PY Colne
    Lancashire
    Segretario
    Heatherlea Skipton Road
    Foulridge
    BB8 7PY Colne
    Lancashire
    BritishAccounts Manager42723460001
    MOORE, Judith
    The Old Stables
    Newtown
    RG20 9AP Newbury
    The Flat
    Berkshire
    England
    Segretario
    The Old Stables
    Newtown
    RG20 9AP Newbury
    The Flat
    Berkshire
    England
    BritishCompany Director130377720003
    MOORE, Judith Ann
    8 Carrisbroke Close
    SO21 9PQ New Alresford
    Hants
    Segretario
    8 Carrisbroke Close
    SO21 9PQ New Alresford
    Hants
    BritishProduction Director65729150004
    MORTON, Paula Denise
    Barton Park, Chickenhall Lane
    SO50 6RR Eastleigh
    Unit 8 Barton Park Ind Estate
    England
    Segretario
    Barton Park, Chickenhall Lane
    SO50 6RR Eastleigh
    Unit 8 Barton Park Ind Estate
    England
    237457880001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BARKER, Frank Neil
    26 Station Road
    Foulridge
    BB8 7LB Colne
    Lancashire
    Amministratore
    26 Station Road
    Foulridge
    BB8 7LB Colne
    Lancashire
    BritishQuality Controller54343100001
    BOOKER, Keith
    Cairnmount House
    TD5 8NN Kelso
    Roxburghshire
    Amministratore
    Cairnmount House
    TD5 8NN Kelso
    Roxburghshire
    United KingdomBritishEngineer21902620003
    BOOKER, Keith
    9 Coates Lane
    Barnoldswick
    BB8 6HJ Colne
    Lancashire
    Amministratore
    9 Coates Lane
    Barnoldswick
    BB8 6HJ Colne
    Lancashire
    BritishElectrical Engineer21902620001
    BURY, Allen
    16 Sheringham Avenue
    FY5 3AD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    Amministratore
    16 Sheringham Avenue
    FY5 3AD Thornton Cleveleys
    Lancashire
    EnglandBritishEngineer60792960001
    HANLON, John
    29 Hazel Grove
    Locks Heath
    SO31 6SH Southampton
    Amministratore
    29 Hazel Grove
    Locks Heath
    SO31 6SH Southampton
    United KingdomBritishEngineer58909150002
    HURLSTONE, John Stephen
    Heatherlea Skipton Road
    Foulridge
    BB8 7PY Colne
    Lancashire
    Amministratore
    Heatherlea Skipton Road
    Foulridge
    BB8 7PY Colne
    Lancashire
    BritishAccounts Manager42723460001
    HURLSTONE, Nigel Peter
    28 Skipton Old Road
    BB8 7QA Colne
    Lancashire
    Amministratore
    28 Skipton Old Road
    BB8 7QA Colne
    Lancashire
    BritishEngineer30202100002
    JOPLING, David Nicholas
    5 Channel Way
    Ocean Village
    SO14 3TG Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    5 Channel Way
    Ocean Village
    SO14 3TG Southampton
    Hampshire
    EnglandBritishManaging Director77010350002
    MASKELYNE, Elaine Louise
    Chickenhall Lane
    SO50 6RR Eastleigh
    Unit 8 Barton Park Industrial Estate
    England
    Amministratore
    Chickenhall Lane
    SO50 6RR Eastleigh
    Unit 8 Barton Park Industrial Estate
    England
    EnglandBritishCertified Chartered Accountant236538380002
    MAYR, Maurizio Eenesto
    Cap 05100 Terni
    Via Magenta 13
    Terni
    Cap 05100 Terni
    Rome
    Italy
    Amministratore
    Cap 05100 Terni
    Via Magenta 13
    Terni
    Cap 05100 Terni
    Rome
    Italy
    ItalyGermanCompany Director221127200001
    MAYR, Maurizio
    77
    Terni 05100
    Italy
    Via G. Di Vittorio
    Amministratore
    77
    Terni 05100
    Italy
    Via G. Di Vittorio
    ItalyItalianBoard Director58669800001
    MOORE, Judith Ann
    Robins Court
    SO24 9NZ Alresford
    8 Robins Court
    England
    Amministratore
    Robins Court
    SO24 9NZ Alresford
    8 Robins Court
    England
    United KingdomBritishDirector130377720007
    MOORE, Judith
    The Paddock
    Itchen Abbas
    SO21 1FJ Winchester
    2
    Hants
    Amministratore
    The Paddock
    Itchen Abbas
    SO21 1FJ Winchester
    2
    Hants
    United KingdomBritishCompany Director130377720003
    MOORE, Judith Ann
    8 Carrisbroke Close
    SO21 9PQ New Alresford
    Hants
    Amministratore
    8 Carrisbroke Close
    SO21 9PQ New Alresford
    Hants
    BritishProduction Director65729150004
    WARD, Stephen David
    22 Euxton Lane
    PR7 1PS Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    22 Euxton Lane
    PR7 1PS Chorley
    Lancashire
    BritishSales Director39297380002
    WHITTAKER, Barry
    12 Old College Road
    RG14 1TB Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    12 Old College Road
    RG14 1TB Newbury
    Berkshire
    BritishQuality67521220002
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Chi sono le persone con controllo significativo di VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Ashley Nicholas Morris
    Chickenhall Lane
    SO50 6RR Eastleigh
    Unit 8 Barton Park Industrial Estate
    England
    01 ago 2019
    Chickenhall Lane
    SO50 6RR Eastleigh
    Unit 8 Barton Park Industrial Estate
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Maurizio Mayr
    Floor
    North Dukes Court, 32 Duke Street
    SW1Y 6DF St James's
    3rd
    London
    01 gen 2017
    Floor
    North Dukes Court, 32 Duke Street
    SW1Y 6DF St James's
    3rd
    London
    Nazionalità: German
    Paese di residenza: Italy
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) hanno il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    8th Floor
    10 Lower Thames Street
    EC3R 6AF London
    Northern Shell Building
    England
    30 apr 2016
    8th Floor
    10 Lower Thames Street
    EC3R 6AF London
    Northern Shell Building
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleThe Companies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02081194
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 25 giu 2024
    Consegnato il 26 giu 2024
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance LTD
    Transazioni
    • 26 giu 2024Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 31 mar 2017
    Consegnato il 04 apr 2017
    In corso
    Breve descrizione
    Unit 5 south kirby business park south kirby L1 1LQ (land registry title number to be allocated).
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 apr 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 10 gen 2017
    Consegnato il 12 gen 2017
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 12 gen 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 04 apr 2008
    Consegnato il 15 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bibby Financial Services Limited
    Transazioni
    • 15 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 apr 2008
    • 18 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 04 apr 2008
    Consegnato il 11 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Keith Booker
    Transazioni
    • 11 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Counterpart rent deposit deed
    Creato il 04 apr 2008
    Consegnato il 09 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £9,436.72 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Key Property Investments (Number Nine) Limited
    Transazioni
    • 09 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Counterpart rent deposit deed
    Creato il 04 apr 2008
    Consegnato il 09 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £38,187.50 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Key Property Investments (Number Nine) Limited
    Transazioni
    • 09 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 31 lug 2006
    Consegnato il 03 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Keith Booker
    Transazioni
    • 03 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 giu 2001
    Consegnato il 16 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 2024Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture deed
    Creato il 14 mag 2001
    Consegnato il 22 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit deed
    Creato il 08 feb 2001
    Consegnato il 13 feb 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease
    Brevi particolari
    £82,250 held in an account in the name of the company designated premises at unit 8/8A and 7A barton park industrial estate eastleigh hampshire.
    Persone aventi diritto
    • Industrial Property Investment Fund
    Transazioni
    • 13 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 16 gen 2001
    Consegnato il 20 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Type of equipment - eurotech finishing systems limited iron phosphate plant comprising: 3 stage wash tunnel with iron phosphate stage water rinse and sealing rinse-drier tunnel-powder coating spray booth with twin cyclone recovery plant and 2: spray guns-'u' shape curing overn (16 min @ 180 deg.c)-stuart gill overhead conveyor. Dalby gas fired spray booth/oven approximately 24'X15'X8' serial number unknown (1997). spraybake 12900 gas fired spray booth/oven serial number P0835 05/98.. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 20 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 ott 1996
    Consegnato il 06 nov 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 nov 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0