VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED
Panoramica
Nome della società | VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03059947 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED?
- fabbricazione di carrozzerie per veicoli a motore (eccetto roulotte) (29201) / Industrie manifatturiere
Dove si trova VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Unit 8 Chickenhall Lane SO50 6RR Eastleigh England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
VICTORIA FORGE (SOUTHAMPTON) LIMITED | 23 mag 1995 | 23 mag 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 23 mag 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 06 giu 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 23 mag 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Bilancio redatto al 31 dic 2023 | 35 pagine | AA | ||
Iscrizione dell'ipoteca 030599470013, creata il 25 giu 2024 | 10 pagine | MR01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Cessazione della carica di Elaine Louise Maskelyne come amministratore in data 13 feb 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Emilio Jose Lopez Cantarero come amministratore in data 09 feb 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Gianfranco Natali come amministratore in data 09 feb 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Inigo Cano Arbaiza come amministratore in data 09 feb 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2022 | 29 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2021 | 30 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Modifica dei dettagli di Faist Limited come persona con controllo significativo il 30 apr 2016 | 2 pagine | PSC05 | ||
Modifica dei dettagli di Mr Ashley Nicholas Morris come persona con controllo significativo il 01 ago 2019 | 2 pagine | PSC04 | ||
Notifica di Faist Limited come persona con controllo significativo il 30 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 29 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di John Hanlon come amministratore in data 03 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 28 pagine | AA | ||
Nomina di Ms Xueqiong Yu come amministratore in data 01 ago 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Jason Jay Farrenden come amministratore in data 01 ago 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Elaine Louise Maskelyne il 27 lug 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Paula Denise Morton come segretario in data 12 dic 2019 | 1 pagine | TM02 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor North Dukes Court, 32 Duke Street St James's London SW1Y 6DF a Unit 8 Chickenhall Lane Eastleigh SO50 6RR in data 13 set 2019 | 1 pagine | AD01 | ||
Chi sono gli amministratori di VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANO ARBAIZA, Inigo | Amministratore | Via Del Lavoro 37067 Valeggio Sul Mincio (Vr) 8 Italy | Italy | Spanish | Cfo | 319912680001 | ||||
FARRENDEN, Jason Jay | Amministratore | Chickenhall Lane SO50 6RR Eastleigh Unit 8 England | England | British | Production And Operations Director | 273104540001 | ||||
LOPEZ CANTARERO, Emilio Jose | Amministratore | Via Del Lavoro 37067 Valeggio Sul Mincio (Vr) 8 Italy | Italy | Spanish | Ceo | 319913570001 | ||||
MORRIS, Ashley Nicholas | Amministratore | Chickenhall Lane SO50 6RR Eastleigh Unit 8 England | England | British | Sales Director | 206743740001 | ||||
NATALI, Gianfranco | Amministratore | 74 Boulevard Ditalie 98000 Monte-Carlo Sun Tour Monaco | Monaco | Italian | Ceo | 319913060001 | ||||
YU, Xueqiong | Amministratore | Chickenhall Lane SO50 6RR Eastleigh Unit 8 England | Italy | Chinese | Group Purchasing & Productivity Coordinator | 273984600001 | ||||
HURLSTONE, John Stephen | Segretario | Heatherlea Skipton Road Foulridge BB8 7PY Colne Lancashire | British | Accounts Manager | 42723460001 | |||||
MOORE, Judith | Segretario | The Old Stables Newtown RG20 9AP Newbury The Flat Berkshire England | British | Company Director | 130377720003 | |||||
MOORE, Judith Ann | Segretario | 8 Carrisbroke Close SO21 9PQ New Alresford Hants | British | Production Director | 65729150004 | |||||
MORTON, Paula Denise | Segretario | Barton Park, Chickenhall Lane SO50 6RR Eastleigh Unit 8 Barton Park Ind Estate England | 237457880001 | |||||||
LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001510001 | |||||||
BARKER, Frank Neil | Amministratore | 26 Station Road Foulridge BB8 7LB Colne Lancashire | British | Quality Controller | 54343100001 | |||||
BOOKER, Keith | Amministratore | Cairnmount House TD5 8NN Kelso Roxburghshire | United Kingdom | British | Engineer | 21902620003 | ||||
BOOKER, Keith | Amministratore | 9 Coates Lane Barnoldswick BB8 6HJ Colne Lancashire | British | Electrical Engineer | 21902620001 | |||||
BURY, Allen | Amministratore | 16 Sheringham Avenue FY5 3AD Thornton Cleveleys Lancashire | England | British | Engineer | 60792960001 | ||||
HANLON, John | Amministratore | 29 Hazel Grove Locks Heath SO31 6SH Southampton | United Kingdom | British | Engineer | 58909150002 | ||||
HURLSTONE, John Stephen | Amministratore | Heatherlea Skipton Road Foulridge BB8 7PY Colne Lancashire | British | Accounts Manager | 42723460001 | |||||
HURLSTONE, Nigel Peter | Amministratore | 28 Skipton Old Road BB8 7QA Colne Lancashire | British | Engineer | 30202100002 | |||||
JOPLING, David Nicholas | Amministratore | 5 Channel Way Ocean Village SO14 3TG Southampton Hampshire | England | British | Managing Director | 77010350002 | ||||
MASKELYNE, Elaine Louise | Amministratore | Chickenhall Lane SO50 6RR Eastleigh Unit 8 Barton Park Industrial Estate England | England | British | Certified Chartered Accountant | 236538380002 | ||||
MAYR, Maurizio Eenesto | Amministratore | Cap 05100 Terni Via Magenta 13 Terni Cap 05100 Terni Rome Italy | Italy | German | Company Director | 221127200001 | ||||
MAYR, Maurizio | Amministratore | 77 Terni 05100 Italy Via G. Di Vittorio | Italy | Italian | Board Director | 58669800001 | ||||
MOORE, Judith Ann | Amministratore | Robins Court SO24 9NZ Alresford 8 Robins Court England | United Kingdom | British | Director | 130377720007 | ||||
MOORE, Judith | Amministratore | The Paddock Itchen Abbas SO21 1FJ Winchester 2 Hants | United Kingdom | British | Company Director | 130377720003 | ||||
MOORE, Judith Ann | Amministratore | 8 Carrisbroke Close SO21 9PQ New Alresford Hants | British | Production Director | 65729150004 | |||||
WARD, Stephen David | Amministratore | 22 Euxton Lane PR7 1PS Chorley Lancashire | British | Sales Director | 39297380002 | |||||
WHITTAKER, Barry | Amministratore | 12 Old College Road RG14 1TB Newbury Berkshire | British | Quality | 67521220002 | |||||
LONDON LAW SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 84 Temple Chambers Temple Avenue EC4Y 0HP London | 900001500001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Ashley Nicholas Morris | 01 ago 2019 | Chickenhall Lane SO50 6RR Eastleigh Unit 8 Barton Park Industrial Estate England | No | ||||||||||
Nazionalità: British Paese di residenza: England | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Mr Maurizio Mayr | 01 gen 2017 | Floor North Dukes Court, 32 Duke Street SW1Y 6DF St James's 3rd London | Sì | ||||||||||
Nazionalità: German Paese di residenza: Italy | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Faist Limited | 30 apr 2016 | 8th Floor 10 Lower Thames Street EC3R 6AF London Northern Shell Building England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
VFS (SOUTHAMPTON) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 25 giu 2024 Consegnato il 26 giu 2024 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 31 mar 2017 Consegnato il 04 apr 2017 | In corso | ||
Breve descrizione Unit 5 south kirby business park south kirby L1 1LQ (land registry title number to be allocated). Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A registered charge | Creato il 10 gen 2017 Consegnato il 12 gen 2017 | In corso | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 04 apr 2008 Consegnato il 15 apr 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 04 apr 2008 Consegnato il 11 apr 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Counterpart rent deposit deed | Creato il 04 apr 2008 Consegnato il 09 apr 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari £9,436.72 see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Counterpart rent deposit deed | Creato il 04 apr 2008 Consegnato il 09 apr 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari £38,187.50 see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 31 lug 2006 Consegnato il 03 ago 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 13 giu 2001 Consegnato il 16 giu 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture deed | Creato il 14 mag 2001 Consegnato il 22 mag 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deposit deed | Creato il 08 feb 2001 Consegnato il 13 feb 2001 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease | |
Brevi particolari £82,250 held in an account in the name of the company designated premises at unit 8/8A and 7A barton park industrial estate eastleigh hampshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Chattel mortgage | Creato il 16 gen 2001 Consegnato il 20 gen 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Type of equipment - eurotech finishing systems limited iron phosphate plant comprising: 3 stage wash tunnel with iron phosphate stage water rinse and sealing rinse-drier tunnel-powder coating spray booth with twin cyclone recovery plant and 2: spray guns-'u' shape curing overn (16 min @ 180 deg.c)-stuart gill overhead conveyor. Dalby gas fired spray booth/oven approximately 24'X15'X8' serial number unknown (1997). spraybake 12900 gas fired spray booth/oven serial number P0835 05/98.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 31 ott 1996 Consegnato il 06 nov 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0