FERFOOT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFERFOOT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03060627
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FERFOOT LIMITED?

    • Strutture residenziali di assistenza infermieristica (87100) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova FERFOOT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Asticus Building 2nd Floor
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FERFOOT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CHORD PROPERTIES LIMITED24 mag 199524 mag 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di FERFOOT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per FERFOOT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 24 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 giu 2016

    Stato del capitale al 09 giu 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sanne Group Secretaries (Uk) Limited il 20 lug 2015

    1 pagineCH04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    2 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Sanne Group 2nd Floor Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP a Asticus Building 2nd Floor 21 Palmer Street London SW1H 0AD in data 05 ago 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 24 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 giu 2015

    Stato del capitale al 19 giu 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sanne Group Secretaries (Uk) Limited il 01 gen 2015

    1 pagineCH04

    Nomina di Jonathan David Farkas come amministratore in data 27 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mathieu Streiff come amministratore in data 27 gen 2015

    1 pagineTM01

    legacy

    28 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Bilancio annuale redatto al 24 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 giu 2014

    Stato del capitale al 18 giu 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sanne Group Secretaries (Uk) Limited il 30 mar 2014

    1 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mathieu Streiff il 30 mar 2014

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Sanne Group 1 Berkeley Street London United Kingdom W1J 8DJ* in data 07 apr 2014

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2014 al 31 dic 2013

    3 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    10 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di FERFOOT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    21
    England
    Segretario
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    21
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione8334728
    175738460001
    FARKAS, Jonathan David
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    Amministratore
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building 2nd Floor
    LuxembourgAmericanManaging Director193539990001
    BARTON, Amanda
    48 Sutherland Crescent
    SN14 6RS Chippenham
    Wiltshire
    Segretario
    48 Sutherland Crescent
    SN14 6RS Chippenham
    Wiltshire
    BritishOffice Manager44536640002
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Segretario
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    British109044580001
    CRS LEGAL SERVICES LIMITED
    Newfoundland Chambers
    43a Whitchurch Road
    CF4 3JN Cardiff
    South Glamorgan
    Segretario nominato
    Newfoundland Chambers
    43a Whitchurch Road
    CF4 3JN Cardiff
    South Glamorgan
    900004280001
    BARTON, Amanda
    48 Sutherland Crescent
    SN14 6RS Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    48 Sutherland Crescent
    SN14 6RS Chippenham
    Wiltshire
    BritishOffice Manager44536640002
    BARTON, Bridget Ann
    Turnpike Cottage
    Old Hardenhuish Lane
    SN14 6HH Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    Turnpike Cottage
    Old Hardenhuish Lane
    SN14 6HH Chippenham
    Wiltshire
    BritishManager44536190001
    BARTON, Henry Robin (Dick), Major
    Ferfoot
    Old Hardenhuish Lane
    SN14 6HH Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    Ferfoot
    Old Hardenhuish Lane
    SN14 6HH Chippenham
    Wiltshire
    BritishManager38548600001
    GRIFFIN, Craig
    Halebourne House
    Halebourne Lane
    GU24 8SL Chobham
    Surrey
    Amministratore
    Halebourne House
    Halebourne Lane
    GU24 8SL Chobham
    Surrey
    United KingdomBritishDirector154122490001
    HILL, Peter Martin
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritishAccountant130983750002
    JEFFERY, Paul Anthony Keith
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritishAccountant65609290003
    NOVIK, Bridget Christina
    37 Frogwell Park
    SN14 0RB Chippenham
    Wiltshire
    Amministratore
    37 Frogwell Park
    SN14 0RB Chippenham
    Wiltshire
    BritishManager44536160002
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritishSolicitor148139420001
    STREIFF, Mathieu Bernard
    c/o Sanne Group
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor Pollen House
    Amministratore
    c/o Sanne Group
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    2nd Floor Pollen House
    United StatesAmericanAttorney200529310001
    WHITE, Ian James
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritishAccountant133383410003
    MC FORMATIONS LIMITED
    Newfoundland Chambers
    43a Whitchurch Road
    CF4 3JN Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore delegato nominato
    Newfoundland Chambers
    43a Whitchurch Road
    CF4 3JN Cardiff
    South Glamorgan
    900004800001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FERFOOT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    2nd Floor, 21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building
    England
    06 apr 2016
    2nd Floor, 21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04258255
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    FERFOOT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 28 lug 2010
    Consegnato il 06 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 06 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 21 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 16 nov 2007
    Consegnato il 27 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee for the secured finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Ascot house 28 wingrove road fenham,34 and 36 wingrove road newcastle upon tynet/no's TY221509 and TY52154,bradbury house bradbury house new street braintree t/no ESX647090, cheshire house 22 st mary's road ashton on mersey t/no GM54543 (for details of further properties charged. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Third party debenture
    Creato il 07 dic 2006
    Consegnato il 19 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the debtor to the finance parties on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norddeutsche Landsebank Girozentrale (London Branch)
    Transazioni
    • 19 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 28 gen 2004
    Consegnato il 29 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Ferfoot old hardenhuish lane chippenham wiltshire t/no WT147273. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 dic 2003
    Consegnato il 10 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 26 ott 1995
    Consegnato il 10 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the policies of life insurance no. 2774432 and 2774436. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Halifax Building Society
    Transazioni
    • 10 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 26 ott 1995
    Consegnato il 10 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at ferfoot old hardenhuish lane chippenham wilts. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Halifax Building Society
    Transazioni
    • 10 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0