ASHTEAD (US) HOLDINGS LIMITED

ASHTEAD (US) HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASHTEAD (US) HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03061532
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASHTEAD (US) HOLDINGS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova ASHTEAD (US) HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Ashtead Group Plc Kings House
    36-37 King Street
    EC2V 8BB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ASHTEAD (US) HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KASS PLANT LTD27 giu 199527 giu 1995
    BRAMBLESTREAM LIMITED26 mag 199526 mag 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASHTEAD (US) HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per ASHTEAD (US) HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2013

    5 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 feb 2013

    Stato del capitale al 20 feb 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    legacy

    10 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2012

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Stuart Ian Robson come amministratore in data 13 lug 2012

    1 pagineTM01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Ian Robson il 14 feb 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Eric Watkins il 14 feb 2012

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Richard Pratt il 14 feb 2012

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2011

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 apr 2010

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Richard Pratt il 01 feb 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 apr 2009

    10 pagineAA

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    2 pagineDS02

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    legacy

    1 pagine288c

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    legacy

    1 pagine652a

    Chi sono gli amministratori di ASHTEAD (US) HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WATKINS, Eric
    Kings House
    36-37 King Street
    EC2V 8BB London
    C/O Ashtead Group Plc
    Segretario
    Kings House
    36-37 King Street
    EC2V 8BB London
    C/O Ashtead Group Plc
    British100734790002
    PRATT, Michael Richard
    Kings House
    36-37 King Street
    EC2V 8BB London
    C/O Ashtead Group Plc
    Amministratore
    Kings House
    36-37 King Street
    EC2V 8BB London
    C/O Ashtead Group Plc
    EnglandBritish37254010002
    CLARK, Robert Edmund
    Kings Court
    41-51 Kingston Road
    KT22 7AP Leatherhead
    Surrey
    Segretario
    Kings Court
    41-51 Kingston Road
    KT22 7AP Leatherhead
    Surrey
    British71028550003
    EVANS, Malcolm John
    22 Brookhill Drive
    NG8 2PS Nottingham
    Segretario
    22 Brookhill Drive
    NG8 2PS Nottingham
    British60525740001
    MAIR, James Stewart
    13 Jackson Close
    Oadby
    LE2 4US Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    13 Jackson Close
    Oadby
    LE2 4US Leicester
    Leicestershire
    British8864270002
    REED, Neil
    16a Church Lane
    Cossall
    NG16 2RW Nottingham
    East Midlands
    Segretario
    16a Church Lane
    Cossall
    NG16 2RW Nottingham
    East Midlands
    British85948070001
    ROBSON, Stuart Ian
    8 Belvedere Court Paulin Drive
    Winchmore Hill
    N21 1AZ London
    Segretario
    8 Belvedere Court Paulin Drive
    Winchmore Hill
    N21 1AZ London
    British71308340006
    SAME-DAY COMPANY SERVICES LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Segretario nominato
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000980001
    ANDERSON, Alan
    78 Pennington Road
    Southborough
    TN4 0AF Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    78 Pennington Road
    Southborough
    TN4 0AF Tunbridge Wells
    Kent
    British3103840007
    BURNETT, George Barnett
    Kings Court
    41-51 Kingston Road
    KT22 7AP Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Kings Court
    41-51 Kingston Road
    KT22 7AP Leatherhead
    Surrey
    British55096390004
    EVANS, Malcolm John
    22 Brookhill Drive
    NG8 2PS Nottingham
    Amministratore
    22 Brookhill Drive
    NG8 2PS Nottingham
    British60525740001
    LEWIS, Peter Donald
    Broadacre Ismays Road
    Ightham
    TN15 9BE Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Broadacre Ismays Road
    Ightham
    TN15 9BE Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish55096310002
    LEWIS, Peter Donald
    Ashtead House Business Park 8
    Barnett Wood Lane
    KT22 7DG Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Ashtead House Business Park 8
    Barnett Wood Lane
    KT22 7DG Leatherhead
    Surrey
    British55096310003
    PATEL, Ritman
    42 Woodmere Avenue
    CR0 7PB Croydon
    Surrey
    Amministratore
    42 Woodmere Avenue
    CR0 7PB Croydon
    Surrey
    EnglandBritish82448140001
    ROBSON, Stuart Ian
    Kings House
    36-37 King Street
    EC2V 8BB London
    C/O Ashtead Group Plc
    Amministratore
    Kings House
    36-37 King Street
    EC2V 8BB London
    C/O Ashtead Group Plc
    United KingdomBritish71308340006
    ROBSON, Stuart Ian
    Ashtead House Business Park 8
    Barnett Wood Lane
    KT22 7DN Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Ashtead House Business Park 8
    Barnett Wood Lane
    KT22 7DN Leatherhead
    Surrey
    British71308340001
    SHEARSTONE, Michael Terence
    The Beeches
    Holme Pierrepont
    NG12 2LD Nottingham
    Amministratore
    The Beeches
    Holme Pierrepont
    NG12 2LD Nottingham
    British5485470001
    WILDMAN & BATTELL LIMITED
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    Amministratore delegato nominato
    9 Perseverance Works
    Kingsland Road
    E2 8DD London
    900000970001

    ASHTEAD (US) HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 31 ago 2006
    Consegnato il 15 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America, N.A.
    Transazioni
    • 15 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 31 ago 2006
    Consegnato il 16 set 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any obilgor to any of the hy noteholders or the chargee on any account whatseover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land k/a plot b speedwells park newgate lane fareham hampshire t/no HP525412. Land lying to south side of old woverton road woverton milton keynes t/no BM234641. 130 kingston road leatherhead surrey t/no SY698548. For details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York as Trustee and Agent of the Hy Beneficiaries (The Trustee)
    Transazioni
    • 16 set 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 03 ago 2005
    Consegnato il 12 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any hy obligor to any of the hy noteholders or the trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land k/a plot b speedwells park newgate lane fareham hampshire t/n HP525412 land lying to south side of wolverton road wolverton t/n BM234641 130 kingston road leatherhead t/n SY698548 for details of further properties charged please refer to form 395 fixed charge all securities all debts the proceeds of collection of all debts and all moneys from time to time standing to the credit of the receivables account goodwill uncalled capital intellectual property floating charge its undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York as Trustee and Agent for the Hy Beneficiaries
    Transazioni
    • 12 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 12 nov 2004
    Consegnato il 24 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the properties. By way of fixed charge all securities, all debts, the proceeds of collection of all debts and all moneys standing to the credit of the receivables account and all accounts, all moneys payable under or pursuant to the insurances, all proceeds of all other sums of money, the goodwill and uncalled capital, intellectual property and the other debts. By way of floating charge the undertaking and all property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of America, N.A.
    Transazioni
    • 24 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 nov 2004
    Consegnato il 24 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York as Trustee for the Hy Noteholders (The "Trustee")
    Transazioni
    • 24 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0