AUTODIAGNOS LIMITED

AUTODIAGNOS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAUTODIAGNOS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03062855
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AUTODIAGNOS LIMITED?

    • (9305) /

    Dove si trova AUTODIAGNOS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hopton Industrial Estate
    London Road
    SN10 2EU Devizes
    Wiltshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AUTODIAGNOS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AUTODIAGNOS UK LIMITED19 dic 199519 dic 1995
    AUTO DIAGNOSTIC UK LIMITED31 mag 199531 mag 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di AUTODIAGNOS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per AUTODIAGNOS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 mag 2011

    Stato del capitale al 20 mag 2011

    • Capitale: GBP 674,445
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    6 pagineMG01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    18 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    19 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assistenza finanziaria per l'acquisizione di azioni

    RES07

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2006

    8 pagineAA

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2005

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    Chi sono gli amministratori di AUTODIAGNOS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COWARD, Jeremy
    Lanhill View
    SN14 6XS Chippenham
    22
    Wiltshire
    United Kingdom
    Segretario
    Lanhill View
    SN14 6XS Chippenham
    22
    Wiltshire
    United Kingdom
    British108477480002
    COWARD, Jeremy
    Lanhill View
    SN14 6XS Chippenham
    22
    Wiltshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lanhill View
    SN14 6XS Chippenham
    22
    Wiltshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish108477480002
    HOULDEN, Peter John
    32 Wembdon Hill
    Wembdon
    TA6 7PX Bridgwater
    Somerset
    Amministratore
    32 Wembdon Hill
    Wembdon
    TA6 7PX Bridgwater
    Somerset
    EnglandBritish57753270002
    WATKINS, John Ferris
    The Old Watermill
    Mill Hill Chiddingstone
    TN8 7AA Edenbridge
    Kent
    Amministratore
    The Old Watermill
    Mill Hill Chiddingstone
    TN8 7AA Edenbridge
    Kent
    EnglandBritish117984420001
    DAWSON, Yvette Julie
    10 Meadowbarn Close
    Cottam
    PR4 0AG Preston
    Segretario
    10 Meadowbarn Close
    Cottam
    PR4 0AG Preston
    British43525650001
    ERICSON, Per Anders
    Vastra Sabygatan 1
    736 92 Kungsor
    FOREIGN Sweden
    Segretario
    Vastra Sabygatan 1
    736 92 Kungsor
    FOREIGN Sweden
    Swedish44535810001
    GRILK, Thomas Swiney
    10 Underhill Road
    Lynnfield
    Ma 01940
    Usa
    Segretario
    10 Underhill Road
    Lynnfield
    Ma 01940
    Usa
    American114994150001
    ISAKSSON, Fredrik
    Storangsvagen 98
    13672 Handen
    Sweden
    Segretario
    Storangsvagen 98
    13672 Handen
    Sweden
    Swedish52950120001
    JOHNSON, Neil Austin
    Brentwood House,8 Mainwaring Road
    Over Peover
    WA16 8TR Knutsford
    Cheshire
    Segretario
    Brentwood House,8 Mainwaring Road
    Over Peover
    WA16 8TR Knutsford
    Cheshire
    British66481370002
    MARCHENT, Nevelle
    Cherry Tree House
    129 Bridgwater Road
    TA2 8BQ Taunton
    Somerset
    Segretario
    Cherry Tree House
    129 Bridgwater Road
    TA2 8BQ Taunton
    Somerset
    British64655230002
    TAFLIN, Lars Ivar
    Skandavagen 17
    S 182 62 Diursholm
    Sweden
    Segretario
    Skandavagen 17
    S 182 62 Diursholm
    Sweden
    Swedish44535840002
    ABOGADO NOMINEES LIMITED
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    Segretario
    100 New Bridge Street
    EC4V 6JA London
    73539350001
    PARAMOUNT COMPANY SEARCHES LIMITED
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    Segretario nominato
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    900001530001
    BEECHER, Gregory R
    23 Yale Street
    Winchester
    Ma 01890
    Usa
    Amministratore
    23 Yale Street
    Winchester
    Ma 01890
    Usa
    United StatesAmerican82434140001
    CHAMILLARD, George William
    378 Jerusalem Road
    Cohasset
    Ma 02025
    Usa
    Amministratore
    378 Jerusalem Road
    Cohasset
    Ma 02025
    Usa
    American54708040002
    DAWSON, David Martin
    2 The Grange
    Cottam
    PR4 0LE Preston
    Amministratore
    2 The Grange
    Cottam
    PR4 0LE Preston
    British43525590002
    ERICSON, Per Anders
    Vastra Sabygatan 1
    736 92 Kungsor
    FOREIGN Sweden
    Amministratore
    Vastra Sabygatan 1
    736 92 Kungsor
    FOREIGN Sweden
    Swedish44535810001
    HUNT, Christopher John
    Brook Cottage
    26 Robert Street
    TA4 4PG Williton
    Somerset
    Amministratore
    Brook Cottage
    26 Robert Street
    TA4 4PG Williton
    Somerset
    British56539710002
    ISAKSSON, Fredrik
    Storangsvagen 98
    13672 Handen
    Sweden
    Amministratore
    Storangsvagen 98
    13672 Handen
    Sweden
    Swedish52950120001
    JOHNSON, Neil Austin
    Brentwood House,8 Mainwaring Road
    Over Peover
    WA16 8TR Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Brentwood House,8 Mainwaring Road
    Over Peover
    WA16 8TR Knutsford
    Cheshire
    British66481370002
    KOLOSKA, Walt
    Ketch House Enmore Road
    Enmore
    TA5 2DP Bridgwater
    Somerset
    Amministratore
    Ketch House Enmore Road
    Enmore
    TA5 2DP Bridgwater
    Somerset
    EnglandBritish57917120001
    MARCHENT, Nevelle
    Cherry Tree House
    129 Bridgwater Road
    TA2 8BQ Taunton
    Somerset
    Amministratore
    Cherry Tree House
    129 Bridgwater Road
    TA2 8BQ Taunton
    Somerset
    EnglandBritish64655230002
    MILES, Peter Richard
    12 Lumb Lane
    SK7 2BA Bramhall
    Cheshire
    Amministratore
    12 Lumb Lane
    SK7 2BA Bramhall
    Cheshire
    United KingdomBritish70262390003
    OSATTIN, Stuart Mark
    44 Pineclife Drive
    Marblehead
    Ma 01945
    Usa
    Amministratore
    44 Pineclife Drive
    Marblehead
    Ma 01945
    Usa
    American82099560001
    TAFLIN, Lars Ivar
    Skandavagen 17
    S 182 62 Diursholm
    Sweden
    Amministratore
    Skandavagen 17
    S 182 62 Diursholm
    Sweden
    Swedish44535840002
    PARAMOUNT PROPERTIES (UK) LIMITED
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    Amministratore delegato nominato
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    900001520001

    AUTODIAGNOS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    All assets debenture
    Creato il 04 gen 2010
    Consegnato il 06 gen 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 06 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 18 dic 2006
    Consegnato il 30 dic 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 16 gen 2006
    Consegnato il 27 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of rent deposit
    Creato il 06 nov 2003
    Consegnato il 14 nov 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Rent deposit sum of £12,102.50.
    Persone aventi diritto
    • Bruntwood Estates Limited
    Transazioni
    • 14 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    All assets debenture
    Creato il 22 ago 2003
    Consegnato il 30 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0