STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED

STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale
    Numero di società 03065012
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Commerce House
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2023

    Quali sono le ultime deposizioni per STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mag 2023

    9 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2023 al 31 mag 2023

    1 pagineAA01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2022

    9 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Business Innovation Centre Studio 10 Sutherland Institute Lightwood Road Longton Stoke-on-Trent ST3 4HY United Kingdom a Commerce House Etruria Stoke-on-Trent ST1 5BE in data 03 ago 2022

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2021

    9 pagineAA

    Cessazione della carica di Kevin Lee Taylor come amministratore in data 02 set 2021

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2020

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Jonathan Robert Andrew come amministratore in data 18 feb 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Kevin Lee Taylor come amministratore in data 06 ago 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2019

    8 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Rebekah Herschel Shenton il 18 ago 2018

    2 pagineCH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2018

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Business Innovation Centre Staffordshire Technology Park Beaconside Stafford ST18 0AR a Business Innovation Centre Studio 10 Sutherland Institute Lightwood Road Longton Stoke-on-Trent ST3 4HY in data 15 nov 2017

    1 pagineAD01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2017

    10 pagineAA

    Notifica di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo

    2 paginePSC08

    Chi sono gli amministratori di STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    K & S SECRETARIES LIMITED
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle
    The Brampton
    Staffordshire
    United Kingdom
    Segretario
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle
    The Brampton
    Staffordshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione02795473
    114754200001
    BRIGGS, Andrew
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Amministratore
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    United KingdomBritish163842990001
    FRANCIS, John Stuart
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Amministratore
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    United KingdomBritish40524300001
    HARPER, Rebekah Herschel
    Studio 10 Sutherland Institute
    Lightwood Road
    ST3 4HY Longton
    Business Innovation Centre
    Stoke-On-Trent
    United Kingdom
    Amministratore
    Studio 10 Sutherland Institute
    Lightwood Road
    ST3 4HY Longton
    Business Innovation Centre
    Stoke-On-Trent
    United Kingdom
    United KingdomBritish111618580004
    KELSALL, Eric
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Amministratore
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    United KingdomBritish99415580001
    KELSALL, Rachel Louise
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Amministratore
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    EnglandBritish190000760001
    MORRIS, Paul Jonathan
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Amministratore
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    United KingdomBritish151623600001
    PEARCE, Anthony Norman, Councellor
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Amministratore
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    United KingdomBritish65400220002
    RILEY, Geoffrey
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    Amministratore
    Etruria
    ST1 5BE Stoke-On-Trent
    Commerce House
    England
    EnglandBritish133180130001
    BIRD, James Christopher Michael
    8 Allen Street
    ST4 7NP Stoke On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    8 Allen Street
    ST4 7NP Stoke On Trent
    Staffordshire
    British63447900002
    MILLER, Derek John
    6 Sidmouth Avenue
    ST5 0QN Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Segretario
    6 Sidmouth Avenue
    ST5 0QN Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    British37920530001
    PRICE, Sebastian
    The Hawthorns Cherry Tree Lane
    Woore
    CW3 9SR Crewe
    Cheshire
    Segretario
    The Hawthorns Cherry Tree Lane
    Woore
    CW3 9SR Crewe
    Cheshire
    British68818870001
    QUIRK, Cindy Ann
    Ardencote
    New Street Lane
    TF9 3RN Market Drayton
    Salop
    Segretario
    Ardencote
    New Street Lane
    TF9 3RN Market Drayton
    Salop
    British46098140002
    K&S DIRECTORS LIMITED
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Segretario
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    97199250001
    ANDERSON, Sarah, Dr
    64 Heathend Road
    Alsager
    ST7 2SH Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    64 Heathend Road
    Alsager
    ST7 2SH Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish19798790001
    ANDREW, Jonathan Robert
    Studio 10 Sutherland Institute
    Lightwood Road
    ST3 4HY Longton
    Business Innovation Centre
    Stoke-On-Trent
    United Kingdom
    Amministratore
    Studio 10 Sutherland Institute
    Lightwood Road
    ST3 4HY Longton
    Business Innovation Centre
    Stoke-On-Trent
    United Kingdom
    United KingdomBritish64082380001
    ASTON, Ronald
    Fox House Tythe Barn
    Alton
    ST10 4AZ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Fox House Tythe Barn
    Alton
    ST10 4AZ Stoke On Trent
    Staffordshire
    British43668490001
    BIRD, James Christopher Michael
    8 Allen Street
    ST4 7NP Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    8 Allen Street
    ST4 7NP Stoke On Trent
    Staffordshire
    British63447900002
    BLAKE, David
    17 Canalside Close
    ST19 5TX Penkridge
    Staffordshire
    Amministratore
    17 Canalside Close
    ST19 5TX Penkridge
    Staffordshire
    British57941390002
    BODEN, Philip Keeling
    2 Jonathan Road
    ST4 8LP Stoke On Trent
    Amministratore
    2 Jonathan Road
    ST4 8LP Stoke On Trent
    British34859400001
    BOOTH, Sandra
    Margaret Street
    ST15 8EL Stone
    16 Reliant House
    Staffordshire
    Amministratore
    Margaret Street
    ST15 8EL Stone
    16 Reliant House
    Staffordshire
    UkBritish146050960001
    BURNS, Stephen James
    32 Raleigh Close
    Old Hall
    WA5 5QS Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    32 Raleigh Close
    Old Hall
    WA5 5QS Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish174030900001
    CLARK, Graham Roger
    5 Horsefair
    Eccleshall
    ST21 6AA Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    5 Horsefair
    Eccleshall
    ST21 6AA Stafford
    Staffordshire
    British57392030001
    COOPER, Alan John, Dr
    146 Stubby Lane
    Wednesfield
    WV11 3NF Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    146 Stubby Lane
    Wednesfield
    WV11 3NF Wolverhampton
    West Midlands
    British32145970001
    DAIN, John Stewart
    32 Captains Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8EZ Burton On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    32 Captains Lane
    Barton Under Needwood
    DE13 8EZ Burton On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish7028540001
    DRYER, John Richard
    College Road
    ST4 2DE Stoke-On-Trent
    Staffordshire University
    Staffordshire
    England
    Amministratore
    College Road
    ST4 2DE Stoke-On-Trent
    Staffordshire University
    Staffordshire
    England
    EnglandBritish193362300001
    FELTBOWER, Geoffrey Howard
    28 Megacre
    Bignall End
    ST7 8PA Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    28 Megacre
    Bignall End
    ST7 8PA Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish57392150002
    GALLAGHER, Rosalind
    Milestone Cottage
    15 Nantwich Road, Woore
    CW3 9SB Crewe
    Cheshire
    Amministratore
    Milestone Cottage
    15 Nantwich Road, Woore
    CW3 9SB Crewe
    Cheshire
    British74980860001
    GRANT, John Victor
    60 Cannock Road
    ST17 0QQ Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    60 Cannock Road
    ST17 0QQ Stafford
    Staffordshire
    British65880600001
    HEERAN, Mark Michael
    Tixall Road
    Littleworth
    ST16 3UY Stafford
    91
    Staffordshire
    Amministratore
    Tixall Road
    Littleworth
    ST16 3UY Stafford
    91
    Staffordshire
    United KingdomBritish147619080001
    HENSON, Ronald Michael, Dr
    11 Weeping Cross
    ST17 0DF Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    11 Weeping Cross
    ST17 0DF Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritish10023600001
    JACKSON, Stuart Malcolm
    21 The Brambles
    Westbury Park Clayton
    ST5 4JJ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    Amministratore
    21 The Brambles
    Westbury Park Clayton
    ST5 4JJ Newcastle Under Lyme
    Staffordshire
    United KingdomBritish79731380001
    LYNCH, David Ross
    The Outlands Bishops Offley
    Eccleshall
    ST21 6HB Stafford
    Staffs
    Amministratore
    The Outlands Bishops Offley
    Eccleshall
    ST21 6HB Stafford
    Staffs
    United KingdomBritish111260170001
    MABEY, Mark, Dr
    2 Leadbeater Avenue
    Penghull
    ST4 5HE Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    2 Leadbeater Avenue
    Penghull
    ST4 5HE Stoke On Trent
    Staffordshire
    British115823450001
    MATHER, David
    35 Pack Horse Road
    Melbourne
    DE73 8EG Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    35 Pack Horse Road
    Melbourne
    DE73 8EG Derby
    Derbyshire
    British120208940001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    06 apr 2016La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    STAFFORDSHIRE AND BLACK COUNTRY BUSINESS INNOVATION CENTRE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 26 set 2002
    Consegnato il 17 ott 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0