CAMBRIDGE MECHATRONICS LIMITED
Panoramica
Nome della società | CAMBRIDGE MECHATRONICS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Attiva |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03071231 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CAMBRIDGE MECHATRONICS LIMITED?
- Altre ricerche e sviluppo sperimentale in scienze naturali e ingegneria (72190) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova CAMBRIDGE MECHATRONICS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 306 Cambridge Science Park Milton Road CB4 0WG Cambridge United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CAMBRIDGE MECHATRONICS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
1... LIMITED | 08 ago 1995 | 08 ago 1995 |
PRINTMENU LIMITED | 21 giu 1995 | 21 giu 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CAMBRIDGE MECHATRONICS LIMITED?
Scaduto | No |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2024 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2025 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2023 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per CAMBRIDGE MECHATRONICS LIMITED?
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 21 giu 2025 |
---|---|
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 05 lug 2025 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 21 giu 2024 |
Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per CAMBRIDGE MECHATRONICS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notifica di Stewart Worth Newton come persona con controllo significativo il 04 gen 2024 | 2 pagine | PSC01 | ||||||||||
Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 15 nov 2024 | 2 pagine | PSC09 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 26 set 2024
| 11 pagine | SH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Bickley come amministratore in data 18 set 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 26 giu 2024
| 11 pagine | SH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2024 con aggiornamenti | 40 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Bickley il 21 mag 2024 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Joshua Cooke il 21 mag 2024 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jorgen Lantto il 21 mag 2024 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Dr Rajendra Kumar Talluri il 21 mag 2024 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , Unit 18, Block 5 the Westbrook Centre, Milton Road, Cambridge, CB4 1YG, United Kingdom a 306 Cambridge Science Park Milton Road Cambridge CB4 0WG in data 21 mag 2024 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Seconda presentazione di uno stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 11 apr 2024
| 11 pagine | RP04SH01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 11 apr 2024
| 12 pagine | SH01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2023 | 35 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Regis Saleur il 01 gen 2024 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 22 feb 2024
| 10 pagine | SH01 | ||||||||||
Annullamento di azioni. Stato del capitale al 11 gen 2024
| 12 pagine | SH06 | ||||||||||
Acquisto di azioni proprie. | 4 pagine | SH03 | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 24 gen 2024
| 11 pagine | SH01 | ||||||||||
Notifica di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo | 2 pagine | PSC08 | ||||||||||
Cessazione di Stewart Worth Newton come persona con controllo significativo il 04 gen 2024 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 04 gen 2024
| 11 pagine | SH01 | ||||||||||
Seconda presentazione per la cessazione di Professor Geoffrey Mcfarland come amministratore | 3 pagine | RP04TM01 | ||||||||||
Seconda presentazione per la cessazione di Neil Joseph Lerner come amministratore | 4 pagine | RP04TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CAMBRIDGE MECHATRONICS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COOKE, Joshua | Segretario | Cambridge Science Park Milton Road CB4 0WG Cambridge 306 United Kingdom | 304972570001 | |||||||
GUEFOR, Abdul | Amministratore | Pipers Way SN3 1RJ Swindon Intel Corporation (Uk) Ltd United Kingdom | United Kingdom | British | Investment Managing Director | 174742560001 | ||||
HARBOUR, Gideon Mark | Amministratore | Red Place W1K 6PL London 1 United Kingdom | England | British | Director | 45473400003 | ||||
KENT, Osman | Amministratore | 112 Jermyn Street SW1Y 6LS London Atlantic Bridge Capital Llp United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 317266510001 | ||||
LANTTO, Jorgen | Amministratore | Cambridge Science Park Milton Road CB4 0WG Cambridge 306 United Kingdom | Sweden | Swedish | Director | 275404840001 | ||||
NEWTON, Stewart Worth | Amministratore | 2a Southwark Bridge Road SE1 9HA London Riverside House United Kingdom | Channel Islands | British | Company Director | 572350016 | ||||
OSMANT, Andrew | Amministratore | Castle Street CB10 1BJ Saffron Walden 40 Essex England | England | British | Accountant | 75346230004 | ||||
SALEUR, Regis | Amministratore | 97 Rue Saint Lazare 75009 Paris Supernova Invest France | France | French | Managing Partner | 317266490001 | ||||
TALLURI, Rajendra Kumar, Dr | Amministratore | Cambridge Science Park Milton Road CB4 0WG Cambridge 306 United Kingdom | United States | Indian | Director | 285663850001 | ||||
DIXON, Susan Elizabeth | Segretario | 1 Evening Court Newmarket Road CB5 8EA Cambridge | British | 61237180003 | ||||||
EMERY, Joanna Serena | Segretario | The Westbrooke Centre Milton Road CB4 1YG Cambridge Unit 18, Block 5 United Kingdom | 293861790001 | |||||||
LIONE, Christine Amelia | Segretario | 52 Addison Road E11 2RG London | British | 65685130001 | ||||||
MORLEY, Gary Cornwell | Segretario | Milton Road CB4 1YG Cambridge Westbrook Centre Cambridgeshire England | 283515330001 | |||||||
OSMANT, Andrew | Segretario | Castle Street CB10 1BJ Saffron Walden 40 Essex England | British | 75346230002 | ||||||
PETERSON, Marion Linda | Segretario | 5 Chesterton Hall Crescent CB4 1AW Cambridge Cambridgeshire | British | Director | 9540450001 | |||||
TILBROOK, Lois Joan, Dr | Segretario | 79 De Freville Avenue CB4 1HP Cambridge Cambridgeshire | British | Artist | 46011770001 | |||||
WHITTON, Charlie | Segretario | The Westbrook Centre Milton Road CB4 1YG Cambridge Unit 17, Block 6 Cambridgeshire United Kingdom | 242645560001 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BAKER-SMITH, Hugh | Amministratore | Building 6 Westbrook Centre CB4 1YG Cambridge Suite 15, First Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 202543250001 | ||||
BICKLEY, Andrew | Amministratore | Cambridge Science Park Milton Road CB4 0WG Cambridge 306 United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 303479240001 | ||||
BRADLEY, Philip Herbert Gilbert | Amministratore | 30 Smith Terrace SW3 4DH London | England | Irish | Accountant | 30045470002 | ||||
CALDER, Simon Malcolm | Amministratore | Ridge House Shrubbs Hill Lane SL5 0LD Sunningdale Ascot Berkshire | British | Chief Executive Officer | 89830090001 | |||||
GILLETT, David Alexander | Amministratore | 17 High Street CB2 5EH Great Shelford Cambridgeshire | England | British | Company Director | 37798400002 | ||||
HOOLEY, Anthony, Doctor | Amministratore | Grange Court CB3 9BD Cambridge 2 Cambridgeshire | England | British | Scientist | 44135840002 | ||||
KNIGHT, Martin Peter, Dr | Amministratore | First Floor Building 6 Westbrook Centre CB4 1YG Cambridge Suite 15 United Kingdom | United Kingdom | British | Corporate Financier | 64447520009 | ||||
LERNER, Neil Joseph | Amministratore | The Westbrook Centre Milton Road CB4 1YG Cambridge Unit 17, Block 6 Cambridgeshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 70372020001 | ||||
MARTIN, Barrie Lawrence | Amministratore | Romany Cottage 20 Greenhill Road Otford TN14 5RS Sevenoaks Kent | British | Consultant | 1046730002 | |||||
MATHESON, Andrew Michael | Amministratore | 6 Hurd Road Belmont Massachusetts Ma02478 Usa | British | Director | 73440010003 | |||||
MCFARLAND, Geoffrey | Amministratore | The Westbrook Centre Milton Road CB4 1YG Cambridge Unit 17, Block 6 Cambridgeshire United Kingdom | England | British | Director (Engineering) | 244608010001 | ||||
MORGANS, John Barrie | Amministratore | 18 The Fairway Aldwick Bay PO21 4ES Bognor Regis West Sussex | British | Company Director | 9975040002 | |||||
NICKSON, Roy Alexander | Amministratore | 14 Garden Walk CB4 3EN Cambridge Cambridgeshire | British | Consultant | 46011830001 | |||||
OUGHTON, Dominic Michael Anthony | Amministratore | 5 Harewood Mottram Road Broadbottom SK14 6BB Hyde Cheshire | England | British | Senior Industrial Fellow | 71563390002 | ||||
PETERSON, Marion Linda | Amministratore | 5 Chesterton Hall Crescent CB4 1AW Cambridge Cambridgeshire | England | British | Director | 9540450001 | ||||
RINCK, Gary Meyer | Amministratore | 56 Raymond Road Wimbledon SW19 4AL London | United States | General Counsel | 86050580001 | |||||
SHEPHERD, Mark Richard | Amministratore | Clare House 124 High Street SG8 6LB Meldreth Royston Hertfordshire | England | British | Director | 40528400003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CAMBRIDGE MECHATRONICS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
---|---|---|---|
Mr Stewart Worth Newton | 04 gen 2024 | 2a Southwark Bridge Road SE1 9HA London Riverside House United Kingdom | No |
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||
Natura del controllo
| |||
Mr Stewart Worth Newton | 30 giu 2016 | 2a Southwark Bridge Road SE1 9HA London Riverside House United Kingdom | Sì |
Nazionalità: British Paese di residenza: United Kingdom | |||
Natura del controllo
|
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per CAMBRIDGE MECHATRONICS LIMITED?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
04 gen 2024 | 04 gen 2024 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
CAMBRIDGE MECHATRONICS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 24 giu 2013 Consegnato il 02 lug 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 16 dic 2011 Consegnato il 23 dic 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari First fixed charge all charged agreements,all specified intellectual property,all licences see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 18 set 2009 Consegnato il 25 set 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £13,985.44 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The rent deposit being £13,985.44. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 18 feb 2009 Consegnato il 27 feb 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £6,300.94 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Deposit account holding initial sum of £6,300.94 see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 20 ago 2008 Consegnato il 22 ago 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and to the loan note holders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 26 set 2007 Consegnato il 05 ott 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 30 gen 2007 Consegnato il 03 feb 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the loan note holders or the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0