RELPART LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRELPART LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03072868
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RELPART LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova RELPART LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1st Floor North Anchor Court
    Keen Road
    CF24 5JW Cardiff
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RELPART LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CELTIC GATEWAY LIMITED05 ott 199505 ott 1995
    BOLOT BUILDING SERVICES LIMITED 27 giu 199527 giu 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di RELPART LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2009

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per RELPART LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per RELPART LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 09 feb 2016

    19 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 09 feb 2016

    19 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 31 ago 2015

    19 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 28 feb 2015

    18 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 28 feb 2014

    18 pagine2.24B

    Indirizzo della sede legale modificato da * 5Th Floor Riverside House 31 Cathedral Road Cardiff CF11 9HB* in data 18 mar 2014

    2 pagineAD01

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 31 ago 2013

    20 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 28 feb 2013

    18 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 31 ago 2012

    17 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 29 feb 2012

    17 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 31 ago 2011

    17 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    2 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 28 feb 2011

    17 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 31 ago 2010

    13 pagine2.24B

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ott 2009

    10 pagineAA

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    26 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    6 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da * Atlantic House Ground Floor Greenwood Close Cardiff Gate Business Park Cardiff CF23 8RD* in data 19 mar 2010

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di RELPART LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GRIFFITHS, Anne Elizabeth
    Water's Edge 66h Beach Road
    Newton
    CF36 5NE Porthcawl
    9
    Mid Glamorgan
    Wales
    Segretario
    Water's Edge 66h Beach Road
    Newton
    CF36 5NE Porthcawl
    9
    Mid Glamorgan
    Wales
    British35314760002
    BAILEY, Paul Edward
    Shirenewton Hall Shirenewton
    NP6 6RQ Newport
    Gwent
    Amministratore
    Shirenewton Hall Shirenewton
    NP6 6RQ Newport
    Gwent
    WalesBritish61066950001
    GRIFFITHS, Anne Elizabeth
    Water's Edge 66h Beach Road
    Newton
    CF36 5NE Porthcawl
    9
    Mid Glamorgan
    Wales
    Amministratore
    Water's Edge 66h Beach Road
    Newton
    CF36 5NE Porthcawl
    9
    Mid Glamorgan
    Wales
    WalesBritish35314760002
    PATTEN, Bernard Philip
    54 Oakington Avenue
    Little Chalfont
    HP6 6ST Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    54 Oakington Avenue
    Little Chalfont
    HP6 6ST Amersham
    Buckinghamshire
    British60550770001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Segretario nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001
    ADAMS, Michael William
    108 Dora Road
    SW19 7HJ London
    Amministratore
    108 Dora Road
    SW19 7HJ London
    British77455300001
    AUER, Adrian Richard
    Rme House
    Coldharbour Lane
    TW20 8TD Thorpe Egham
    Surrey
    Amministratore
    Rme House
    Coldharbour Lane
    TW20 8TD Thorpe Egham
    Surrey
    United KingdomBritish105271660001
    CRANE, Alan Thomas
    South Lodge French Street
    TN16 1PJ Westerham
    Kent
    Amministratore
    South Lodge French Street
    TN16 1PJ Westerham
    Kent
    United KingdomBritish35181790002
    DUCKWORTH, Roger Ian
    Mayfield
    Huntercombe
    RG9 0RR Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Mayfield
    Huntercombe
    RG9 0RR Henley On Thames
    Oxfordshire
    British674980002
    EDE, Graham Hewett
    Moorings
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Moorings
    Woodland Drive
    KT24 5AN East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish75781300001
    HONE, John Patrick
    29 Home Wood
    Harleyford
    SL7 2SW Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    29 Home Wood
    Harleyford
    SL7 2SW Marlow
    Buckinghamshire
    British2686200002
    JAMES, John Mansel
    Tesano
    Van
    SY18 6NG Llanidloes
    Powys
    Amministratore
    Tesano
    Van
    SY18 6NG Llanidloes
    Powys
    British55503960001
    LOMAS, Graham
    17 Crofters Drive
    HU16 4SD Cottingham
    North Humberside
    Amministratore
    17 Crofters Drive
    HU16 4SD Cottingham
    North Humberside
    British64508130001
    SOULSBY, John Marriott
    7 Plas Street Pol De Leon
    CF64 1TR Penarth
    South Glamorgan
    Amministratore
    7 Plas Street Pol De Leon
    CF64 1TR Penarth
    South Glamorgan
    United KingdonBritish67530330001
    SPROULE, Eric Henry
    148 Warren Road
    BT21 0PQ Donaghadee
    County Down
    Amministratore
    148 Warren Road
    BT21 0PQ Donaghadee
    County Down
    Northern IrelandBritish29910001
    THOMPSON, Clive Antony
    19 Rodway Road
    BR1 3JJ Bromley
    Kent
    Amministratore
    19 Rodway Road
    BR1 3JJ Bromley
    Kent
    EnglandBritish2256030001
    TURNER, Christopher Gerald
    Affricks Manor Watchet Lane
    Little Kingshill
    HP16 0DR Great Missenden
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Affricks Manor Watchet Lane
    Little Kingshill
    HP16 0DR Great Missenden
    Buckinghamshire
    British23534710001
    TWAMLEY, Paul James
    The Old Rectory
    Wolvesnewton
    NP6 Chepstow
    Gwent
    Amministratore
    The Old Rectory
    Wolvesnewton
    NP6 Chepstow
    Gwent
    British27438640001
    COMBINED NOMINEES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NA London
    900000090001
    COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    Amministratore delegato nominato
    Victoria House
    64 Paul Street
    EC2A 4NG London
    900000080001

    RELPART LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 05 nov 2009
    Consegnato il 09 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a global reach site 4 celtic gateway dunleavy drive cardiff bay t/no CYM327174 together with all fixtures see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bailey Investments Limited and Swm Developments Limited
    Transazioni
    • 09 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 05 nov 2009
    Consegnato il 09 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a global reach site 4 celtic gateway dunleavy drive cardiff bay t/no CYM327174 together with all fixtures see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Usk Leap Developments Limited and Swm Developments (Custom House) Limited
    Transazioni
    • 09 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 11 gen 2008
    Consegnato il 15 gen 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H global reach site 4 celtic gateway dunleavy drive cardiff bay t/no CYM327174 together with all buildings and fixtures from time to time on such property by way of fixed equitable charge the goodwill of any business by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and other chattel assets now or from time to time placed on or about the property.
    Persone aventi diritto
    • Principality Building Society
    Transazioni
    • 15 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge over building contract
    Creato il 11 gen 2008
    Consegnato il 15 gen 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The company's interest in the building contract dated 07/09/07 made between the company and stradform limited. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Principality Building Society
    Transazioni
    • 15 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of legal mortgage
    Creato il 09 ott 2006
    Consegnato il 17 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at dunleavy drive cardiff t/no WA965142 and other part of which is known as land at ely fields cardiff t/no CYM33828. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Julian Hodge Bank Limited
    Transazioni
    • 17 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over credit balance
    Creato il 01 giu 2006
    Consegnato il 03 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the monies from time to time in the company's account account number 0122002930000 and all the entitlement to interest,right to repayment and other rights and benefits accruing to or arising in connection with the said account.
    Persone aventi diritto
    • Julian Hodge Bank Limited
    Transazioni
    • 03 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge over building contract
    Creato il 07 apr 2004
    Consegnato il 10 apr 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Benefit in the building contract dated 1 march 2004 between the company and dean & dyball construction limited all rights titles benefits and interests present and future relating to the contract.
    Persone aventi diritto
    • Principality Building Society
    Transazioni
    • 10 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 29 mar 2004
    Consegnato il 30 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property being land lying to the south of dunleavy drive, celtic gateway, cardiff t/no CYM140393; by way of fixed equitable charge the goodwill of any business now or from time to time carried on or from the mortgaged property; by way of floating charge all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment and other chattel assets now or from time to time placed on or about the mortgaged property.
    Persone aventi diritto
    • Principality Building Society
    Transazioni
    • 30 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of the benefit of two agreements for sale
    Creato il 04 mar 2004
    Consegnato il 16 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Agreement for sale dated 2 march 2004 relating to unit b, site 5 celtic gateway dunleavy drive cardiff bay and agreement for sale dated 4 march 2004 relating to unit C3, site 5 celtic gateway dunleavy drive cardiff bay.
    Persone aventi diritto
    • Principality Building Society
    Transazioni
    • 16 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 02 mar 2004
    Consegnato il 11 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that l/h property known as site 5 celtic gateway dunleavy drive cardiff and the goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Principality Building Society
    Transazioni
    • 11 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over development agreement dated 10 september 1996
    Creato il 02 mar 2004
    Consegnato il 11 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The benefit of a development agreement dated 10 september 1996 made between the cardiff bay development corporation and the company relating to land at ely fields cardiff now known as celtic gateway dunleavy drive cardiff bay.
    Persone aventi diritto
    • Principality Building Society
    Transazioni
    • 11 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment
    Creato il 23 lug 1999
    Consegnato il 05 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights title benefit and interest of the assignor under the property works and rental guarantee agreement of even date. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 05 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 23 lug 1999
    Consegnato il 05 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights title benefit and interest of the assignor under the property works and rental guarantee agreement of even date. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 05 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment by way of security of two agreements being a development agreement and a building contract
    Creato il 23 lug 1999
    Consegnato il 05 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights titles benefits and interests of the assignor whatsoever present and future arising out of or connected with or relating to each of the contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 05 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 lug 1999
    Consegnato il 05 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Lease of land k/a site 2 celtic gateway ely fields cardiff.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 05 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 lug 1999
    Consegnato il 05 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The British Linen Bank Limited
    Transazioni
    • 05 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 lug 1999
    Consegnato il 04 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a funding agreement dated 23 july 1999
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Christiani & Nielsen Limited
    • Tci Corporation Limited
    • Ashquay Group PLC
    Transazioni
    • 04 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment
    Creato il 22 lug 1998
    Consegnato il 30 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a counter indemnity of even date
    Brevi particolari
    The account of the company with the bank which account is blocked or designated as charged to the bank into which is to be paid £691,643.84.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 lug 1998
    Consegnato il 29 lug 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the indemnity and guarantee
    Brevi particolari
    L/H plot 1 cabletel house ely fields cardiff. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ashquay Group PLC
    Transazioni
    • 29 lug 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 ott 1997
    Consegnato il 04 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a plot 1 cabletel house ely fields cardiff. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Welsh Development Agency
    Transazioni
    • 04 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 1998Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 19 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment by way of security
    Creato il 15 ott 1997
    Consegnato il 04 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All right title benefits and interest in each contract being the agreement for lease dated 3 june 1997, the building contract dated 30 june 1997 and the development agreement dated 10 september 1997. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • British Linen Properties PLC
    Transazioni
    • 04 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 ott 1997
    Consegnato il 04 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    The lease dated 3 june 1997 between cardiff bay development corporation and the company relating to land at ely fields ferry road cardiff. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • British Linen Properties PLC
    Transazioni
    • 04 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 15 ott 1997
    Consegnato il 04 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All rights titles and benefit in the deposit being the sums standing to the credit of the charged account of the company with the governor and company of the bank of scotland into which is paid £400,000 representing a loan from ashquay group PLC. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • British Linen Properties PLC
    Transazioni
    • 04 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 ott 1997
    Consegnato il 04 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • British Linen Properties PLC
    Transazioni
    • 04 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 ott 1997
    Consegnato il 23 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    RELPART LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 mar 2010Inizio dell'amministrazione
    09 feb 2016Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Hill
    Begbies Traynor
    5th Floor
    CF11 9HB Riverside House
    31 Cathedral Road Cardiff,
    Praticante
    Begbies Traynor
    5th Floor
    CF11 9HB Riverside House
    31 Cathedral Road Cardiff,
    Stephen Wade
    5th Floor Riverside House 31 Cathedral Road
    CF11 9HB Cardiff
    Praticante
    5th Floor Riverside House 31 Cathedral Road
    CF11 9HB Cardiff

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0