FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03074331
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Norcliffe House
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    OMEGA (UK) LIMITED26 giu 199526 giu 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 lug 2015

    Stato del capitale al 23 lug 2015

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Richard Smith il 19 feb 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Robert Taberner il 18 feb 2015

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Dominic Jude Kay come amministratore in data 28 ott 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 lug 2014

    Stato del capitale al 03 lug 2014

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Cessazione della carica di Dominic Kay come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Abigail Mattison come segretario

    2 pagineAP03

    Dettagli del direttore cambiati per Maureen Claire Royston il 22 mag 2014

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Emerson Court Alderley Road Wilmslow Cheshire SK9 1NX* in data 21 feb 2014

    1 pagineAD01

    Nomina di Maureen Claire Royston come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Calveley come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Ian Richard Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    15 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 26 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MATTISON, Abigail
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    188573200001
    ROYSTON, Maureen Claire, Dr
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    Amministratore
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    United KingdomBritish184190020002
    SMITH, Ian Richard
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish181082310001
    TABERNER, Benjamin Robert
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish150511890001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    British38256680007
    GOSLING, Mark David
    8 Dane Close
    Hartlip
    ME9 7TN Sittingbourne
    Kent
    Segretario
    8 Dane Close
    Hartlip
    ME9 7TN Sittingbourne
    Kent
    British66801660001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Segretario
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    British145920530001
    CMM (SECRETARIES) LIMITED
    Sceptre House
    169/173 Regent Street
    W1R 7FB London
    Segretario nominato
    Sceptre House
    169/173 Regent Street
    W1R 7FB London
    900004970001
    SCEPTRE CONSULTANTS LIMITED
    6 Babmaes Street
    SW1Y 6HD London
    Segretario
    6 Babmaes Street
    SW1Y 6HD London
    32627710003
    ANSTEAD, Hamilton Douglas
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    British107751890001
    BAILEY, Essel
    900 Victors Way
    Suite 350
    Ann Arbor
    Mi 48108
    Usa
    Amministratore
    900 Victors Way
    Suite 350
    Ann Arbor
    Mi 48108
    Usa
    American55075420002
    BEARDSLEY, Julian Richard
    Flat 2
    27 Moring Road
    SW17 8DN London
    Amministratore
    Flat 2
    27 Moring Road
    SW17 8DN London
    British67039610001
    CALVELEY, Peter, Dr
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    Amministratore
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    United KingdomBritish131468590001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    British38256680007
    ELLIOTT, Graham Nicholas
    9 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    Amministratore
    9 Bowmans Close
    BN44 3SR Steyning
    West Sussex
    EnglandBritish38064300002
    FLAHERTY, James Paul
    28 Harley House
    Marylebone Road
    NW1 5HF London
    Amministratore
    28 Harley House
    Marylebone Road
    NW1 5HF London
    American52843400002
    GOSLING, Mark David
    8 Dane Close
    Hartlip
    ME9 7TN Sittingbourne
    Kent
    Amministratore
    8 Dane Close
    Hartlip
    ME9 7TN Sittingbourne
    Kent
    British66801660001
    HEYWOOD, Anthony George
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    Amministratore
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    EnglandBritish131288260001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Amministratore
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish145920530001
    MAYNARD, Tanya
    14 Bayham Road
    Chiswick
    W4 1BJ London
    Amministratore
    14 Bayham Road
    Chiswick
    W4 1BJ London
    British41493210001
    MITCHELL, Nicholas John
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Great BritainBritish145102120001
    NOBLE, Edward Charles
    9668 Tree Top Court
    Pickney
    FOREIGN Michigan
    Usa
    Amministratore
    9668 Tree Top Court
    Pickney
    FOREIGN Michigan
    Usa
    American69199980002
    ROBINSON, Todd Philip
    2307 Princess Ann Street
    Greensboro
    North Carolina 27408
    Usa
    Amministratore
    2307 Princess Ann Street
    Greensboro
    North Carolina 27408
    Usa
    American77491610001
    STOREY, John
    17 Collins Street
    SE3 0UG London
    Amministratore
    17 Collins Street
    SE3 0UG London
    British60123860001
    STOVER, David
    905 West Eisenhower Circle
    Suite 110
    48103 Ann Arbor Michigan
    Washtenaw County
    Usa
    Amministratore
    905 West Eisenhower Circle
    Suite 110
    48103 Ann Arbor Michigan
    Washtenaw County
    Usa
    American55075550001
    WILLIS, Graeme
    4 Woodbank
    Lynton Lane
    SK9 7NP Alderley Edge
    Cheshire
    Amministratore
    4 Woodbank
    Lynton Lane
    SK9 7NP Alderley Edge
    Cheshire
    British71527500004

    FOUR SEASONS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Scottish floating charge
    Creato il 24 nov 2006
    Consegnato il 14 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First floating charge all its present and future property,assets and undertaking situated in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse,London Branch
    Transazioni
    • 14 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A security deed
    Creato il 30 ott 2006
    Consegnato il 17 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse London Branch
    Transazioni
    • 17 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 09 gen 2006
    Consegnato il 18 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rhyme debenture
    Creato il 12 nov 2004
    Consegnato il 30 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Scarlet Finance Limited
    Transazioni
    • 30 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A charge over bank accounts
    Creato il 03 lug 2003
    Consegnato il 11 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its rights and interests in, and all monies standing to the credit of the account by way of first fixed charge. A floating charge as further security for the payment of the indebtedness, charged with full title guarantee all its rights and interests in, and all monies stnading to the credit of, the account.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security accession deed
    Creato il 01 ott 2002
    Consegnato il 16 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all freehold and leasehold property together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) on that property; and by way of first equitable mortgage all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclay Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 16 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0