WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED

WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03074509
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED?

    • (7011) /

    Dove si trova WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NOSU DEVELOPMENTS LIMITED02 ago 199502 ago 1995
    HACKREMCO (NO. 1058) LIMITED30 giu 199530 giu 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    2 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Nations House 103 Wigmore Street London W1U 1AE in data 08 mar 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 feb 2012

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Cessazione della carica di Nicholas Paul Kelsall come amministratore in data 23 gen 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robert William Game come amministratore in data 23 gen 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Vinod Bachulal Vaghela come amministratore in data 03 nov 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Robert William Game come amministratore in data 03 nov 2011

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 lug 2011

    Stato del capitale al 06 lug 2011

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    10 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    11 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2007

    11 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 mar 2006

    13 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LANCHESTER, David James
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    Segretario
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    British7014460002
    GIBSON, Graeme David
    12 Foxhills Close
    Appleton
    WA4 5DH Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    12 Foxhills Close
    Appleton
    WA4 5DH Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish60838970001
    KEOGH, Mark William
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    Amministratore
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    EnglandIrish62140690001
    FOLGER, Susan
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Segretario
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    British36525980001
    HENSON, Mark Richard
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    Segretario
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    British104630800001
    LOWES, Richard Phillip
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    Segretario
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    British5785520001
    WILLIAMS, John Benedict Alan
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    Segretario
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    British79419360001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Segretario nominato
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    COLLINS, Peter William
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish26086560001
    COULING, Graham Charles
    47 Lime Grove
    Kirby Muxloe
    LE9 2DF Leicester
    Amministratore
    47 Lime Grove
    Kirby Muxloe
    LE9 2DF Leicester
    British41278620002
    EDWARDS, John Nigel
    8b Avery Row
    Mayfair
    W1K 4AL London
    Amministratore
    8b Avery Row
    Mayfair
    W1K 4AL London
    United KingdomBritish37742270003
    EDWARDS, John Nigel
    976b Garratt Lane
    SW17 0ND London
    Amministratore
    976b Garratt Lane
    SW17 0ND London
    British37742270001
    GAME, Robert William
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    United Kingdom
    Amministratore
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    United Kingdom
    United KingdomEnglish139555050001
    GIBSON, Graeme David
    12 Foxhills Close
    Appleton
    WA4 5DH Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    12 Foxhills Close
    Appleton
    WA4 5DH Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish60838970001
    GRANT, John Albert Martin
    The Malthouse Manor Lane
    Claverdon
    CV35 8NH Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    The Malthouse Manor Lane
    Claverdon
    CV35 8NH Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish55161940001
    HEWITT, Alan
    The White House Casthorpe Road
    Barrowby
    NG32 1DW Grantham
    Lincolnshire
    Amministratore
    The White House Casthorpe Road
    Barrowby
    NG32 1DW Grantham
    Lincolnshire
    British572100002
    JACKSON, Martin
    6 Fern Lea Drive
    SK11 8PQ Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    6 Fern Lea Drive
    SK11 8PQ Macclesfield
    Cheshire
    British70926010001
    JONES, Morgan Lewis
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish10146340003
    KELSALL, Nicholas Paul
    7 Dunnockswood
    Alsager
    ST7 2XU Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    7 Dunnockswood
    Alsager
    ST7 2XU Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish34374490002
    MEADE, Karl Robert
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish118074370001
    NEVIN, Mark
    110 Westmorland Road
    Urmston
    M41 9HP Manchester
    Amministratore
    110 Westmorland Road
    Urmston
    M41 9HP Manchester
    EnglandBritish72157500001
    OVENS, Mark Douglas
    Birdhurst
    37 The Warren
    SM5 4EQ Carshalton
    Surrey
    Amministratore
    Birdhurst
    37 The Warren
    SM5 4EQ Carshalton
    Surrey
    United KingdomBritish56734030003
    RIX, Timothy
    93 Chertsey Road
    GU20 6HU Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    93 Chertsey Road
    GU20 6HU Windlesham
    Surrey
    British47277200001
    ROGERS, Martin John
    Wood Knoll 49 Burton Road
    Repton
    DE65 6FN Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    Wood Knoll 49 Burton Road
    Repton
    DE65 6FN Derby
    Derbyshire
    EnglandBritish31854560001
    STEVENS, Michael John
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish60348780002
    VAGHELA, Vinod Bachulal
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    Amministratore
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    EnglandBritish5689250001
    VAGHELA, Vinod Bachulal
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    Amministratore
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    EnglandBritish5689250001
    VINCENT, Michael
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    Amministratore
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    EnglandBritish99258270001
    WATSON, Ian Richard
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish68256540001
    HACKWOOD DIRECTORS LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Amministratore delegato nominato
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004840001

    WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 21 mar 1996
    Consegnato il 27 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any loan document (as defined)
    Brevi particolari
    Land at chapel hill braintree essex t/n ex 502805 and part of land within t/n ex 379124. by way of first equitable mortgage all real property acquired by the company after the creation of the charge. Floating charge over the undertaking and all assets present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norcross Developments Limited
    Transazioni
    • 27 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating legal charge
    Creato il 21 mar 1996
    Consegnato il 26 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any loan document
    Brevi particolari
    Land at chapel hill braintree essex t/n EX502805 and part of the land within title number EX379124 and by way of first floating charge all undertaking and assets.
    Persone aventi diritto
    • Suter Estates Limited
    Transazioni
    • 26 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 17 ago 1995
    Consegnato il 01 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement dated 16TH august 1995
    Brevi particolari
    F/H property k/a land at chapel hill, braintree t/no. EX502805 and all buildings and fixtures thereon. First equitable mortgage all real property acquired by the company after the creation of the charge. First floating charge on all undertaking and assets of the company present and future including uncalled capital.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Suter Estates Limited
    Transazioni
    • 01 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    WYEBROOK DEVELOPMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 nov 2012Data di scioglimento
    28 feb 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Gordon Franklin
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    Praticante
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0