GROUP VEHICLE SERVICES (1) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GROUP VEHICLE SERVICES (1) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03074526 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GROUP VEHICLE SERVICES (1) LIMITED?
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova GROUP VEHICLE SERVICES (1) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 135 Bishopsgate EC2M 3UR London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GROUP VEHICLE SERVICES (1) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| LOMBARD VEHICLE MANAGEMENT (NO.1) LIMITED | 16 ott 1998 | 16 ott 1998 |
| NATWEST VEHICLE MANAGEMENT (NO. 1) LIMITED | 09 ott 1995 | 09 ott 1995 |
| HACKREMCO (NO. 1066) LIMITED | 30 giu 1995 | 30 giu 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GROUP VEHICLE SERVICES (1) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2012 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per GROUP VEHICLE SERVICES (1) LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per GROUP VEHICLE SERVICES (1) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 3 Princess Way Redhill Surrey RH1 1NP* in data 23 set 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Carolyn Whittaker come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 giu 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Andrew Paul Gadsby come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Barnard come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Paul Andrew Murray come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Simon Recaldin come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2012 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di un segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Rbs Secretarial Services Limited come segretario | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 giu 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Miss Carolyn Jean Whittaker il 10 lug 2012 | 2 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2011 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 giu 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Dominic Recaldin come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stuart Houlston come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2010 | 29 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 giu 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Andrew David Barnard come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neeraj Kapur come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2009 | 27 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GROUP VEHICLE SERVICES (1) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24/25 Scotland |
| 169073830001 | ||||||||||
| CLIBBENS, Nigel Timothy John | Amministratore | 40a Pennington Road Southborough TN4 0SL Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 49141230004 | |||||||||
| GADSBY, Andrew Paul | Amministratore | Bishopsgate EC2M 3UR London 135 England | England | British | 74834980002 | |||||||||
| MURRAY, Paul Andrew | Amministratore | 3 Princess Way RH1 1NP Redhill Lombard House Surrey England | England | British | 177275850001 | |||||||||
| ADAMS, Rowan Daniel Justin | Segretario | 3 Tower Road Strawberry Hill TW1 4PD Twickenham Middlesex | British | 44470780001 | ||||||||||
| BROMLEY, Heidi Elizabeth | Segretario | 1 Snowball Cottages Swan Lane RH6 0DB Charlwood Surrey | British | 33605720003 | ||||||||||
| BROMLEY, Heidi Elizabeth | Segretario | 40 Hitchings Way RH2 8EW Reigate Surrey | British | 33605720002 | ||||||||||
| CUNNINGHAM, Angela Mary | Segretario | 26 Green Acres Park Hill CR0 5UW Croydon Surrey | British | 62801910001 | ||||||||||
| EVANS, Margaret Janet | Segretario | 17 Coniston Way RH2 0LN Reigate Surrey | British | 2289880001 | ||||||||||
| HOFMANN, David John | Segretario | 16 Sheredes Drive EN11 8LJ Hoddesdon Hertfordshire | British | 49331410001 | ||||||||||
| LEWIS, Derek John | Segretario | 48 Chantry Avenue Hartley DA3 8DD Longfield Kent | British | 34423910002 | ||||||||||
| WHITTAKER, Carolyn Jean | Segretario | 280 Bishopsgate EC2M 4RB London 4th Floor England | Other | 67499700003 | ||||||||||
| HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||||||
| BAILEY, Robert Andrew | Amministratore | Bechers Withybed Lane WR7 4JJ Inkberrow Worcestershire | United Kingdom | British | 104106520002 | |||||||||
| BARNARD, Andrew David | Amministratore | Bell Cottage Bell Road RH12 3QL Warnham Bell Cottage West Sussex England | England | British | 137736080001 | |||||||||
| BARR, David Howard | Amministratore | Glendale 21 St Brydes Way Cardrona EH45 9LL Peebles Scottish Borders | United Kingdom | British | 78519370001 | |||||||||
| BOOTH, Thomas John | Amministratore | Rose Farmhouse Seaton Ross YO42 4LZ York | British | 104299390001 | ||||||||||
| BUTLER, Peter Alan | Amministratore | 13 Abbot Close Oakwood DE21 2BQ Derby | British | 45135730001 | ||||||||||
| DENMAN, Philip Graham | Amministratore | Lahaina Pamington GL20 8LX Tewkesbury Gloucestershire | England | British | 162703220001 | |||||||||
| FLINT, Eion Arthur Mcmorran | Amministratore | Manor Farm Main Street Levisham YO18 7NL Pickering North Yorkshire | British | 56760630003 | ||||||||||
| FLINT, Eion Arthur Mcmorran | Amministratore | The Rhododendrons Warren Lane Finchampstead RG40 4HS Wokingham Berkshire | British | 56760630002 | ||||||||||
| HOULSTON, Stuart | Amministratore | Hastings Pool Poolbrook Road WR14 3QL Barnards Green Quantock Grange Worcestershire | British | 137490170001 | ||||||||||
| JONES, Dennis | Amministratore | 20 Overton Shaw Baldwins Hill RH19 2HN East Grinstead West Sussex | British | 70099540001 | ||||||||||
| KAPUR, Neeraj | Amministratore | The Old Granary Hillside Road GU10 3AJ Frensham Surrey | United Kingdom | British | 122158360001 | |||||||||
| KNOWLES, Christopher George | Amministratore | Whispering Well House Chander Hill Lane, Holymoorside S42 7HN Chesterfield Derbyshire | British | 67501900002 | ||||||||||
| PARKINSON, Alan Donald | Amministratore | 8 Pinchwell View Wickersley S66 1FP Rotherham South Yorkshire | England | British | 104435050001 | |||||||||
| RAMANATHAN, Shankar | Amministratore | Mowson Hollow Worrall S35 0AD Sheffield 3 South Yorkshire | England | British | 125663610001 | |||||||||
| RECALDIN, Simon Dominic | Amministratore | Princess Way RH1 1NP Redhill 3 Surrey England | England | British | 90574780001 | |||||||||
| SKILLEN, Christopher Thomas | Amministratore | The Stables Nortoft Guilsborough NN6 8QB Northampton | British | 53126450002 | ||||||||||
| SPICKNELL, Mark Andrew | Amministratore | 88 Oakland Road DA6 7AL Bexleyheath Kent | England | British | 104107710001 | |||||||||
| HACKWOOD DIRECTORS LIMITED | Amministratore delegato nominato | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004840001 |
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0