MILLENCO HARDWARE LTD.

MILLENCO HARDWARE LTD.

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMILLENCO HARDWARE LTD.
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03075676
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MILLENCO HARDWARE LTD.?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova MILLENCO HARDWARE LTD.?

    Indirizzo della sede legale
    Portebello
    School Street
    WV13 3PW Willenhall
    West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MILLENCO HARDWARE LTD.?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per MILLENCO HARDWARE LTD.?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher David Browning il 01 apr 2013

    2 pagineCH01

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Nomina di Christopher David Browning come amministratore in data 01 apr 2013

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Claire Louise Bailey come amministratore in data 31 mar 2013

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nigel John Hutchinson come amministratore in data 31 dic 2012

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution INSOLVENCY:Ordinary Resolution ;- "Books,Records.etc"
    1 pagineLIQ MISC RES

    Risoluzione di insolvenza

    Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie"
    1 pagineLIQ MISC RES

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 16 nov 2012

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Bilancio annuale redatto al 04 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 ago 2012

    Stato del capitale al 21 ago 2012

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Cessazione della carica di Neil Arthur Vann come amministratore in data 01 lug 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    12 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    17 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Paddock Fabrications Limited Fryers Road Walsall West Midlands WS2 7LZ in data 17 set 2010

    2 pagineAD01

    Nomina di Alexander Paul Stern come segretario

    3 pagineAP03

    Nomina di Allan David Talbot Cooper come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Claire Louise Bailey come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di John Linley Middleton come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Neil Arthur Vann come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew King come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Andrew King come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di MILLENCO HARDWARE LTD.?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    STERN, Alexander Paul
    School Street
    WV13 3PW Willenhall
    Portebello
    West Midlands
    Segretario
    School Street
    WV13 3PW Willenhall
    Portebello
    West Midlands
    British154212030001
    BROWNING, Christopher David
    School Street
    WV13 3PW Willenhall
    Portebello
    West Midlands
    Amministratore
    School Street
    WV13 3PW Willenhall
    Portebello
    West Midlands
    EnglandBritish177705260001
    COOPER, Allan David Talbot
    School Street
    WV13 3PW Willenhall
    Portebello
    West Midlands
    Amministratore
    School Street
    WV13 3PW Willenhall
    Portebello
    West Midlands
    United KingdomBritish154201290001
    MIDDLETON, John Linley
    School Street
    WV13 3PW Willenhall
    Portebello
    West Midlands
    Amministratore
    School Street
    WV13 3PW Willenhall
    Portebello
    West Midlands
    United KingdomSouth African154201180001
    HUNT, Peter Dennis
    97 Dovehouse Lane
    Olton
    B91 2EQ Solihull
    West Midlands
    Segretario
    97 Dovehouse Lane
    Olton
    B91 2EQ Solihull
    West Midlands
    British13305530002
    KING, Andrew Mark
    23 Yew Croft Avenue
    Harborne
    B17 9TR Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    23 Yew Croft Avenue
    Harborne
    B17 9TR Birmingham
    West Midlands
    British96568110001
    PRIEST, David
    40 Langland Drive
    DY3 3TH Dudley
    West Midlands
    Segretario
    40 Langland Drive
    DY3 3TH Dudley
    West Midlands
    British62678310001
    WILSON, Michael
    15 Brunnel Grove
    Perton
    WV6 7YD Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    15 Brunnel Grove
    Perton
    WV6 7YD Wolverhampton
    West Midlands
    British19302860003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BAILEY, Claire Louise
    School Street
    WV13 3PW Willenhall
    Portebello
    West Midlands
    Amministratore
    School Street
    WV13 3PW Willenhall
    Portebello
    West Midlands
    United KingdomBritish154201050001
    BROMLEY, Mark
    3 Ashtree Close
    Little Haywood
    ST18 0NL Stafford
    Amministratore
    3 Ashtree Close
    Little Haywood
    ST18 0NL Stafford
    British40212890001
    BURNHOPE, Mark Edward
    113 Stafford Road
    Bloxwich
    WS3 3PG Walsall
    West Midlands
    Amministratore
    113 Stafford Road
    Bloxwich
    WS3 3PG Walsall
    West Midlands
    EnglandEnglish60709550001
    HARVEY, Ian James
    The Granary
    Mill Court Mill Lane
    WS14 0DE Shenstone
    Staffordshire
    Amministratore
    The Granary
    Mill Court Mill Lane
    WS14 0DE Shenstone
    Staffordshire
    British71647700003
    HARVEY, Richard Horace
    Long Birch Farm, Port Lane
    Coven
    WV9 5BE Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Long Birch Farm, Port Lane
    Coven
    WV9 5BE Wolverhampton
    West Midlands
    United KingdomBritish16753430002
    HUNT, Peter Dennis
    97 Dovehouse Lane
    Olton
    B91 2EQ Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    97 Dovehouse Lane
    Olton
    B91 2EQ Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish13305530002
    HUTCHINSON, Nigel John
    1 Penkside
    Coven
    WV9 5BL Wolverhampton
    Amministratore
    1 Penkside
    Coven
    WV9 5BL Wolverhampton
    United KingdomBritish63848530002
    KING, Andrew Mark
    23 Yew Croft Avenue
    Harborne
    B17 9TR Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    23 Yew Croft Avenue
    Harborne
    B17 9TR Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish96568110001
    LOFTUS, Thomas
    29 Canalside Close
    Penkridge
    ST19 5TX Stafford
    Amministratore
    29 Canalside Close
    Penkridge
    ST19 5TX Stafford
    British36166430003
    VANN, Neil Arthur
    School Street
    WV13 3PW Willenhall
    Portebello
    West Midlands
    Amministratore
    School Street
    WV13 3PW Willenhall
    Portebello
    West Midlands
    United KingdomBritish154201650001
    WILSON, Michael
    15 Brunnel Grove
    Perton
    WV6 7YD Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    15 Brunnel Grove
    Perton
    WV6 7YD Wolverhampton
    West Midlands
    British19302860003

    MILLENCO HARDWARE LTD. ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 27 gen 2006
    Consegnato il 08 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited (The Security Holder)
    Transazioni
    • 08 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 27 gen 2006
    Consegnato il 04 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of intellectual property rights
    Creato il 27 gen 2006
    Consegnato il 04 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the intellectual property rights, assigns all applications and all right title and interest in and to the applications, all right title and interest in and to all those third party rights and by way of fixed charge such part of the materials. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 16 mar 2005
    Consegnato il 30 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 30 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 16 lug 2002
    Consegnato il 22 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 03 lug 1996
    Consegnato il 12 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Trade Indemnity-Heller Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 12 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MILLENCO HARDWARE LTD. ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    01 ott 2013Data di scioglimento
    16 nov 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0