FLEETS POINT LIMITED

FLEETS POINT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFLEETS POINT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03075946
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FLEETS POINT LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova FLEETS POINT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    BARRY BROOMBERG OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LLP
    Fleet Point Verde 10 Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FLEETS POINT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FITNESS FIRST LIMITED18 ago 200318 ago 2003
    FITNESS FIRST PLC23 set 199623 set 1996
    FITNESS FIRST GROUP LIMITED29 giu 199529 giu 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di FLEETS POINT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per FLEETS POINT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Barry Alan Broomberg come amministratore in data 31 mag 2023

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2022

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2021

    6 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2020

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2019

    6 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Barry Alan Broomberg il 18 nov 2019

    3 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Verde Bressenden Place London SW1E 5DH England a Fleet Point 10 Bressenden Place London SW1E 5DH in data 17 dic 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 nov 2019 senza aggiornamenti

    2 pagineCS01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Paul Richard Stevens come amministratore in data 20 set 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 giu 2018

    34 pagineAA

    Cessazione della carica di Susan Anne Cadd come segretario in data 05 set 2018

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da 52 Willis Way Poole BH15 3SY England a Verde Bressenden Place London SW1E 5DH in data 04 set 2018

    1 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cash dividend of £3166632.46 paid 26/06/2018
    RES13

    Soddisfazione dell'onere 030759460023 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 030759460024 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 ott 2017

    44 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di FLEETS POINT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BALFOUR, Michael William
    1belvedere House 6 Mckinley Road
    BH4 8AQ Bournemouth
    Dorset
    Segretario
    1belvedere House 6 Mckinley Road
    BH4 8AQ Bournemouth
    Dorset
    British36866470002
    CADD, Susan Anne
    Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    Verde
    England
    Segretario
    Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    Verde
    England
    British82401780001
    LONDON LAW SECRETARIAL LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Segretario nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001510001
    BALFOUR, Michael William
    11 Bury Road
    BH13 7DD Poole
    Dorset
    Amministratore
    11 Bury Road
    BH13 7DD Poole
    Dorset
    British36866470005
    BAMFORD, Stephen James
    Glengarden Farmleigh Grove
    Burwood Park
    KT12 5BU Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    Glengarden Farmleigh Grove
    Burwood Park
    KT12 5BU Walton On Thames
    Surrey
    British47964750001
    BICKLE, Justin Andrew
    Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    27
    United Kingdom
    Amministratore
    Knightsbridge
    SW1X 7LY London
    27
    United Kingdom
    EnglandBritish112506210002
    BODDY, Peter Ashley
    The Old Rectory
    Church Hill Road
    LE16 7SN Cranoe
    Leicestershire
    Amministratore
    The Old Rectory
    Church Hill Road
    LE16 7SN Cranoe
    Leicestershire
    EnglandBritish101072960001
    BROOMBERG, Barry Alan
    Fleet Point
    Verde 10 Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    Oaktree Capital Management Llp
    England
    Amministratore
    Fleet Point
    Verde 10 Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    Oaktree Capital Management Llp
    England
    United KingdomBritish207557180001
    BYNG MADDICK, Zillah
    Russet House
    14 Claremont Gardens
    SL7 1BS Slough
    Amministratore
    Russet House
    14 Claremont Gardens
    SL7 1BS Slough
    EnglandBritish118619550001
    CARTWRIGHT, Nigel Ronald
    Staithe The Causeway
    KT10 0NE Claygate
    Surrey
    Amministratore
    Staithe The Causeway
    KT10 0NE Claygate
    Surrey
    United KingdomBritish51888080001
    CHESTER, Ross
    Compass Court
    42/44 Winn Road
    SO17 1EQ Southampton
    Amministratore
    Compass Court
    42/44 Winn Road
    SO17 1EQ Southampton
    British121959520001
    CHILD, Colin Charles
    Waterside House
    Headbourne Worthy
    SO23 7JR Winchester
    Hants
    Amministratore
    Waterside House
    Headbourne Worthy
    SO23 7JR Winchester
    Hants
    EnglandBritish125146440001
    DENNING, Edward John
    Lowder Mill
    Bell Vale Lane
    GU27 3DJ Haselmere
    Surrey
    Amministratore
    Lowder Mill
    Bell Vale Lane
    GU27 3DJ Haselmere
    Surrey
    United KingdomBritish5755650002
    ENOCH, Melvyn Stuart
    9 Aylmer Drive
    HA7 3EJ Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    9 Aylmer Drive
    HA7 3EJ Stanmore
    Middlesex
    British57420500001
    FEINGOLD, Limor
    23 Elms Avenue
    BH14 8EE Poole
    Dorset
    Amministratore
    23 Elms Avenue
    BH14 8EE Poole
    Dorset
    British109022770001
    FEINGOLD, Limor
    4 Moriconium Quay
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    Amministratore
    4 Moriconium Quay
    BH15 4QP Poole
    Dorset
    British99858900001
    GOLDSMITH, Walter Kenneth
    21 Ashurst Close
    HA6 1EL Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    21 Ashurst Close
    HA6 1EL Northwood
    Middlesex
    British10845240002
    GUSCOTT, Malcolm Sinclair
    6 Mckinley Road
    BH4 8AQ Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    6 Mckinley Road
    BH4 8AQ Bournemouth
    Dorset
    British47529000005
    KENGELBACH, Jan
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    Amministratore
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    EnglandGerman166791090001
    LIGHT, Craig Jonathan
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    Amministratore
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    EnglandBritish175309730001
    MCGOLDRICK, James Edward
    Morfelderlandstr 265
    FOREIGN Frankfurt
    60598
    Germany
    Amministratore
    Morfelderlandstr 265
    FOREIGN Frankfurt
    60598
    Germany
    American86450530001
    METCALF, Michael Edward
    Tanglewood 19 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    Amministratore
    Tanglewood 19 Meadway
    KT10 9HG Esher
    Surrey
    EnglandBritish61013220001
    NEWMAN, Timothy Carlo
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    Amministratore
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    EnglandBritish133499820001
    NEWMAN, Timothy Carlo
    Charlton Marshall
    DT11 9NE Blandford
    Newlands Manor House
    Dorset
    Amministratore
    Charlton Marshall
    DT11 9NE Blandford
    Newlands Manor House
    Dorset
    EnglandBritish133499820001
    PEARCE, Christopher Donovan James
    Pembridge House
    Pachesham Park
    KT22 0DJ Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Pembridge House
    Pachesham Park
    KT22 0DJ Leatherhead
    Surrey
    United KingdomBritish20666800004
    PHILLIPS, Sean
    39 Western Avenue
    Branscote Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    Amministratore
    39 Western Avenue
    Branscote Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    American44839890004
    STEVENS, Paul Richard
    Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    Verde
    England
    Amministratore
    Bressenden Place
    SW1E 5DH London
    Verde
    England
    EnglandBritish186050040001
    TATTON-BROWN, Duncan Eden
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    Amministratore
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    EnglandBritish149245720001
    WAGGETT, Colin Douglas
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    Amministratore
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    EnglandBritish104154090003
    WARTIG, John Michael
    Willis Way
    BH15 3SY Poole
    52
    England
    Amministratore
    Willis Way
    BH15 3SY Poole
    52
    England
    EnglandAustralian178768810001
    WILLIAMS, Jeremy David
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    Amministratore
    58 Fleets Lane
    Poole
    BH15 3BT Dorset
    United KingdomBritish121982220002
    WILLIAMS, Jeremy David
    Witchampton
    BH21 5AR Wimborne
    Welcombe Thatch
    Amministratore
    Witchampton
    BH21 5AR Wimborne
    Welcombe Thatch
    United KingdomBritish121982220002
    LONDON LAW SERVICES LIMITED
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    Amministratore delegato nominato
    84 Temple Chambers
    Temple Avenue
    EC4Y 0HP London
    900001500001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FLEETS POINT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Moraylimited
    Fleets Lane
    BH15 3BT Poole
    58
    England
    06 apr 2016
    Fleets Lane
    BH15 3BT Poole
    58
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngalnd And Wales
    Numero di registrazione4698751
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    FLEETS POINT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 25 apr 2014
    Consegnato il 06 mag 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 06 mag 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 ott 2016Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 15 ago 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 25 apr 2014
    Consegnato il 06 mag 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited as Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 06 mag 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 dic 2015Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    • 15 ago 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 06 set 2013
    Consegnato il 17 set 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wilmington Trust (London) Limited (and Its Successors in Title, Pemitted Assigns and Permitted Transferees)
    Transazioni
    • 17 set 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 26 apr 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 06 set 2013
    Consegnato il 17 set 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Trademark id: 36447 country UK reg no 2111128, 43481 country european union reg no 898734, 43481AT country austria reg no 898734, for details of further trademarks please refer to the document image. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wilmington Trust (London) Limited (and Its Successors in Title, Permitted Assigns and Permitted Transferees)
    Transazioni
    • 17 set 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 26 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge of deposit
    Creato il 01 ago 2012
    Consegnato il 07 ago 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All amounts now and in the future credited to account numbers 550/00/31194249 and 28424301 with the bank.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 apr 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Confirmation and amendment agreement
    Creato il 14 dic 2010
    Consegnato il 23 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the pledgees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Th shares being the two shares in the amount of eur 25,000.00 and eur 2,475,000.00 together with all ancillary rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mizuho Corparate Bank, LTD (In Its Capacity as Security Agent)
    Transazioni
    • 23 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Pledge agreement
    Creato il 14 mar 2008
    Consegnato il 26 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A first ranking pledge over the shares and all future shares see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mizuho Corporate Bank, LTD ( as Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 26 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    An agreement and deed of pledge of shares
    Creato il 17 ago 2007
    Consegnato il 01 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All present and future shares and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mizuho Corporate Bank, LTD (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 01 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Share pledge agreement
    Creato il 31 gen 2006
    Consegnato il 13 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the pledgees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charging company pledged to the pledgees all of its shares in the company being the share capital held by the charging company of one share of dem 636,000.00 and the share capital of dem 9,964,000.00 held by pledgor 2 consisting of 9 shares in the nominal amount of dem 62,500.00, dem 12,500.00, dem 905,000.00, dem 12,500.00, dem 37,500.00, dem 770,000.00, dem 990,000.00, dem 520,000.00 and dem 6,654,000.00 (together with any future shares of the pledgors) and all present and future rights attached to the shares.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mizuho Corporate Bank, LTD as Security Agent for the Finance Parties
    Transazioni
    • 13 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Agreement and deed of pledge of shares
    Creato il 31 gen 2006
    Consegnato il 10 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Five thousand issued and outstanding shares numbered 1 up to and including 5000 each with a nominal capital of one hundred euro (eur 100) in the share capital of the company and registered in the name of the charging company and all dividends and distributions in respect of the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mizuho Corporate Bank, LTD (In Its Capacity as Security Agent for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 10 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Share pledge agreement
    Creato il 31 gen 2006
    Consegnato il 13 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the pledgees on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charging company pledged to the pledgee all of its shares in the company being the share capital of eur 2,500,000.00 of the company consisting of two shares in the amount of eur 25,000.00 and eur 2,475,000.00 held by the charging company (together with any future shares of the charging company after the charge date) and all present and future rights attached to the shares.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mizuho Corporate Bank, LTD as Security Agent for the Finance Parties
    Transazioni
    • 13 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession and charge
    Creato il 30 gen 2006
    Consegnato il 10 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title and interest in respect of sums payable pursuant to the insurance policies all rights title and interest in respect of the hedging agreements and all rights title and interest in resp. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mizuho Corporate Bank, LTD (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 10 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 01 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Share mortgage
    Creato il 30 gen 2006
    Consegnato il 10 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares the additional rights and the designated account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mizuho Corporate Bank, LTD (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 10 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Share charge
    Creato il 30 gen 2006
    Consegnato il 10 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    1,895,316 shares of hk$1 each in the issued share capital of the company and the derivative assets owned by the charging company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mizuho Corporate Bank, LTD (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 10 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge agreement
    Creato il 30 gen 2006
    Consegnato il 10 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The 18,128,482 registered shares in the company owned by the charging company from the pledge date any and all rights to aquire shares in the capital of the company which rights the charging company has at the pledge date and any and all other rights pertaining to the shares from the pledge date including the right to receive all interest and dividend rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mizuho Corporate Bank, LTD (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 10 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 09 ott 2003
    Consegnato il 21 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Legal mortgage all the land fixed charge all ,plant and machinery, rental and other income, investments, rights under insurances, goodwill and uncalled capital, intellectual property, agreements and licences, trade secrets, confidential information and know-how, rights and causes of action in respect of infringements, book and other debts, claims against third parties, negotiable instruments, claims in any pension fund, monies standing to any realisation account, rights over land, floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 21 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 25TH july 2003 and
    Creato il 24 giu 2003
    Consegnato il 08 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each and any chargor to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the l/h interest in the east side of cathcart road glasgow t/n GLA110299.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share mortgage
    Creato il 24 giu 2003
    Consegnato il 08 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All present and future shares and new rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent)
    Transazioni
    • 08 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share charge
    Creato il 24 giu 2003
    Consegnato il 08 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The security assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent)
    Transazioni
    • 08 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession and supplemental charge supplemental to a debenture dated 10 april 2003 and
    Creato il 24 giu 2003
    Consegnato il 04 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the charging company to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (In Its Capacity as Security Agent)
    Transazioni
    • 04 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share pledge agreement
    Creato il 23 giu 2003
    Consegnato il 14 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the parent, the company and or all other obligors to the pledgee and/or the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All shares of the pledging company including all present and future rights attached to the shares.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(In Its Capacity as Security Agent)
    Transazioni
    • 14 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 21 giu 1999
    Consegnato il 08 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the financing documents including the guarantee and debenture
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 291298
    Creato il 01 dic 1998
    Consegnato il 07 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The tenant's interest under the lease between the city of glasgow district council and shoprite limited dated 22 september and 3 october 1984 and now registered in the land register of scotland under title number GLA110299 of premises comprising 1.6 hectares at cathcart road, glasgow.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 17 dic 1997
    Consegnato il 22 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0