JUNCTION BRAND COMMUNICATIONS LTD

JUNCTION BRAND COMMUNICATIONS LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJUNCTION BRAND COMMUNICATIONS LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03076510
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JUNCTION BRAND COMMUNICATIONS LTD?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova JUNCTION BRAND COMMUNICATIONS LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Players House
    300 Attercliffe Common
    S9 2AG Sheffield
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JUNCTION BRAND COMMUNICATIONS LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JUNCTION ADVERTISING GROUP LIMITED28 lug 199828 lug 1998
    JUNCTION 22 LIMITED06 lug 199506 lug 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di JUNCTION BRAND COMMUNICATIONS LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per JUNCTION BRAND COMMUNICATIONS LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Indirizzo della sede legale modificato da Arclite House Century Road Peatmoor Swindon SN5 5YN United Kingdom in data 06 mar 2013

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Michael Sprot come segretario in data 01 mar 2013

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Katharine Sarah Mcintyre come amministratore in data 01 mar 2013

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Katharine Sarah Mcintyre come segretario in data 01 mar 2013

    1 pagineTM02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Andrew Robert Gardner come amministratore in data 04 dic 2012

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Charles Friedrich Buddery come amministratore in data 04 dic 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Katharine Sarah Mcintyre come amministratore in data 01 giu 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Katharine Sarah Mcintyre come segretario in data 01 giu 2012

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Keith John Sadler come amministratore in data 31 lug 2012

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Keith John Sadler come segretario in data 31 lug 2012

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 17 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 lug 2012

    Stato del capitale al 19 lug 2012

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 17 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Stato del capitale al 26 apr 2011

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 17 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di JUNCTION BRAND COMMUNICATIONS LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SPROT, Michael
    300 Attercliffe Common
    S9 2AG Sheffield
    Players House
    United Kingdom
    Segretario
    300 Attercliffe Common
    S9 2AG Sheffield
    Players House
    United Kingdom
    176378960001
    GARDNER, Andrew Robert
    300 Attercliffe Common
    S9 2AG Sheffield
    Players House
    United Kingdom
    Amministratore
    300 Attercliffe Common
    S9 2AG Sheffield
    Players House
    United Kingdom
    EnglandBritish174126740001
    BIRCH, Sarah
    20 Middle Dean Street
    Greetland
    HX4 8DP Halifax
    Segretario
    20 Middle Dean Street
    Greetland
    HX4 8DP Halifax
    British83176670001
    GUEST, Sarah Elizabeth
    Coopers Close
    OX33 1UA Littleworth
    24
    Oxford
    Segretario
    Coopers Close
    OX33 1UA Littleworth
    24
    Oxford
    British158967330001
    LIGHTOWLER, Sharon Louise
    15 Briarfield Gardens
    HD5 9JN Huddersfield
    West Yorkshire
    Segretario
    15 Briarfield Gardens
    HD5 9JN Huddersfield
    West Yorkshire
    British97723000001
    MARSDEN, Helen Elizabeth
    The Grange
    Thunderbridge, Kirkburton
    HD8 0BX Huddersfield
    West Yorkshire
    Segretario
    The Grange
    Thunderbridge, Kirkburton
    HD8 0BX Huddersfield
    West Yorkshire
    British44051010003
    MCINTYRE, Katharine Sarah
    Century Road
    Peatmoor
    SN5 5YN Swindon
    Arclite House
    United Kingdom
    Segretario
    Century Road
    Peatmoor
    SN5 5YN Swindon
    Arclite House
    United Kingdom
    171838740001
    MILLINGTON, John Robert
    16 Hallam Grange Crescent
    Fulwood
    S10 4BA Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    16 Hallam Grange Crescent
    Fulwood
    S10 4BA Sheffield
    South Yorkshire
    British9206850001
    MINNS, Gregory Leslie John
    113 Paddick Drive
    RG6 4HF Lower Earley
    Berkshire
    Segretario
    113 Paddick Drive
    RG6 4HF Lower Earley
    Berkshire
    British72170360001
    SADLER, Keith John
    3 Clifton High Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TU Bristol
    Segretario
    3 Clifton High Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TU Bristol
    British73173100007
    YORK PLACE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Segretario nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000880001
    BUDDERY, Charles Friedrich
    407 Whirlowdale Road
    S11 9NF Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    407 Whirlowdale Road
    S11 9NF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish16566660003
    DUFFY, Simon
    Flat A 113 Egerton Road North
    Chorlton
    M16 0BR Manchester
    Amministratore
    Flat A 113 Egerton Road North
    Chorlton
    M16 0BR Manchester
    British44372230001
    JONES, Sharon
    Flat A 113 Egerton Road North
    Chorlton
    M16 0BR Manchester
    Amministratore
    Flat A 113 Egerton Road North
    Chorlton
    M16 0BR Manchester
    British44372420001
    KAYE, Nigel
    28 Victoria Road
    M33 3HY Sale
    Cheshire
    Amministratore
    28 Victoria Road
    M33 3HY Sale
    Cheshire
    British44372510001
    MARSDEN, Helen Elizabeth
    The Grange
    Thunderbridge, Kirkburton
    HD8 0BX Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Grange
    Thunderbridge, Kirkburton
    HD8 0BX Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish44051010003
    MCINTYRE, Katharine Sarah
    Century Road
    Peatmoor
    SN5 5YN Swindon
    Arclite House
    United Kingdom
    Amministratore
    Century Road
    Peatmoor
    SN5 5YN Swindon
    Arclite House
    United Kingdom
    EnglandBritish53459600006
    MILLINGTON, John Robert
    16 Hallam Grange Crescent
    Fulwood
    S10 4BA Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    16 Hallam Grange Crescent
    Fulwood
    S10 4BA Sheffield
    South Yorkshire
    British9206850001
    RANDALL, Adam Mark
    Millbarn 27 Clay Well
    Golcar
    HD7 4JD Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Millbarn 27 Clay Well
    Golcar
    HD7 4JD Huddersfield
    West Yorkshire
    British63429060001
    SADLER, Keith John
    3 Clifton High Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TU Bristol
    Amministratore
    3 Clifton High Grove
    Stoke Bishop
    BS9 1TU Bristol
    EnglandBritish73173100007
    SHAW, Darren Malcolm
    3 Wrigley Court
    Netherton
    HD4 7ED Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    3 Wrigley Court
    Netherton
    HD4 7ED Huddersfield
    West Yorkshire
    British44050920005
    YORK PLACE COMPANY NOMINEES LIMITED
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore delegato nominato
    12 York Place
    LS1 2DS Leeds
    West Yorkshire
    900000870001

    JUNCTION BRAND COMMUNICATIONS LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture deed
    Creato il 17 apr 2000
    Consegnato il 20 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 20 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 07 set 1999
    Consegnato il 25 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The leasehold property known as outlane primary school new hey road huddersfield west yorkshire title number WYK639807. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit agreement to secure own liabilities
    Creato il 31 ago 1999
    Consegnato il 09 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The account with the bank denominated in sterling designated premier interest account number 6237885.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0