OAKGATE PROPERTIES LIMITED

OAKGATE PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOAKGATE PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03077617
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OAKGATE PROPERTIES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova OAKGATE PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Castlegarth Grange
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OAKGATE PROPERTIES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    LANDCLASS LIMITED10 lug 199510 lug 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di OAKGATE PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per OAKGATE PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Oakgate House 25 Market Place Wetherby West Yorkshire LS22 6LQ a Castlegarth Grange Scott Lane Wetherby LS22 6LH in data 12 mag 2017

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 mar 2017 al 31 ago 2017

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di John David Grantham come amministratore in data 16 gen 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 lug 2015

    Stato del capitale al 29 lug 2015

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John David Grantham il 01 gen 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Edward France il 01 gen 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Caddick il 01 gen 2015

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    1 pagineAA

    Nomina di Mr Paul Andrew Bullers come segretario in data 20 gen 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Peter Graham Hirst come amministratore in data 20 gen 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Paul Andrew Bullers come amministratore in data 20 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Graham Hirst come segretario in data 20 gen 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 10 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 lug 2014

    Stato del capitale al 25 lug 2014

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 29 lug 2013

    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    1 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    1 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di OAKGATE PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BULLERS, Paul Andrew
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    Segretario
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    194298910001
    BULLERS, Paul Andrew
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    Amministratore
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    EnglandBritish155801480001
    CADDICK, Paul
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    Amministratore
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    United KingdomBritish2288420001
    FRANCE, Richard Edward
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    Amministratore
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    England
    United KingdomBritish56208840002
    HIRST, Peter Graham
    The Coach House
    Outwood Lane Horsforth
    LS18 4HR Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    The Coach House
    Outwood Lane Horsforth
    LS18 4HR Leeds
    West Yorkshire
    British32603370002
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    Segretario nominato
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003220001
    GRANTHAM, John David
    Oakgate House
    25 Market Place
    LS22 6LQ Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Oakgate House
    25 Market Place
    LS22 6LQ Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritish48928850002
    HIRST, Peter Graham
    The Coach House
    Outwood Lane Horsforth
    LS18 4HR Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Coach House
    Outwood Lane Horsforth
    LS18 4HR Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish32603370002
    LUCIENE JAMES LIMITED
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    Amministratore delegato nominato
    83 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    900003210001

    Chi sono le persone con controllo significativo di OAKGATE PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Caddick Group Plc
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    West Yorkshire
    England
    06 apr 2016
    Scott Lane
    LS22 6LH Wetherby
    Castlegarth Grange
    West Yorkshire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione02065043
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    Oakgate Group Plc
    Market Place
    LS22 6LQ Wetherby
    Oakgate House
    West Yorkshire
    England
    06 apr 2016
    Market Place
    LS22 6LQ Wetherby
    Oakgate House
    West Yorkshire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland
    Numero di registrazione03055772
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% delle azioni della società.

    OAKGATE PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed
    Creato il 08 lug 1999
    Consegnato il 21 lug 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group member to the chargee as trustee for itself and any other lender or any lender supplemental to the legal charge dated 19 december 1997
    Brevi particolari
    7 blake street york together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 21 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental deed
    Creato il 18 gen 1999
    Consegnato il 29 gen 1999
    In corso
    Importo garantito
    All moneys and indebtedness due from and all moneys covenanted to be paid by any group member to norwich union mortgage finance limited as trustee for itself and any other lender supplemental to the legal charge dated 19TH december 1997
    Brevi particolari
    Stonegate walk stonegate york-NYK11567 together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fitting thereon.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 29 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of assignment
    Creato il 23 dic 1998
    Consegnato il 09 gen 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company and or all or any of the other companies named therein ("group member") to the chargees on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies from time to time due or owing or incured to the company under the occupational leases in respect of 26,28 and 30 stonegate york t/no's;-NYK29311. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited(as Trustee for Itself and the Other Lenders)
    Transazioni
    • 09 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental deed
    Creato il 23 dic 1998
    Consegnato il 09 gen 1999
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any group member to the chargees supplemental to the legal charge dated 19TH december 1997 between oakgate group PLC and norwich union mortgage finance limited
    Brevi particolari
    26,28 and 30 stonegate york t/no;-NYK29311 together with all buildings fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) fixed plant and machinery all improvements and additions thereto benefits under all leases and licences in relation to the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited(As Trustee for Itself and Any Other Lenders from Time to Time)
    Transazioni
    • 09 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental deed of charge
    Creato il 13 mag 1998
    Consegnato il 22 mag 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge which is supplemental to the principal deed dated 19TH december 1997
    Brevi particolari
    F/H property k/a units e,f and g 25/27 market place wetherby west yorkshire together with all buildings erections and fixtures (including trade but excluding tenant's fixtures) fixed plant machinery all improvements and additions thereto all rights and licences benefits of all leases underleases tenancies agreements to lease covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance and floating charge the whole of the company's undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 22 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    Memorandum of cash deposit
    Creato il 19 nov 1996
    Consegnato il 05 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Initial deposit of £280,000 credited to acct/no 00219229 with the bank and any addition to that deposit in any currency.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of deposit
    Creato il 15 ott 1996
    Consegnato il 23 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The amount from time to time standing to the credit of account number 00219210 with the bank and any deposit from time to time of the company with the bank of any other currency description designation or numbering etc.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of cash deposit
    Creato il 15 ott 1996
    Consegnato il 23 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The amount from time to time standing to the credit of account number 00219237 with the bank and any deposit from time to time of the company with the bank of any other currency description designation or numbering etc.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 15 ott 1996
    Consegnato il 23 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 15 ott 1996
    Consegnato il 23 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 7 - 11 trinity street (formerly k/a the ostlers arms) leeds t/no wyk 521321 with the goodwill of the business and proceeds of any insurance. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0