FTM TYREFIT LIMITED
Panoramica
| Nome della società | FTM TYREFIT LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03078330 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di FTM TYREFIT LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova FTM TYREFIT LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Bridgewater Place Water Lane LS11 5DY Leeds Yorkshire United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di FTM TYREFIT LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| FTM LIMITED | 03 ott 1995 | 03 ott 1995 |
| APPLYGENTLE LIMITED | 11 lug 1995 | 11 lug 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di FTM TYREFIT LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per FTM TYREFIT LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 05 lug 2012
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 24 apr 1998
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 mar 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2011 al 31 mar 2012 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Kazushi Ogura come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Kenji Murai come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Healy come segretario | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Fraser come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Healy come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ian Vincent Ellis come segretario | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 mar 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 3 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB in data 02 ago 2010 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 mar 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Michael Joseph Anthony Healy il 20 ott 2009 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Michael Joseph Anthony Healy il 20 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ian Ellis Fraser il 20 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008 | 4 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di FTM TYREFIT LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLIS, Ian Vincent | Segretario | Water Lane LS11 5DY Leeds Bridgewater Place Yorkshire United Kingdom | British | 162127580001 | ||||||
| MURAI, Kenji | Amministratore | Water Lane LS11 5DY Leeds Bridgewater Place Yorkshire United Kingdom | England | Japanese | 95702340002 | |||||
| OGURA, Kazushi | Amministratore | Water Lane LS11 5DY Leeds Bridgewater Place Yorkshire United Kingdom | England | Japanese | 150485750001 | |||||
| HEALY, Michael Joseph Anthony | Segretario | East Main Street EH52 5AS Broxburn 216 West Lothian | British | 99111340001 | ||||||
| JAMES, Martyn Keith | Segretario | 81 Parkstone Avenue Parkstone BH14 9LW Poole Dorset | British | 10697770001 | ||||||
| JUDDERY, John William Henry | Segretario | Apartment 11 High Point 76 Bournemouth Road BH14 0EY Poole Dorset | British | 5986560001 | ||||||
| MASKELL, Philip John | Segretario | Church Field Fawley RG9 6HZ Henley On Thames Oxfordshire | British | 5733160003 | ||||||
| MCGILL, Kenneth Andrew | Segretario | 4 Peastonbank Farm Cottages By Pencaitland EH34 5ET Tranent East Lothian | British | 41923940001 | ||||||
| MORRISON, Scott | Segretario | 24 Gaveston Road CV32 6EU Leamington Spa Warwickshire | British | 99297890001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BATESON, Dominic Clive | Amministratore | 2 Norden Meadows SL6 4SB Maidenhead Berkshire | United Kingdom | British | 98910740001 | |||||
| BISSETT, Graeme | Amministratore | 123 Saint Vincent Street G2 5EA Glasgow | British | 79800380001 | ||||||
| BRIDGMAN, Michael | Amministratore | Broomfield Lodge Broomfield Park Sunningdale SL5 0JS Ascot Berkshire | British | 74833800001 | ||||||
| FRASER, Ian Ellis | Amministratore | East Main Street EH52 5AS Broxburn 216 West Lothian | Scotland | Uk | 28393850006 | |||||
| HARRIS, Frances | Amministratore | 19 Herm Road Parkstone BH12 4LE Poole Dorset | British | 46118500001 | ||||||
| HEALY, Michael Joseph Anthony | Amministratore | East Main Street EH52 5AS Broxburn 216 West Lothian | United Kingdom | British | 99111340001 | |||||
| HOLMES, Peter Robert | Amministratore | Kerfield Cottage Innerleithen Road EH45 8BG Peebles Peeblesshire | British | 28829540001 | ||||||
| JAMES, Martyn Keith | Amministratore | 81 Parkstone Avenue Parkstone BH14 9LW Poole Dorset | British | 10697770001 | ||||||
| LEWIS, Ivor | Amministratore | 6 Wentworth Close WA8 9JF Widnes Cheshire | British | 34800310001 | ||||||
| LOCHERY, Anthony Francis | Amministratore | 85 Ravelston Dykes EH12 6EZ Edinburgh Midlothian | England | British | 18996670003 | |||||
| MASKELL, Philip John | Amministratore | Church Field Fawley RG9 6HZ Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 5733160003 | |||||
| MASON, Dale John | Amministratore | 17 Springdale Road BH18 9BN Broadstone Dorset | British | 10697780002 | ||||||
| MCGILL, Kenneth Andrew | Amministratore | 4 Peastonbank Farm Cottages By Pencaitland EH34 5ET Tranent East Lothian | British | 41923940001 | ||||||
| OWENS, Stanley Hart | Amministratore | 15b Ewerland Barnton EH4 6DH Edinburgh | American | 75755850002 | ||||||
| PARKER, Kevin Neil | Amministratore | 2 Guy Close Stapleford NG9 7GZ Nottingham Nottinghamshire | British | 45659780001 | ||||||
| PARKER, Timothy Charles | Amministratore | East Main Street EH52 5AS Broxburn 216 West Lothian | United Kingdom | British | 126476060001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
FTM TYREFIT LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Composite guarantee and charge | Creato il 12 apr 2000 Consegnato il 27 apr 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities due or to become due from each charging company to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries (as defined)) (the "security trustee") and all costs charges and expenses properly incurred by the chargee in connection with the preparation and negotiation of the banking documents | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Chattel mortgage | Creato il 04 dic 1999 Consegnato il 10 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All present and future right title and interest in the plant machinery chattels or other equipment described in schedule 2 to the mortgage the benefit of any guarantee warranty or other obligations in relation to the mortgaged chattels. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge over account balances | Creato il 04 dic 1999 Consegnato il 10 dic 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All monies from time to time held to the credit of each company listed in schedule 1 to the deed by the bank on any current deposit or other account or accounts which the company may have with lloyds tsb bank PLC. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of adherence to a composite guarantee and debenture (the "original debenture") | Creato il 24 apr 1998 Consegnato il 09 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any group company (as defined) to the chargee as security trustee for the security beneficiaries (as defined therein) on any account whatsoever whether pursuant to the guarantee (as defined) or otherwise and under the terms of the "original debenture" | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of adherence to a composite guarantee and debenture dated 9 august 1996 and | Creato il 24 apr 1998 Consegnato il 09 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All indebtedness,liabilities and obligations which are due or to become due from any group company to the security beneficiaries in any manner whatsoever whether pursuant to the guarantee or otherwise including all liabilities incurred by the security beneficiaries at the request of any group company in connection with foreign exchange transactions,acceptances,discounting or otherwise or under guarantees,bonds,indemnities,documentary or other credits or any instruments whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 17 lug 1996 Consegnato il 22 lug 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0