FTM TYREFIT LIMITED

FTM TYREFIT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFTM TYREFIT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03078330
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FTM TYREFIT LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova FTM TYREFIT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Yorkshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FTM TYREFIT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FTM LIMITED03 ott 199503 ott 1995
    APPLYGENTLE LIMITED11 lug 199511 lug 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di FTM TYREFIT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per FTM TYREFIT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 05 lug 2012

    • Capitale: GBP 2,184,155.00
    4 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Allotment of 2,184153 shares 28/09/2012
    RES13

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 24 apr 1998

    • Capitale: GBP 2,184,155.00
    4 pagineSH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Bilancio annuale redatto al 11 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2011 al 31 mar 2012

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Nomina di Mr Kazushi Ogura come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Kenji Murai come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Healy come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Ian Fraser come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Healy come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Ian Vincent Ellis come segretario

    3 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 11 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB in data 02 ago 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 11 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Michael Joseph Anthony Healy il 20 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Michael Joseph Anthony Healy il 20 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Ellis Fraser il 20 ott 2009

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2008

    4 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di FTM TYREFIT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ELLIS, Ian Vincent
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    British162127580001
    MURAI, Kenji
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandJapanese95702340002
    OGURA, Kazushi
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandJapanese150485750001
    HEALY, Michael Joseph Anthony
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Segretario
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    British99111340001
    JAMES, Martyn Keith
    81 Parkstone Avenue
    Parkstone
    BH14 9LW Poole
    Dorset
    Segretario
    81 Parkstone Avenue
    Parkstone
    BH14 9LW Poole
    Dorset
    British10697770001
    JUDDERY, John William Henry
    Apartment 11 High Point
    76 Bournemouth Road
    BH14 0EY Poole
    Dorset
    Segretario
    Apartment 11 High Point
    76 Bournemouth Road
    BH14 0EY Poole
    Dorset
    British5986560001
    MASKELL, Philip John
    Church Field
    Fawley
    RG9 6HZ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Segretario
    Church Field
    Fawley
    RG9 6HZ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British5733160003
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Segretario
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    MORRISON, Scott
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    British99297890001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BATESON, Dominic Clive
    2 Norden Meadows
    SL6 4SB Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    2 Norden Meadows
    SL6 4SB Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritish98910740001
    BISSETT, Graeme
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    Amministratore
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    British79800380001
    BRIDGMAN, Michael
    Broomfield Lodge Broomfield Park
    Sunningdale
    SL5 0JS Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Broomfield Lodge Broomfield Park
    Sunningdale
    SL5 0JS Ascot
    Berkshire
    British74833800001
    FRASER, Ian Ellis
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Amministratore
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    ScotlandUk28393850006
    HARRIS, Frances
    19 Herm Road
    Parkstone
    BH12 4LE Poole
    Dorset
    Amministratore
    19 Herm Road
    Parkstone
    BH12 4LE Poole
    Dorset
    British46118500001
    HEALY, Michael Joseph Anthony
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Amministratore
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    United KingdomBritish99111340001
    HOLMES, Peter Robert
    Kerfield Cottage Innerleithen Road
    EH45 8BG Peebles
    Peeblesshire
    Amministratore
    Kerfield Cottage Innerleithen Road
    EH45 8BG Peebles
    Peeblesshire
    British28829540001
    JAMES, Martyn Keith
    81 Parkstone Avenue
    Parkstone
    BH14 9LW Poole
    Dorset
    Amministratore
    81 Parkstone Avenue
    Parkstone
    BH14 9LW Poole
    Dorset
    British10697770001
    LEWIS, Ivor
    6 Wentworth Close
    WA8 9JF Widnes
    Cheshire
    Amministratore
    6 Wentworth Close
    WA8 9JF Widnes
    Cheshire
    British34800310001
    LOCHERY, Anthony Francis
    85 Ravelston Dykes
    EH12 6EZ Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    85 Ravelston Dykes
    EH12 6EZ Edinburgh
    Midlothian
    EnglandBritish18996670003
    MASKELL, Philip John
    Church Field
    Fawley
    RG9 6HZ Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Church Field
    Fawley
    RG9 6HZ Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish5733160003
    MASON, Dale John
    17 Springdale Road
    BH18 9BN Broadstone
    Dorset
    Amministratore
    17 Springdale Road
    BH18 9BN Broadstone
    Dorset
    British10697780002
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Amministratore
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    OWENS, Stanley Hart
    15b Ewerland
    Barnton
    EH4 6DH Edinburgh
    Amministratore
    15b Ewerland
    Barnton
    EH4 6DH Edinburgh
    American75755850002
    PARKER, Kevin Neil
    2 Guy Close
    Stapleford
    NG9 7GZ Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    2 Guy Close
    Stapleford
    NG9 7GZ Nottingham
    Nottinghamshire
    British45659780001
    PARKER, Timothy Charles
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Amministratore
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    United KingdomBritish126476060001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    FTM TYREFIT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and charge
    Creato il 12 apr 2000
    Consegnato il 27 apr 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each charging company to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries (as defined)) (the "security trustee") and all costs charges and expenses properly incurred by the chargee in connection with the preparation and negotiation of the banking documents
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 apr 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 04 dic 1999
    Consegnato il 10 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All present and future right title and interest in the plant machinery chattels or other equipment described in schedule 2 to the mortgage the benefit of any guarantee warranty or other obligations in relation to the mortgaged chattels. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge over account balances
    Creato il 04 dic 1999
    Consegnato il 10 dic 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies from time to time held to the credit of each company listed in schedule 1 to the deed by the bank on any current deposit or other account or accounts which the company may have with lloyds tsb bank PLC.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 dic 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of adherence to a composite guarantee and debenture (the "original debenture")
    Creato il 24 apr 1998
    Consegnato il 09 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness liabilities and obligations due or to become due from any group company (as defined) to the chargee as security trustee for the security beneficiaries (as defined therein) on any account whatsoever whether pursuant to the guarantee (as defined) or otherwise and under the terms of the "original debenture"
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Mezzanine Limited
    Transazioni
    • 09 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of adherence to a composite guarantee and debenture dated 9 august 1996 and
    Creato il 24 apr 1998
    Consegnato il 09 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness,liabilities and obligations which are due or to become due from any group company to the security beneficiaries in any manner whatsoever whether pursuant to the guarantee or otherwise including all liabilities incurred by the security beneficiaries at the request of any group company in connection with foreign exchange transactions,acceptances,discounting or otherwise or under guarantees,bonds,indemnities,documentary or other credits or any instruments whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Plcas Security Trustee for the Security Beneficiaries
    Transazioni
    • 09 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 lug 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 17 lug 1996
    Consegnato il 22 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0