REX JOHNSON ONLINE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | REX JOHNSON ONLINE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03078447 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di REX JOHNSON ONLINE LIMITED?
- Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova REX JOHNSON ONLINE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Unit 1 Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di REX JOHNSON ONLINE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CASH-A-CHEQUE (GB) LIMITED | 08 set 1995 | 08 set 1995 |
| WORDPOINT LIMITED | 11 lug 1995 | 11 lug 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di REX JOHNSON ONLINE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per REX JOHNSON ONLINE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 lug 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 giu 2019 al 31 mag 2019 | 1 pagine | AA01 | ||
Cessazione della carica di Alpesh Kumar Patel come amministratore in data 07 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Sheraz Afzal come amministratore in data 07 ott 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Kevin Richard Kaye come amministratore in data 22 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Alpesh Kumar Patel come amministratore in data 22 mar 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2018 | 7 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Tony Deakin come amministratore in data 01 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ England a Unit 1 Castle Marina Road Nottingham NG7 1TN in data 12 set 2018 | 1 pagine | AD01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Lorna Biondi come segretario in data 30 apr 2018 | 1 pagine | TM02 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2017 | 7 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Tony Deakin come amministratore in data 27 feb 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Scott Aaron Cohen come amministratore in data 27 feb 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da C/O Browne Jacobson Llp 15th Floor 6 Bevis Marks London EC3A 7BA England a C/O Browne Jacobson Llp Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ | 1 pagine | AD02 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2016 | 7 pagine | AA | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 6 Bevis Marks London EC3A 7BA a Cardinal House Abbeyfield Road Nottingham NG7 2SZ in data 16 set 2016 | 1 pagine | AD01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2016 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Eric George Erickson come amministratore in data 08 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di REX JOHNSON ONLINE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFZAL, Sheraz | Amministratore | Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham Unit 1 England | United Kingdom | British | 251073350001 | |||||
| BIONDI, Lorna | Segretario | Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House England | 196294160001 | |||||||
| FREEMAN, Lynne Ann | Segretario | Lakeside Litchborough Road Duncote NN12 8AL Towcester Northamptonshire | British | 52719170001 | ||||||
| MCKENZIE, Robbie | Segretario | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | 195401170001 | |||||||
| PRIOR, Mark Lee | Segretario | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | 178139140001 | |||||||
| SALKELD, Ian | Segretario | 30 Felstead Road Wanstead E11 2QJ London | British | 52338990001 | ||||||
| SOKOLOWSKI, Peter John | Segretario | 208 Rively Avenue Collingdale Pennsylvannia 19023 Usa | American | 68054300001 | ||||||
| WALTON, Caroline Debra | Segretario | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | British | 58608750003 | ||||||
| ASHCROFT CAMERON SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004530001 | |||||||
| TABSEC LIMITED | Segretario | Torrington House 47 Holywell Hill AL1 1HD St Albans Hertfordshire | 1677520001 | |||||||
| COHEN, Scott Aaron | Amministratore | Abbeyfield Road NG7 2SZ Nottingham Cardinal House England | United States | American | 209567180001 | |||||
| COOK, Richard Charles | Amministratore | The Cottage 8 Station Road Ivinghoe LU7 9EB Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 25254880001 | ||||||
| CORNWELL, Nicholas Grant | Amministratore | The Old Rectory Rectory Hill, Cranford St Andrews NN14 1HP Kettering Northants | United Kingdom | British | 95585590001 | |||||
| DEAKIN, Tony | Amministratore | Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham Unit 1 England | United Kingdom | British | 210862440001 | |||||
| DORFMAN, Richard Seth | Amministratore | 9 Pleasant Court Medford FOREIGN Newjersey 08055 Usa | American | 67599880001 | ||||||
| ERICKSON, Eric George | Amministratore | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | Usa | Usa | 224104020001 | |||||
| GAYHARDT, Donald Francis | Amministratore | 511 Lynmere Road Brynmawr FOREIGN Pennsylvannia 19010 Usa | United States | American | 67600210001 | |||||
| HETHERINGTON, Cameron John | Amministratore | 3 Barculdie Crescent QLD 4508 Deception Bay Queensland Australia | Australian | 123428110001 | ||||||
| HIBBERD, Roy Wayne | Amministratore | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | Usa | United States | 158609380001 | |||||
| KAYE, Kevin Richard | Amministratore | Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham Unit 1 England | England | British | 257480610001 | |||||
| MAY, Paul Edward | Amministratore | The Old Rectory Bradden NN12 8ED Towcester Northamptonshire | United Kingdom | British | 83046570001 | |||||
| MCLURE, Gordon Stuart Douglas | Amministratore | "The Bails" Boughton Hall Boughton NN2 8SQ Northampton | British | 39434610002 | ||||||
| MILDENSTEIN, Paul | Amministratore | The Barn Redhouse Farm Redhouse Farm Lane CV35 7NZ Beausale 2 Warwickshire | England | British | 158561370001 | |||||
| NORRIS, Terence John | Amministratore | Woodlands Dukes Covert GU19 5HU Bagshot Surrey | United Kingdom | British | 8778080001 | |||||
| PATEL, Alpesh Kumar | Amministratore | Castle Marina Road NG7 1TN Nottingham Unit 1 England | England | British | 193008350001 | |||||
| PICCINI, Silvio Dante | Amministratore | 77 Gracechurch Street EC3V 0AS London 6th Floor | England | American | 129300540002 | |||||
| PRIOR, Mark Lee | Amministratore | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 United Kingdom | Usa | American | 177845480001 | |||||
| SALKELD, Ian | Amministratore | 30 Felstead Road Wanstead E11 2QJ London | British | 52338990001 | ||||||
| WEISS, Jeffrey Allan | Amministratore | Lancaster Avenue Suite 300 19312 Berwyn 1436 Usa | Usa | United States | 151303310006 | |||||
| ASHCROFT CAMERON NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 4 Rivers House Fentiman Walk SG14 1DB Hertford Hertfordshire | 900004520001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di REX JOHNSON ONLINE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash A Cheque Holdings Great Britain Limited | 06 apr 2016 | Bevis Marks EC3A 7BA London 6 Bevis Marks England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
REX JOHNSON ONLINE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Charge of deposit | Creato il 30 ott 2002 Consegnato il 04 nov 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All deposits now and in the future credited to account designation 8706638 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rental deposit deed | Creato il 07 apr 2000 Consegnato il 13 apr 2000 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the underlease of even date | |
Brevi particolari All interest in the rent deposit and the account into which the rent is paid and all money from time to time withdrawn. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over credit balances | Creato il 22 feb 2000 Consegnato il 03 mar 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in relation to a loan note instrument constituting £1,000,000 guaranteed loan notes 2007 dated 22 february 2000 in favour of cash-a-cheque (GB) limited | |
Brevi particolari The sum of £1,000,000 together with interest accrued now or to be held by national westminster bank PLC on an account numbered 8706638 and earmarked or designated by reference to the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Pledge and security agreement | Creato il 15 set 1999 Consegnato il 30 set 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito The payment and performance of its obligations due or to become due from the company to the chargee under the guaranty and guarantor security agreement | |
Brevi particolari All shares in the company all voting and non-voting rights of shares and all cash and non-cash dividends and all other property chattels contracts intangible goods of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 05 mar 1997 Consegnato il 12 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0