D&S (HOLDINGS) LIMITED

D&S (HOLDINGS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàD&S (HOLDINGS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03078957
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di D&S (HOLDINGS) LIMITED?

    • Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a. (10890) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova D&S (HOLDINGS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Tayto Group Limited Princewood Road
    Earlstrees Industrial Estate
    NN17 4AP Corby
    Northamptonshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di D&S (HOLDINGS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GUMTRADE LIMITED12 lug 199512 lug 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di D&S (HOLDINGS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 giu 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per D&S (HOLDINGS) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per D&S (HOLDINGS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Bilancio annuale redatto al 06 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 gen 2016

    Stato del capitale al 07 gen 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale al 21 set 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    12 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 lug 2015

    Stato del capitale al 16 lug 2015

    • Capitale: GBP 3,000,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 28 giu 2014

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    12 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 ago 2014

    Stato del capitale al 05 ago 2014

    • Capitale: GBP 3,000,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 giu 2013

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    12 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 ago 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 19 ago 2013

    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2012

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    12 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 02 lug 2011

    10 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Care of Golden Wonder Limited Princewood Road Earlstrees Industrial Estate Corby Northamptonshire NN17 4AP* in data 24 gen 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    12 pagineAR01

    Bilancio redatto al 03 lug 2010

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    12 pagineAR01

    Bilancio redatto al 04 lug 2009

    14 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    24 pagineMEM/ARTS

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Facilities letter 30/03/2009
    RES13

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    7 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di D&S (HOLDINGS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HUTCHINSON, Stephen Thomas Alexander
    The Old School
    Tandragee Castle Tandragee
    BT62 2AB Co Armagh
    Belfast
    Segretario
    The Old School
    Tandragee Castle Tandragee
    BT62 2AB Co Armagh
    Belfast
    BritishDirector110520890001
    ALLEN, Paul Martin
    3 Malone Valley Park
    Malone Road
    BT9 5PZ Belfast
    Amministratore
    3 Malone Valley Park
    Malone Road
    BT9 5PZ Belfast
    Northern IrelandBritishDirector110520960001
    HUTCHINSON, Raymond Latimer
    151 Lurgan Road
    BT32 4NR Banbridge
    Lenaderg House
    Co Down
    Amministratore
    151 Lurgan Road
    BT32 4NR Banbridge
    Lenaderg House
    Co Down
    Northern IrelandBritishDirector129216420001
    HUTCHINSON, Stephen Thomas Alexander
    The Old School
    Tandragee Castle Tandragee
    BT62 2AB Co Armagh
    Belfast
    Amministratore
    The Old School
    Tandragee Castle Tandragee
    BT62 2AB Co Armagh
    Belfast
    Northern IrelandBritishDirector110520890001
    HUTCHINSON KANE, Anne Alexandra
    Mullavilly
    BT62 2LX Tandragee
    Mullavilly Cottage
    Co Armagh
    Amministratore
    Mullavilly
    BT62 2LX Tandragee
    Mullavilly Cottage
    Co Armagh
    Northern IrelandBritishDirector143582430001
    BARLOW, James Nevile Disney
    Rose Cottage
    12 Barlows Lane Wilbarston
    LE16 8QB Market Harborough
    Leicestershire
    Segretario
    Rose Cottage
    12 Barlows Lane Wilbarston
    LE16 8QB Market Harborough
    Leicestershire
    BritishAccountant49899940001
    LEWIS, Graham John
    Hirilorn
    Harborough Road
    NN6 9JA Maidwell
    Northamptonshire
    Segretario
    Hirilorn
    Harborough Road
    NN6 9JA Maidwell
    Northamptonshire
    British3047470002
    RICHARDSON, Paul
    9 Quadrangle Lodge
    40 Queens Road
    SW19 8LY London
    Segretario
    9 Quadrangle Lodge
    40 Queens Road
    SW19 8LY London
    BritishTrainee Solicitor52177440001
    WENMAN, Barry
    26 Links View
    Abbeyfields
    B62 8SS Halesowen
    West Midlands
    Segretario
    26 Links View
    Abbeyfields
    B62 8SS Halesowen
    West Midlands
    British59179720001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Segretario nominato
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001
    CICUREL, David Elie
    71 Springfield Road
    NW8 0QJ London
    Amministratore
    71 Springfield Road
    NW8 0QJ London
    FrenchCompany Director70056130001
    DAVIES, Linda Anne
    46 Cross Road
    Wimbledon
    SW19 1PF London
    Amministratore
    46 Cross Road
    Wimbledon
    SW19 1PF London
    BritishLawyer51641990001
    FAVRE-BEAULIEU, Nathalie
    29 Delvino Road
    Fulham
    SW6 4AF London
    Amministratore
    29 Delvino Road
    Fulham
    SW6 4AF London
    FrenchInvestor45713660001
    LEWIS, Glenn Ian
    1 Ormond Place
    NN14 1JL Isham
    Northamptonshire
    Amministratore
    1 Ormond Place
    NN14 1JL Isham
    Northamptonshire
    Great BritainBritishCompany Director45713490001
    LEWIS, Graham John
    Hirilorn
    Harborough Road
    NN6 9JA Maidwell
    Northamptonshire
    Amministratore
    Hirilorn
    Harborough Road
    NN6 9JA Maidwell
    Northamptonshire
    BritishDirector3047470002
    MCKINNEY, James
    Coedfa
    Bryn Coch Lane
    CH7 1PS Mold
    Clwyd
    Amministratore
    Coedfa
    Bryn Coch Lane
    CH7 1PS Mold
    Clwyd
    United KingdomBritishManaging Director65943160001
    NIELD, Garry Stephen
    19 Kingsway
    Heswall
    CH60 3SN Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    19 Kingsway
    Heswall
    CH60 3SN Wirral
    Merseyside
    BritishManaging Director62685760001
    PENMAN, Angus Warwick
    7 Red Anchor Close
    Old Church Street Chelsea
    SW3 5DW London
    Amministratore
    7 Red Anchor Close
    Old Church Street Chelsea
    SW3 5DW London
    EnglandBritishInvestor44192700001
    RICHARDSON, Paul
    9 Quadrangle Lodge
    40 Queens Road
    SW19 8LY London
    Amministratore
    9 Quadrangle Lodge
    40 Queens Road
    SW19 8LY London
    BritishTrainee Solicitor52177440001
    C F HOLDINGS LIMITED
    Globe Street
    WS10 0NN Wednesbury
    West Midlands
    Amministratore
    Globe Street
    WS10 0NN Wednesbury
    West Midlands
    60355400001
    CONTINENTAL FOODS LIMITED
    Globe Street
    WS10 0NN Wednesbury
    West Midlands
    Amministratore
    Globe Street
    WS10 0NN Wednesbury
    West Midlands
    59253110002
    NOROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Amministratore delegato nominato
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006410001
    NORTON ROSE LIMITED
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    Amministratore delegato nominato
    Kempson House
    P.O. Box 570, Camomile Street
    EC3A 7AN London
    900006420001

    D&S (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 12 mar 2008
    Consegnato il 15 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited and Ulster Bank Ireland Limited (Together Referred to as the Bank)
    Transazioni
    • 15 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 05 set 2007
    Consegnato il 08 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession and amendment
    Creato il 10 dic 1996
    Consegnato il 19 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each borrower (as defined) and the companies (as defined) to the secured parties (as defined) or any of them under or in connection with the facility agreement (as defined),the overdraft letter (as defined),the natwest loan agreement (as defined),the guarantee and debenture (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC,as Agent and Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 19 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 dic 1995
    Consegnato il 15 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to frederick alan openshaw and anthony scholes as trustees for frederick alan openshaw and anthony scholes settlement trustees (the vendors) under or pursuant to the vendor note (as defined) or the debenture or on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Frederick Alan Openshaw
    • Anthony Scholes
    Transazioni
    • 15 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 dic 1995
    Consegnato il 15 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the facility agreement (as defined) and/or the debenture or on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • First Britannia Mezzanine Capital B.V.
    Transazioni
    • 15 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 dic 1995
    Consegnato il 15 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the facility agreement (as defined),the overdraft letter (as defined) and/or the debenture or on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0