21ST CENTURY VILLAS LIMITED

21ST CENTURY VILLAS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società21ST CENTURY VILLAS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03079721
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 21ST CENTURY VILLAS LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova 21ST CENTURY VILLAS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sterling Ford Centurion Court
    83 Camp Road
    AL1 5JN St Albans
    Herts
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di 21ST CENTURY VILLAS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per 21ST CENTURY VILLAS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 mag 2017

    6 pagineLIQ03

    Soddisfazione dell'onere 18 in pieno

    2 pagineMR04

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni

    3 pagineSH10

    Indirizzo della sede legale modificato da 43 Mornington Road Chingford London E4 7DT a Sterling Ford Centurion Court 83 Camp Road St Albans Herts AL1 5JN in data 31 mag 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 05 mag 2016

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    24 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    4 pagineMR04

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11

    Soddisfazione dell'onere 17 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 19 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 11 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2015

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Michael Howard Goldstein come amministratore in data 14 mar 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Gary Anthony Burns come amministratore in data 14 mar 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 13 lug 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 lug 2015

    Stato del capitale al 16 lug 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 lug 2014

    Stato del capitale al 18 lug 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2013

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di 21ST CENTURY VILLAS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MORNINGTON SECRETARIES LIMITED
    43 Mornington Road
    E4 7DT Chingford
    London
    Segretario
    43 Mornington Road
    E4 7DT Chingford
    London
    87701330001
    BOUETTE, Phillip Andrew
    Odessa Road
    E7 9DX Forest Gate
    165
    London
    England
    Amministratore
    Odessa Road
    E7 9DX Forest Gate
    165
    London
    England
    EnglandEnglishProperty Manger92162110003
    BURNS, Gary Anthony
    83 Camp Road
    AL1 5JN St Albans
    Sterling Ford Centurion Court
    Herts
    Amministratore
    83 Camp Road
    AL1 5JN St Albans
    Sterling Ford Centurion Court
    Herts
    United KingdomBritishProperty Manager153088020003
    GOLDSTEIN, Michael Howard
    83 Camp Road
    AL1 5JN St Albans
    Sterling Ford Centurion Court
    Herts
    Amministratore
    83 Camp Road
    AL1 5JN St Albans
    Sterling Ford Centurion Court
    Herts
    EnglandEnglishChartered Accountant206395540001
    DRAPER, Adam
    Studio 3
    75 Leonard Street
    EC2 London
    Segretario
    Studio 3
    75 Leonard Street
    EC2 London
    BritishSolicitor65719670001
    DRAPER, Grazia Giuliani
    Studio 3
    75 Leonard Street
    EC21 4QS London
    Segretario
    Studio 3
    75 Leonard Street
    EC21 4QS London
    British80017400001
    GIULIANI, Grazia Giuliani
    Flat 3 75 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    Segretario
    Flat 3 75 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    BritishCultural Organiser49067680001
    MURPHY, Simon
    1 Roydon Road
    SG12 8HN Stanstead Abbotts
    Hertfordshire
    Segretario
    1 Roydon Road
    SG12 8HN Stanstead Abbotts
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary67108200002
    BRIGHTON SECRETARY LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    Segretario nominato
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004700001
    MORNINGTON SECRETARIES LIMITED
    43 Mornington Road
    E4 7DT Chingford
    London
    Segretario
    43 Mornington Road
    E4 7DT Chingford
    London
    87701330001
    DRAPER, Adam
    43 Mornington Road
    Chingford
    E4 7DT London
    Amministratore
    43 Mornington Road
    Chingford
    E4 7DT London
    EnglandBritishSolicitor65719670006
    GIULIANI, Grazia Giuliani
    Flat 3 75 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    Amministratore
    Flat 3 75 Leonard Street
    EC2A 4QS London
    BritishCultural Organiser49067680001
    MURPHY, Simon
    1 Roydon Road
    SG12 8HN Stanstead Abbotts
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Roydon Road
    SG12 8HN Stanstead Abbotts
    Hertfordshire
    BritishProperty Manager67108200002
    BRIGHTON DIRECTOR LIMITED
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    Amministratore delegato nominato
    381 Kingsway
    BN3 4QD Hove
    East Sussex
    900004690001

    21ST CENTURY VILLAS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 19 ott 2005
    Consegnato il 07 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat 3, 66 salford road streatham hill london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 set 2005
    Consegnato il 07 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat at 174 croydon road anerley london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 07 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 12 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 7 pyfolds, jamica road, bermondsey, southwark t/n TGL32954. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 12 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 2 bentley court, lambourn road, lambeth, t/n TGL52728. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 12 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 16 homemead, little dimocks, balham, wandsworth t/n TGL32750. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 12 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a flat b, 21 fairmile avenue, streatham, lambeth, t/n SGL487899. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 12 mag 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 57 midmoor road and garden lambeth t/n TGL82866. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 12 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat 1 robin court yalding road southwark t/no SGL466268 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable from any lease, all goodwill, the proceeds of any insurance, all fixtures and fittings not forming part of the property, all plant and machinery, all furniture equipment tools and other goods kept at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 12 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 02 mag 2003
    Consegnato il 10 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    100 a eardley road streatham london SW16. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 15 nov 2000
    Consegnato il 24 nov 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 robin court yalding road london the rental income by way of first fixed charge..the property rights by way of first fixed charge and all of your undertaking and assets by way of floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Paragon Mortgages Limited
    Transazioni
    • 24 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 25 giu 1999
    Consegnato il 30 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 giu 1999
    Consegnato il 30 giu 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    2 bentley court lambourne road clapham london SW9.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 giu 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 mar 1999
    Consegnato il 15 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Property k/a 21 fairmile avenue london SW16. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 mar 1999
    Consegnato il 15 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 ago 1998
    Consegnato il 03 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 57 midmoor road london SW12.. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 ago 1998
    Consegnato il 03 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 03 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 12 nov 1997
    Consegnato il 13 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat 2 bentley court lambourne road clapham london. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 lug 1997
    Consegnato il 26 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 04 apr 1997
    Consegnato il 08 apr 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H flat 16 homemead little dimmocks balham london benefit of all rights licences contracts deeds undertakings assigns of goodwill to the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    21ST CENTURY VILLAS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 mag 2016Inizio della liquidazione
    26 ott 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Phillip Anthony Roberts
    Centurion Court, 83 Camp Road
    AL1 5JN St Albans
    Hertfordshire
    Praticante
    Centurion Court, 83 Camp Road
    AL1 5JN St Albans
    Hertfordshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0