EDGEWATER LODGE LIMITED
Panoramica
Nome della società | EDGEWATER LODGE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Liquidazione |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03085604 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EDGEWATER LODGE LIMITED?
- Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova EDGEWATER LODGE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | C/O Evelyn Partners Llp 45 Gresham Street EC2V 7BG London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EDGEWATER LODGE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
TRACEDALE LIMITED | 31 lug 1995 | 31 lug 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EDGEWATER LODGE LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2018 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2019 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per EDGEWATER LODGE LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 23 giu 2020 |
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 04 ago 2020 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 23 giu 2019 |
Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per EDGEWATER LODGE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Smith & Williamson Llp 25 Moorgate London EC2R 6AY a C/O Evelyn Partners Llp 45 Gresham Street London EC2V 7BG in data 22 mag 2024 | 3 pagine | AD01 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 mar 2024 | 29 pagine | LIQ03 | ||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 mar 2023 | 42 pagine | LIQ03 | ||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||
Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori | 61 pagine | AM22 | ||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore | 69 pagine | AM10 | ||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore | 64 pagine | AM10 | ||
Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione | 3 pagine | AM19 | ||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 5 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 5 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 2 in parte | 5 pagine | MR04 | ||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore | 50 pagine | AM10 | ||
Notifica di approvazione tacita delle proposte | 3 pagine | AM06 | ||
Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA | 11 pagine | AM02 | ||
Cessazione della carica di Benjamin Robert Taberner come amministratore in data 30 giu 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione della proposta dell'amministratore | 65 pagine | AM03 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Norcliffe House Station Road Wilmslow SK9 1BU a C/O Smith & Williamson Llp 25 Moorgate London EC2R 6AY in data 02 apr 2020 | 2 pagine | AD01 | ||
Nomina di un amministratore | 3 pagine | AM01 | ||
Cessazione della carica di Martin William Oliver Healy come amministratore in data 30 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Notifica di Mericourt Limited come persona con controllo significativo il 16 lug 2019 | 2 pagine | PSC02 | ||
Nomina di Mr Martin William Oliver Healy come amministratore in data 18 nov 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Timothy Richard William Hammond come amministratore in data 18 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione di Elli Finance (Uk) Plc come persona con controllo significativo il 30 apr 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||
Modifica dei dettagli di Elli Finance (Uk) Plc come persona con controllo significativo il 17 mag 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Chi sono gli amministratori di EDGEWATER LODGE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTISON, Abigail | Segretario | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | 188568020001 | |||||||
ROYSTON, Maureen Claire, Dr | Amministratore | 45 Gresham Street EC2V 7BG London C/O Evelyn Partners Llp | United Kingdom | British | None | 184190020002 | ||||
BAINES, Philip | Segretario | 97 Hangleton Road BN3 7GH Hove East Sussex | British | 3470830001 | ||||||
BROWNLEE, Sarah Roberta | Segretario | Shalom 59 Tirmacrannon Road Loughgall BT61 8LW Armagh County Armagh | British | Managing Director | 144250780001 | |||||
CARTER, Dianne | Segretario | 1 The Bench Ham Street Ham TW10 7HX Richmond Surrey | British | 46379850001 | ||||||
CROWE, Geoffrey Michael | Segretario | 51 Oakwood Lane Bowdon WA14 3DL Altrincham Cheshire | British | Commercial Diretor | 38256680007 | |||||
KAY, Dominic Jude | Segretario | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | British | Solicitor | 145920530001 | |||||
SIZER, Graham Kevin | Segretario | Woodburn Patrick Brompton DL8 1JN Bedale North Yorkshire | British | Chartered Accountant | 77274540002 | |||||
C & M SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | PO BOX 55 7 Spa Road SE16 3QP London | 900007640001 | |||||||
ANDERSON, David William | Amministratore | 17 Laurel Grove BT28 3EW Lisburn County Antrim | British | Finance Director | 67630980001 | |||||
ANSTEAD, Hamilton Douglas | Amministratore | 5 Heald Court 34 Hawthorn Lane SK9 5DG Wilmslow Cheshire | British | Cheif Executive | 107751890001 | |||||
BROWNLEE, Sarah Roberta | Amministratore | Shalom 59 Tirmacrannon Road Loughgall BT61 8LW Armagh County Armagh | Northern Ireland | British | Managing Director | 144250780001 | ||||
CALVELEY, Peter, Dr | Amministratore | Canwick Hill Canwick LN4 2RF Lincoln The Old Vicarage Lincolnshire | United Kingdom | British | Ceo | 131468590001 | ||||
CROWE, Geoffrey Michael | Amministratore | 51 Oakwood Lane Bowdon WA14 3DL Altrincham Cheshire | British | Commercial Diretor | 38256680007 | |||||
ELLIOTT, Graham Nicholas | Amministratore | 9 Bowmans Close BN44 3SR Steyning West Sussex | England | British | Company Director | 38064300002 | ||||
FITCH, William | Amministratore | Foxhall 19 Broomhill Park BT9 6JB Belfast Antrim | British | Director(Chairman) | 49478560001 | |||||
GRAHAM, Donald Cameron | Amministratore | 152 Eastwoodmains Road Clarkston G76 7HF Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | Accountant | 26178630002 | ||||
HAMMOND, Timothy Richard William | Amministratore | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | England | British | Company Director | 205777760001 | ||||
HEALY, Martin William Oliver | Amministratore | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | Irish | Accountant | 134003120002 | ||||
HEYWOOD, Anthony George | Amministratore | Harborough Hall Lane CO5 9UA Messing Harborough Hall Essex | England | British | Chief Executive | 131288260001 | ||||
HOW, Alistair Maxwell | Amministratore | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | Director | 169139000001 | ||||
KAY, Dominic Jude | Amministratore | 4 Glyn Avenue WA15 9DG Hale Cheshire | United Kingdom | British | Solicitor | 145920530001 | ||||
KINGHAN, Gary Ward | Amministratore | Treetops 23 Old Galgorm Road Ballymena BT41 1AL Co Antrim Northern Ireland | British | Managing Director | 56632550002 | |||||
MAXWELL, Barbara Ann | Amministratore | 17 Crieff Road SW18 2EB London | Irish | Managing Director | 41693200001 | |||||
MITCHELL, Nicholas John | Amministratore | Lymbrook 53 Dore Road Dore S17 3NA Sheffield South Yorkshire | Great Britain | British | Director | 145102120001 | ||||
O'REILLY, Michael Patrick | Amministratore | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | Director | 40241900001 | ||||
SIZER, Graham Kevin | Amministratore | Woodburn Patrick Brompton DL8 1JN Bedale North Yorkshire | British | Chartered Accountant | 77274540002 | |||||
SMITH, Ian Richard | Amministratore | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House | United Kingdom | British | Company Director | 181082310001 | ||||
TABERNER, Benjamin Robert | Amministratore | 25 Moorgate EC2R 6AY London C/O Smith & Williamson Llp | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 150511890001 | ||||
WILLIS, Graeme | Amministratore | 3 Carrwood Road SK9 5DJ Wilmslow Cheshire | British | Financial Director | 71527500002 | |||||
C & M REGISTRARS LIMITED | Amministratore delegato nominato | PO BOX 55 7 Spa Road SE16 3QP London | 900007630001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di EDGEWATER LODGE LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mericourt Limited | 16 lug 2019 | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Elli Finance (Uk) Plc | 06 apr 2016 | Suite 3 Regency House 91 Western Road BN1 2NW Brighton C/O Alvarez & Marsal Europe Llp United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Four Seasons Health Care Group Limited | 06 apr 2016 | Station Road SK9 1BU Wilmslow Norcliffe House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
EDGEWATER LODGE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A security deed | Creato il 30 ott 2006 Consegnato il 17 nov 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 30 apr 1997 Consegnato il 14 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a lease of even date | |
Brevi particolari All the companys right title and interest in and to the initial deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 27 mar 1997 Consegnato il 10 apr 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee in the event of a "default" (as defined in the deed) pursuant to a lease of even date | |
Brevi particolari All the company's right title and interest in and to the initial deposit all interests the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 27 mar 1997 Consegnato il 05 apr 1997 | Parzialmente soddisfatta | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari First fixed charge on l/h premises situtate at edgewater lodge nursing home sunnydale avenue millisle road donaghadee county down .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A mortgage debenture which was presented for registration in northern ireland on the 28TH may 1996 | Creato il 24 mag 1996 Consegnato il 06 giu 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
EDGEWATER LODGE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In amministrazione |
| ||||||||||||||||||||||
2 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0