PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED

PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03085817
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?

    • Servizi di rappresentanza dei media (73120) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    7th Floor, Lacon House
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EUROLITE 6'S LIMITED06 set 199506 set 1995
    MICROPRIZE LIMITED31 lug 199531 lug 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Cessazione della carica di Leon Taviansky come amministratore in data 31 mar 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Anthony John Booker come amministratore in data 15 feb 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Jason Richard Cotterrell come amministratore in data 15 feb 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Leon Taviansky come amministratore in data 15 feb 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Naren Anirudha Patel come amministratore in data 30 apr 2020

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony John Booker il 18 gen 2020

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Primesight Limited come persona con controllo significativo il 30 dic 2019

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Primesight Limited come persona con controllo significativo il 30 dic 2019

    2 paginePSC05

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony John Booker il 10 gen 2020

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Primesight come persona con controllo significativo il 30 dic 2019

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Primesight Limited the Met Building 22 Percy Street London W1T 2BU a 7th Floor, Lacon House 84 Theobalds Road London WC1X 8NL in data 07 nov 2019

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Primesight come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    5 paginePSC05

    Nomina di Mr Anthony John Booker come amministratore in data 15 lug 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Darren David Singer come amministratore in data 15 lug 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Monica Ellen Mackinnon come segretario in data 30 giu 2019

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Matthew Guy Teeman come amministratore in data 30 giu 2019

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COTTERRELL, Jason Richard
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    Amministratore
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    United KingdomBritish247876600001
    SINGER, Darren David
    Leicester Square
    WC2H 7LA London
    30
    United Kingdom
    Amministratore
    Leicester Square
    WC2H 7LA London
    30
    United Kingdom
    EnglandBritish159918310001
    CLARK, Peter Ian
    120 Barrowgate Road
    W4 4QP Chiswick
    London
    Segretario
    120 Barrowgate Road
    W4 4QP Chiswick
    London
    New Zealander64941070001
    CLARKE, Sara
    Old Stable Cottage
    Old Barn Farm, Uplawmoor
    G78 4AZ Glasgow
    Segretario
    Old Stable Cottage
    Old Barn Farm, Uplawmoor
    G78 4AZ Glasgow
    British77963580002
    DAVIDSON, Dawn
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    Segretario
    Langhaugh
    Carmichael
    ML12 6PQ Biggar
    Lanarkshire
    British51065860001
    DESAI, Falguni
    6 Buckleigh Avenue
    SW20 9JZ London
    Segretario
    6 Buckleigh Avenue
    SW20 9JZ London
    British77755390001
    MACKINNON, Monica Ellen
    c/o Primesight Limited
    22 Percy Street
    W1T 2BU London
    The Met Building
    England
    Segretario
    c/o Primesight Limited
    22 Percy Street
    W1T 2BU London
    The Met Building
    England
    British107899210001
    PHILIP, Ian Edward
    13 St Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    Kent
    Segretario
    13 St Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    Kent
    British10317680001
    PINNELL, Judith Helen
    12 Linden Road
    TW12 2JB Hampton
    Middlesex
    Segretario
    12 Linden Road
    TW12 2JB Hampton
    Middlesex
    British127121950001
    TAMES, Jane Elizabeth Anne
    5 Hatfield Drive
    Kelvinside
    G12 0XZ Glasgow
    Segretario
    5 Hatfield Drive
    Kelvinside
    G12 0XZ Glasgow
    British118367070001
    WHITE, Leonard Henry
    19 Montana Road
    SW20 8TW London
    Segretario
    19 Montana Road
    SW20 8TW London
    British12308620001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BOOKER, Anthony John
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    Amministratore
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    United KingdomBritish123183570001
    CLARK, Peter Ian
    120 Barrowgate Road
    W4 4QP Chiswick
    London
    Amministratore
    120 Barrowgate Road
    W4 4QP Chiswick
    London
    New Zealander64941070001
    DANIELS, Charles James
    Yew Tree End Springwoods
    Wentworth
    GU25 4PW Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Yew Tree End Springwoods
    Wentworth
    GU25 4PW Virginia Water
    Surrey
    British69233900002
    DANIELS, Paul Jonathan
    c/o Primesight Limited
    22 Percy Street
    W1T 2BU London
    The Met Building
    England
    Amministratore
    c/o Primesight Limited
    22 Percy Street
    W1T 2BU London
    The Met Building
    England
    EnglandBritish127121890001
    DANIELS, Paul Jonathan
    12 Beechwood Close
    GU51 5PT Church Crookham
    Hampshire
    Amministratore
    12 Beechwood Close
    GU51 5PT Church Crookham
    Hampshire
    British99302630001
    EMSLIE, Donald Gordon
    32 Drumsheugh Gardens
    EH3 7RN Edinburgh
    Amministratore
    32 Drumsheugh Gardens
    EH3 7RN Edinburgh
    ScotlandBritish61177720002
    FLANAGAN, Andrew Henry
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    7 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish42787120004
    HUGHES, Gary William
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    Amministratore
    64 Crown Road North
    Dowanhill
    G12 9HW Glasgow
    UkBritish72256160002
    PATEL, Naren Anirudha
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    Amministratore
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    EnglandBritish44514540003
    PATEL, Naren Anirudha
    Langham
    Brokengate Lane, Denham
    UB9 4LA Uxbridge
    Middlesex
    Amministratore
    Langham
    Brokengate Lane, Denham
    UB9 4LA Uxbridge
    Middlesex
    United KingdomBritish44514540002
    PEARSON, Sarah
    Flat 11 29-31 Dingley Place
    EC1V 8BR London
    Amministratore
    Flat 11 29-31 Dingley Place
    EC1V 8BR London
    British49285200002
    PHILIP, Ian Edward
    13 St Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    13 St Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish10317680001
    SINGH, Sohan
    The Hollies
    Castle Road Horsell
    GU21 4ET Woking
    Surrey
    Amministratore
    The Hollies
    Castle Road Horsell
    GU21 4ET Woking
    Surrey
    EnglandBritish82811080001
    TAVIANSKY, Leon
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    Amministratore
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    United KingdomBritish216429060001
    TEEMAN, Matthew Guy
    c/o Primesight Limited
    22 Percy Street
    W1T 2BU London
    The Met Building
    Amministratore
    c/o Primesight Limited
    22 Percy Street
    W1T 2BU London
    The Met Building
    EnglandBritish227376180001
    WATT, William George
    7 Millar Grove
    ML3 9BF Hamilton
    Amministratore
    7 Millar Grove
    ML3 9BF Hamilton
    ScotlandBritish72664400006
    WOODWARD, Robert Stanley Lawrence
    Crawfordston Farm
    Maybole
    KA19 7JS Ayrshire
    Amministratore
    Crawfordston Farm
    Maybole
    KA19 7JS Ayrshire
    ScotlandBritish122562020001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Gmt Realisation Fund L.P.
    Les Banques
    St. Peter Port
    GY1 2JA Guernsey
    Trafalar Court
    Guernsey
    05 apr 2017
    Les Banques
    St. Peter Port
    GY1 2JA Guernsey
    Trafalar Court
    Guernsey
    Forma giuridicaLimited Partnership
    Paese di registrazioneGuernsey
    Autorità legaleLimited Liability Partnership Act
    Luogo di registrazioneGuernsey Register
    Numero di registrazioneLp2788
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Primesight Limited
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    England
    06 apr 2016
    84 Theobalds Road
    WC1X 8NL London
    7th Floor, Lacon House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione1847728
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture
    Creato il 22 ott 2012
    Consegnato il 26 ott 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking assets present and future, including goodwill, book and other debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Macquarie Us Trading Llc
    Transazioni
    • 26 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 04 mag 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Full form debenture
    Creato il 16 nov 2011
    Consegnato il 23 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Leumi Abl Limited
    Transazioni
    • 23 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 04 apr 2003
    Consegnato il 16 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other of the obligors to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent on Trust for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 16 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 18 lug 2002
    Consegnato il 24 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 24 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 apr 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 02 giu 1997
    Consegnato il 11 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All indebtedness, liabilities and obligations which are as at 2ND june 1997 or may at any time thereafter be due, owing or incurred in any manner whatsoever to the chargee, by any group company whether actually or contingently, whether pursuant to the guarantee or otherwise
    Brevi particolari
    First fixed and floating charges over the undertaking and all its property and assets present and future incuding its goodwill and uncalled capital and all plant and machinery. (N.B. the property described in part I and ii of the schedule attached to this form 395 is described as being "none").. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland ("the Bank")
    Transazioni
    • 11 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 30 set 1996
    Consegnato il 07 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Stock trust deed
    Creato il 30 set 1996
    Consegnato il 05 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All amounts from time to time due from the company to the chargee (as trustees) under the stock trust deed including but not limited to payment of the amount of the principal sum then outstanding on the security of the stock and interest on the amount of such principal sum for the time being outstanding at the rate of 10% per year payable half yearly on 31ST december and 30TH june in the years 1996, 1997 and 1998 but at 12% per year in 1999 and 14% in 2000
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Botts Capital Nominees Limited and David Martin-Jenkins
    Transazioni
    • 05 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 set 1996
    Consegnato il 05 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Primesight PLC
    Transazioni
    • 05 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0