PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03085817 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?
- Servizi di rappresentanza dei media (73120) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 7th Floor, Lacon House 84 Theobalds Road WC1X 8NL London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| EUROLITE 6'S LIMITED | 06 set 1995 | 06 set 1995 |
| MICROPRIZE LIMITED | 31 lug 1995 | 31 lug 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Cessazione della carica di Leon Taviansky come amministratore in data 31 mar 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 6 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Anthony John Booker come amministratore in data 15 feb 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Jason Richard Cotterrell come amministratore in data 15 feb 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Leon Taviansky come amministratore in data 15 feb 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 6 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Naren Anirudha Patel come amministratore in data 30 apr 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony John Booker il 18 gen 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Modifica dei dettagli di Primesight Limited come persona con controllo significativo il 30 dic 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Modifica dei dettagli di Primesight Limited come persona con controllo significativo il 30 dic 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony John Booker il 10 gen 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Modifica dei dettagli di Primesight come persona con controllo significativo il 30 dic 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 6 pagine | AA | ||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Primesight Limited the Met Building 22 Percy Street London W1T 2BU a 7th Floor, Lacon House 84 Theobalds Road London WC1X 8NL in data 07 nov 2019 | 1 pagine | AD01 | ||
Modifica dei dettagli di Primesight come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 5 pagine | PSC05 | ||
Nomina di Mr Anthony John Booker come amministratore in data 15 lug 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Darren David Singer come amministratore in data 15 lug 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Monica Ellen Mackinnon come segretario in data 30 giu 2019 | 1 pagine | TM02 | ||
Cessazione della carica di Matthew Guy Teeman come amministratore in data 30 giu 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COTTERRELL, Jason Richard | Amministratore | 84 Theobalds Road WC1X 8NL London 7th Floor, Lacon House | United Kingdom | British | 247876600001 | |||||
| SINGER, Darren David | Amministratore | Leicester Square WC2H 7LA London 30 United Kingdom | England | British | 159918310001 | |||||
| CLARK, Peter Ian | Segretario | 120 Barrowgate Road W4 4QP Chiswick London | New Zealander | 64941070001 | ||||||
| CLARKE, Sara | Segretario | Old Stable Cottage Old Barn Farm, Uplawmoor G78 4AZ Glasgow | British | 77963580002 | ||||||
| DAVIDSON, Dawn | Segretario | Langhaugh Carmichael ML12 6PQ Biggar Lanarkshire | British | 51065860001 | ||||||
| DESAI, Falguni | Segretario | 6 Buckleigh Avenue SW20 9JZ London | British | 77755390001 | ||||||
| MACKINNON, Monica Ellen | Segretario | c/o Primesight Limited 22 Percy Street W1T 2BU London The Met Building England | British | 107899210001 | ||||||
| PHILIP, Ian Edward | Segretario | 13 St Johns Road TN13 3LR Sevenoaks Kent | British | 10317680001 | ||||||
| PINNELL, Judith Helen | Segretario | 12 Linden Road TW12 2JB Hampton Middlesex | British | 127121950001 | ||||||
| TAMES, Jane Elizabeth Anne | Segretario | 5 Hatfield Drive Kelvinside G12 0XZ Glasgow | British | 118367070001 | ||||||
| WHITE, Leonard Henry | Segretario | 19 Montana Road SW20 8TW London | British | 12308620001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BOOKER, Anthony John | Amministratore | 84 Theobalds Road WC1X 8NL London 7th Floor, Lacon House | United Kingdom | British | 123183570001 | |||||
| CLARK, Peter Ian | Amministratore | 120 Barrowgate Road W4 4QP Chiswick London | New Zealander | 64941070001 | ||||||
| DANIELS, Charles James | Amministratore | Yew Tree End Springwoods Wentworth GU25 4PW Virginia Water Surrey | British | 69233900002 | ||||||
| DANIELS, Paul Jonathan | Amministratore | c/o Primesight Limited 22 Percy Street W1T 2BU London The Met Building England | England | British | 127121890001 | |||||
| DANIELS, Paul Jonathan | Amministratore | 12 Beechwood Close GU51 5PT Church Crookham Hampshire | British | 99302630001 | ||||||
| EMSLIE, Donald Gordon | Amministratore | 32 Drumsheugh Gardens EH3 7RN Edinburgh | Scotland | British | 61177720002 | |||||
| FLANAGAN, Andrew Henry | Amministratore | 7 Collylinn Road Bearsden G61 4PN Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 42787120004 | |||||
| HUGHES, Gary William | Amministratore | 64 Crown Road North Dowanhill G12 9HW Glasgow | Uk | British | 72256160002 | |||||
| PATEL, Naren Anirudha | Amministratore | 84 Theobalds Road WC1X 8NL London 7th Floor, Lacon House | England | British | 44514540003 | |||||
| PATEL, Naren Anirudha | Amministratore | Langham Brokengate Lane, Denham UB9 4LA Uxbridge Middlesex | United Kingdom | British | 44514540002 | |||||
| PEARSON, Sarah | Amministratore | Flat 11 29-31 Dingley Place EC1V 8BR London | British | 49285200002 | ||||||
| PHILIP, Ian Edward | Amministratore | 13 St Johns Road TN13 3LR Sevenoaks Kent | England | British | 10317680001 | |||||
| SINGH, Sohan | Amministratore | The Hollies Castle Road Horsell GU21 4ET Woking Surrey | England | British | 82811080001 | |||||
| TAVIANSKY, Leon | Amministratore | 84 Theobalds Road WC1X 8NL London 7th Floor, Lacon House | United Kingdom | British | 216429060001 | |||||
| TEEMAN, Matthew Guy | Amministratore | c/o Primesight Limited 22 Percy Street W1T 2BU London The Met Building | England | British | 227376180001 | |||||
| WATT, William George | Amministratore | 7 Millar Grove ML3 9BF Hamilton | Scotland | British | 72664400006 | |||||
| WOODWARD, Robert Stanley Lawrence | Amministratore | Crawfordston Farm Maybole KA19 7JS Ayrshire | Scotland | British | 122562020001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmt Realisation Fund L.P. | 05 apr 2017 | Les Banques St. Peter Port GY1 2JA Guernsey Trafalar Court Guernsey | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Primesight Limited | 06 apr 2016 | 84 Theobalds Road WC1X 8NL London 7th Floor, Lacon House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
PRIMESIGHT COMMUNICATIONS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Composite debenture | Creato il 22 ott 2012 Consegnato il 26 ott 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to the chargee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking assets present and future, including goodwill, book and other debts, uncalled capital, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Full form debenture | Creato il 16 nov 2011 Consegnato il 23 nov 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 04 apr 2003 Consegnato il 16 apr 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or any other of the obligors to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 18 lug 2002 Consegnato il 24 lug 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 02 giu 1997 Consegnato il 11 giu 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All indebtedness, liabilities and obligations which are as at 2ND june 1997 or may at any time thereafter be due, owing or incurred in any manner whatsoever to the chargee, by any group company whether actually or contingently, whether pursuant to the guarantee or otherwise | |
Brevi particolari First fixed and floating charges over the undertaking and all its property and assets present and future incuding its goodwill and uncalled capital and all plant and machinery. (N.B. the property described in part I and ii of the schedule attached to this form 395 is described as being "none").. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and debenture | Creato il 30 set 1996 Consegnato il 07 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Stock trust deed | Creato il 30 set 1996 Consegnato il 05 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All amounts from time to time due from the company to the chargee (as trustees) under the stock trust deed including but not limited to payment of the amount of the principal sum then outstanding on the security of the stock and interest on the amount of such principal sum for the time being outstanding at the rate of 10% per year payable half yearly on 31ST december and 30TH june in the years 1996, 1997 and 1998 but at 12% per year in 1999 and 14% in 2000 | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 30 set 1996 Consegnato il 05 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0