EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03087337 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Deluxe House Unit 32, Perivale Industrial Park Horsenden Lane South UB6 7RH Perivale England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Deluxe Limited Film House 142 Wardour Street London W1F 8DD England a Deluxe House Unit 32, Perivale Industrial Park Horsenden Lane South Perivale UB6 7RH in data 29 gen 2021 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Deluxe House Unit 32, Perivale Business Park Perivale UB6 7RH | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Eric Cummins come amministratore in data 30 set 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 4 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Memorandum e Statuto | 3 pagine | MA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 giu 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo | 2 pagine | PSC08 | ||||||||||
Cessazione di Ronald Owen Perelman come persona con controllo significativo il 06 nov 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Michael Bell come amministratore in data 18 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ralph Abraham Levy come amministratore in data 18 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sirmad Balal Shafique come amministratore in data 18 set 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Stefanie Liquori Digrigoli come amministratore in data 17 set 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Roger Stuart Howl come amministratore in data 07 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Ralph Abraham Levy come amministratore in data 07 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Sirmad Balal Shafique come amministratore in data 07 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew Michael Bell come amministratore in data 07 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIQUORI DIGRIGOLI, Stefanie | Amministratore | Unit 32, Perivale Industrial Park Horsenden Lane South UB6 7RH Perivale Deluxe House England | United States | American | 262502870001 | |||||||||
| ABBOTT, Norman Charles Bettsworth | Segretario | 36 The Street Brooke NR15 1JT Norwich Norfolk | British | 16936560001 | ||||||||||
| ARIAS, Jesus Araujo | Segretario | Ferme Park Road N8 9BL London 260b | Spanish | 128431150001 | ||||||||||
| CATTERALL, Christopher Edward | Segretario | North Orbitial Road Denham UB9 5HQ Uxbridge Denham Media Park Middlesex | British | 156461510001 | ||||||||||
| CLEARY, David James | Segretario | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | 217477240001 | |||||||||||
| HIGHAM, Jennifer | Segretario | 216 Durrant Court CM1 1UE Chelmsford Essex | British | 66973550003 | ||||||||||
| HIGHAM, Jennifer | Segretario | 9 Cassons Close Weston Hills PE12 6DX Spalding Lincolnshire | British | 45596350001 | ||||||||||
| LEWIS, Jonathan Mark | Segretario | 3d Gatesborough Street EC2A 4NS London | British | 75832150002 | ||||||||||
| WATSON, James Neil | Segretario | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | 194237810001 | |||||||||||
| ARCH ACCOUNTANCY | Segretario | Tesla Court, Innovation Way Lynch Wood PE2 6FL Peterborough 26 United Kingdom |
| 108456720002 | ||||||||||
| ARIAS, Jesus Araujo | Amministratore | Ferme Park Road N8 9BL London 260b | United Kingdom | Spanish | 128431150001 | |||||||||
| BELL, Andrew Michael | Amministratore | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | England | British | 117165060003 | |||||||||
| CHAO, Gewe | Amministratore | 1040 Shoreland Drive Lopez Island Washington 98261 Usa | Us | 118256440001 | ||||||||||
| COOPER, Alethia | Amministratore | 13669 Legacy Circle \ B Herndon 20171 Usa | Usa | 118330750001 | ||||||||||
| CUMMINS, John Eric | Amministratore | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | United States | American | 246542580001 | |||||||||
| CUPPLES, Amanda Suzanne | Amministratore | c/o C/O James Watson, Deluxe 142 Wardour Street W1F 8DD London Ground Floor, Film House England | England | Australian,British | 187272820001 | |||||||||
| DAVIDSON, Neil Patrick | Amministratore | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | Usa | American | 197003660001 | |||||||||
| DONALDSON, Charles Mcbeath | Amministratore | 21 Grimsbury Drive OX16 7HL Banbury Oxfordshire | British | 45216040002 | ||||||||||
| FEINBERG, Jay Mark | Amministratore | 18125 Darnell Dr Olney Naryland 20832 Usa | Usa | 118330590001 | ||||||||||
| GATES, John Lybrook | Amministratore | 405 Southwest Drive Swilver Spring Maryland 20901 Usa | Us Citizen | 74873620001 | ||||||||||
| GEORGAKOPOULOU, Panayota | Amministratore | 137-144 High Holborn WC1V 6PL London Ect 1st Floor Holborn Tower | Greece | Greek | 102661640002 | |||||||||
| GURNEY, Patrick Philip | Amministratore | c/o C/O James Watson, Deluxe 142 Wardour Street W1F 8DD London Ground Floor, Film House England | England | British | 216332150001 | |||||||||
| HOWL, Roger Stuart | Amministratore | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | England | British | 199288360001 | |||||||||
| JONES, John Allan | Amministratore | Hengae Llanllwni SA39 9EE Pencader Dyfed | Welsh | 44176840001 | ||||||||||
| JULIAN, Robert Keith | Amministratore | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | United States | American | 238211530001 | |||||||||
| LEVY, Ralph Abraham | Amministratore | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | United States | American | 253310550001 | |||||||||
| LEWIS, Jonathan Mark | Amministratore | 3d Gatesborough Street EC2A 4NS London | British | 75832150002 | ||||||||||
| MAURER, Tim Charles | Amministratore | North Orbitial Road Denham UB9 5HQ Uxbridge Denham Media Park Middlesex | Usa | American | 157996630001 | |||||||||
| MORLEY, Alexander William John | Amministratore | North Orbitial Road Denham UB9 5HQ Uxbridge Denham Media Park Middlesex | England | British | 156461600001 | |||||||||
| MORLEY, Alexander William John | Amministratore | 164 Windmill Road W5 4BT Ealing London | England | British | 156461600001 | |||||||||
| SEIDEL, Robert T | Amministratore | c/o C/O James Watson, Deluxe 142 Wardour Street W1F 8DD London Ground Floor, Film House England | Usa | American | 102781690001 | |||||||||
| SHAFIQUE, Sirmad Balal | Amministratore | Film House 142 Wardour Street W1F 8DD London Deluxe Limited England | United Kingdom | British | 157242840001 | |||||||||
| SUH, John | Amministratore | c/o C/O James Watson, Deluxe 142 Wardour Street W1F 8DD London Ground Floor, Film House England | Usa | American | 173390760001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato |
|---|---|---|---|
| Mr Ronald Owen Perelman | 06 apr 2016 | 35 East 62nd Street NY 10065 New York Macandrews And Forbes Usa | Sì |
Nazionalità: American Paese di residenza: United States | |||
Natura del controllo
| |||
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 06 nov 2019 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
EUROPEAN CAPTIONING INSTITUTE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rent security deposit deed | Creato il 03 set 2009 Consegnato il 16 set 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £33,781.25 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The sum of £33,781 and all other monies see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 15 gen 2007 Consegnato il 18 gen 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent security deposit | Creato il 04 ago 2004 Consegnato il 14 ago 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The sum of £33,781.25 pursuant to the rent security deposit deed. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent security dfeposit deed | Creato il 08 mag 1998 Consegnato il 13 mag 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £5,875.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari £5,875.00 (the deposit). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 23 nov 1995 Consegnato il 28 nov 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0