PERGOLA PROPERTIES LTD

PERGOLA PROPERTIES LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPERGOLA PROPERTIES LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03087633
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PERGOLA PROPERTIES LTD?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova PERGOLA PROPERTIES LTD?

    Indirizzo della sede legale
    1 Brewery House
    Brook Street
    CO7 9DS Wivenhoe Colchester
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PERGOLA PROPERTIES LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WILKINACE PROPERTIES LIMITED04 ago 199504 ago 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di PERGOLA PROPERTIES LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PERGOLA PROPERTIES LTD?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per PERGOLA PROPERTIES LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 ago 2015 al 30 nov 2014

    1 pagineAA01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 ago 2014

    Stato del capitale al 08 ago 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 ago 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 06 ago 2013

    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2011

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2009

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2008

    6 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2007

    7 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2006

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2005

    7 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    4 pagine395

    Chi sono gli amministratori di PERGOLA PROPERTIES LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NEWTON, Mariette Marthe
    3 Tolliday Close
    Wivenhoe
    CO7 9SL Colchester
    Essex
    Segretario
    3 Tolliday Close
    Wivenhoe
    CO7 9SL Colchester
    Essex
    FrenchTeacher43957000001
    NEWTON, Kenneth Michael
    3 Tolliday Close
    Wivenhoe
    CO7 9SL Colchester
    Essex
    Amministratore
    3 Tolliday Close
    Wivenhoe
    CO7 9SL Colchester
    Essex
    EnglandBritishCompany Director43957110001
    NEWTON, Mariette Marthe
    3 Tolliday Close
    Wivenhoe
    CO7 9SL Colchester
    Essex
    Amministratore
    3 Tolliday Close
    Wivenhoe
    CO7 9SL Colchester
    Essex
    EnglandFrenchTeacher43957000001
    RM REGISTRARS LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Segretario nominato
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900000760001
    RM NOMINEES LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Amministratore delegato nominato
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900009140001

    PERGOLA PROPERTIES LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 02 giu 2000
    Consegnato il 29 ott 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property known as 25 kingfisher drive dovercourt t/n EX660989.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC Trading as the Woolwich
    Transazioni
    • 29 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 05 mag 2000
    Consegnato il 25 mag 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The freehold property known as 4 pepys street, harwich, essex title number EX577552. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 25 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Legal charge
    Creato il 28 apr 2000
    Consegnato il 24 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    52 timer court grays essex formerly known as plot 32 lightermans quay columbia wharf road grays essex fixed charge over all rental income floating charge over the undertaking and all other property and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC T/a Woolwich PLC
    Transazioni
    • 24 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 08 feb 2000
    Consegnato il 24 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    35 coal court grays essex formerly k/a plot 117 lightermans quay columbia wharf road grays essex fixed charge ove the rental income floating charge over the undertaking and all other property and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC T/a Woolwich PLC
    Transazioni
    • 24 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 01 apr 1998
    Consegnato il 21 apr 1998
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat 2 43 victoria street dovercourt essex T.n EX464307. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Mortgage deed
    Creato il 19 giu 1997
    Consegnato il 10 lug 1997
    In corso
    Importo garantito
    £20,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the mortgage deed
    Brevi particolari
    The freehold property known as 35 una road parkeston harwich essex.
    Persone aventi diritto
    • Jochen Hofmann
    • Waltraud Hofman
    Transazioni
    • 10 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Mortgage
    Creato il 30 mag 1997
    Consegnato il 05 giu 1997
    In corso
    Importo garantito
    £10,000 due from the company to the chargee under the terms of this mortgage
    Brevi particolari
    F/H property k/a 4 pepys street harwich essex.
    Persone aventi diritto
    • Jochen Hofmann and Waltraud Hofmann
    Transazioni
    • 05 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Legal mortgage
    Creato il 07 feb 1997
    Consegnato il 24 feb 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat 3 5 orwell terrace dovercourt and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 24 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 20 set 1996
    Consegnato il 08 ott 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 10 central house dovercourt essex tand the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Legal mortgage
    Creato il 22 apr 1996
    Consegnato il 03 mag 1996
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    210 fronks road dovercourt essex and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Legal mortgage
    Creato il 30 nov 1995
    Consegnato il 20 dic 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    43 gazelle court highwoods colchester essex (l/h). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0