TALKLAND MIDLANDS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TALKLAND MIDLANDS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03089104 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TALKLAND MIDLANDS LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova TALKLAND MIDLANDS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TALKLAND MIDLANDS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TALKLAND PHONE IN LIMITED | 23 ago 1995 | 23 ago 1995 |
| RYCOVE ENTERPRISES LIMITED | 09 ago 1995 | 09 ago 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TALKLAND MIDLANDS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per TALKLAND MIDLANDS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 07 mar 2018
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 feb 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 feb 2016 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 feb 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Joanne Sarah Finch come amministratore in data 26 set 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 feb 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 5Th Floor One Kingdom Street Paddington Central London W2 6BY United Kingdom | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Nomina di Mr David Nigel Evans come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Martin Purkess come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 feb 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Nomina di Diane Mcintyre come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TALKLAND MIDLANDS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODAFONE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Segretario | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | 75473330004 | |||||||
| EVANS, David Nigel | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 134975040001 | |||||
| MCINTYRE, Diane Josephine, Cfo | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 173703620001 | |||||
| LAVER, John Michael | Segretario | Brook House Homestead Road TN8 6JD Edenbridge Kent | British | 8207040001 | ||||||
| SCOTT, Stephen Roy | Segretario | Bracken House Bunces Shaw Farley Hill RG7 1UU Reading Berkshire | British | 25660590003 | ||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario nominato | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 | |||||||
| ALLEN, Christian Philip Quentin | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 123612980001 | ||||||
| BREWER, Stephen | Amministratore | Flat 10 Rushworth House Enborne Lodge Lane RG14 6RH Newbury Berkshire | British | 79186090002 | ||||||
| BROCKLEHURST, Nigel | Amministratore | 1 The Hollyhocks Reading Road, Harwell OX11 0LX Didcot Oxfordshire | British | 83126790001 | ||||||
| CHESWORTH, Paul | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 99525280001 | ||||||
| EDWARDS, Peter David | Amministratore | Hockets Oriental Road SL5 7AZ Sunninghill Berkshire | British | 1908570001 | ||||||
| EVANS, Mark | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | British | 127017870001 | ||||||
| FINCH, Joanne Sarah | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 158146620001 | |||||
| FREEMAN, William Ian Bede | Amministratore | Herons Cottage Ferry Lane, Medmenham SL7 2EZ Marlow Buckinghamshire | England | British | 64442870001 | |||||
| GRAY, Ian | Amministratore | 61 Bathurst Mews W2 2SB London | United Kingdom | British | 50246030004 | |||||
| HALFORD, Andrew Nigel | Amministratore | The Oxdrove House Burghclere RG20 9HJ Newbury Berkshire | British | 33951180005 | ||||||
| KEY, Matthew David | Amministratore | Yardley School Lane Seer Green HP9 2QJ Beaconsfield Buckinghamshire | British | 62981720001 | ||||||
| LANGSTON, Edward | Amministratore | 23 Manilla Road Clifton BS8 4EB Bristol Avon | Uk | British | 24471140001 | |||||
| LANGSTON, Edward | Amministratore | 23 Manilla Road Clifton BS8 4EB Bristol Avon | Uk | British | 24471140001 | |||||
| LEE, Simon Christopher | Amministratore | Moorlands Harrow Road West RH4 3BH Dorking Surrey | United Kingdom | British | 86697870001 | |||||
| NOWAK, Thomas, Dr | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | German | 174443800001 | |||||
| PURKESS, Martin John | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | England | British | 139360020001 | |||||
| READ, Nicholas Jonathan | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 87149560001 | |||||
| SCHÄFER, Richard Wolfgang Henry | Amministratore | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 158146600001 | |||||
| SHERWOOD, Timothy Robin | Amministratore | Berry Oaks 12 Woodlands Avenue RG41 3HL Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | 104309090001 | |||||
| TOURNON, Emanuele | Amministratore | Vodafone House The Connection RG14 2FN Newbury Berkshire | United Kingdom | Italian | 103542080002 | |||||
| TOWNSEND, John Raymond | Amministratore | Knowle House Chapel Corner Hamstead Marshall RG20 0HP Newbury Berkshire | British | 95223480001 | ||||||
| WATSON, Ian | Amministratore | School House Oakley Park Frilford Heath OX13 6QW Abingdon Oxfordshire | United Kingdom | British | 117671590001 | |||||
| WEBB, Denys William | Amministratore | Oakfield Stud Whitemoor Lane, Upper Basildon RG8 8SF Reading Berkshire | United Kingdom | British | 76074580001 | |||||
| WHITTLE, John Richard | Amministratore | 54 Stirling Road BH3 7JH Bournemouth Dorset | British | 69660920001 | ||||||
| WOOD, Christopher | Amministratore | Wayside Cottage Hunscote Lane Wellesbourne CV35 9EX Warwickshire | England | British | 44842800001 | |||||
| COMBINED NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NA London | 900000090001 | |||||||
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Victoria House 64 Paul Street EC2A 4NG London | 900000080001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di TALKLAND MIDLANDS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone Retail Limited | 06 apr 2016 | The Connection RG14 2FN Newbury Vodafone House Berkshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
TALKLAND MIDLANDS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 29 set 1995 Consegnato il 05 ott 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H 21 shelton square coventry. L/h 29 regent street hinckley. L/h 43A wood street stratford-upon-avon. L/h 13 market place banbury. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0