EMPRISE PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEMPRISE PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 03089450
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EMPRISE PLC?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova EMPRISE PLC?

    Indirizzo della sede legale
    Gateway House Tollgate,
    Chandlers Ford
    SO53 3TG Eastleigh
    Hampshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EMPRISE PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EMPRISE LIMITED02 mag 200702 mag 2007
    EMPRISE PLC21 ott 200421 ott 2004
    EMPRISE LIMITED02 nov 199502 nov 1995
    INGLEBY (835) LIMITED09 ago 199509 ago 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di EMPRISE PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 giu 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per EMPRISE PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 lug 2019

    31 pagineLIQ03

    Dichiarazione delle attività

    8 pagineLIQ02

    Indirizzo della sede legale modificato da Gateway House Tollgate, Chandlers Ford Eastleigh Hampshire SO53 3TG a Gateway House Tollgate, Chandlers Ford Eastleigh Hampshire SO53 3TG in data 17 lug 2018

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 186 City Road London EC1V 2NT a Gateway House Tollgate, Chandlers Ford Eastleigh Hampshire SO53 3TG in data 17 lug 2018

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Addleshaw Goddard (Scotland) Secretarial Limited come segretario in data 16 lug 2018

    1 pagineTM02

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 27 giu 2018

    LRESEX

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 29 giu 2017 al 29 dic 2017

    1 pagineAA01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Nomina di Addleshaw Goddard (Scotland) Secretarial Limited come segretario in data 01 set 2017

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Mark Ronald Sydney Beadle come segretario in data 01 set 2017

    1 pagineTM02

    Soddisfazione dell'onere 030894500005 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ago 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 29 giu 2016

    19 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 giu 2016 al 29 giu 2016

    1 pagineAA01

    Nomina di Mr Mark Ronald Sydney Beadle come amministratore in data 01 apr 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Mark Ronald Sydney Beadle come segretario in data 01 apr 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Howard Graham Sharp come segretario in data 01 apr 2016

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Howard Graham Sharp come amministratore in data 01 apr 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio modificato redatto al 30 giu 2015

    12 pagineAAMD

    Bilancio redatto al 30 giu 2015

    12 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Howard Graham Sharp il 03 ago 2015

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di EMPRISE PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARRETT, Stephen John
    Tollgate,
    Chandlers Ford
    SO53 3TG Eastleigh
    Gateway House
    Hampshire
    Amministratore
    Tollgate,
    Chandlers Ford
    SO53 3TG Eastleigh
    Gateway House
    Hampshire
    United KingdomBritish5149580003
    BEADLE, Mark Ronald Sydney
    Tollgate,
    Chandlers Ford
    SO53 3TG Eastleigh
    Gateway House
    Hampshire
    Amministratore
    Tollgate,
    Chandlers Ford
    SO53 3TG Eastleigh
    Gateway House
    Hampshire
    EnglandBritish198215750001
    BEADLE, Mark Ronald Sydney
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Segretario
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    214739420001
    BURROWS, Alison Jane
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Segretario
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    British166193310001
    CROWFOOT, Martyn Christopher
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Segretario
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    British85033580002
    SHARP, Howard Graham
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Segretario
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    187487590001
    SHARP, Howard Graham
    Ridgefield 21 Blackmore Way
    Blackmore End
    AL4 8LJ Wheathampstead
    Hertfordshire
    Segretario
    Ridgefield 21 Blackmore Way
    Blackmore End
    AL4 8LJ Wheathampstead
    Hertfordshire
    British38254450003
    ADDLESHAW GODDARD (SCOTLAND) SECRETARIAL LIMITED
    Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Exchange Tower, 19
    Scotland
    Segretario
    Canning Street
    EH3 8EH Edinburgh
    Exchange Tower, 19
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC131085
    665080009
    INGLEBY NOMINEES LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Segretario nominato
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007860001
    BARRETT, Stephen John
    Amberley
    Lee's Hill
    RG29 1RQ South Warnborough
    Hampshire
    Amministratore
    Amberley
    Lee's Hill
    RG29 1RQ South Warnborough
    Hampshire
    British5149580002
    BENCE, Trevor William
    4 Chawkmare Coppice
    Aldwick
    PO21 3BT Bognor Regis
    West Sussex
    Amministratore
    4 Chawkmare Coppice
    Aldwick
    PO21 3BT Bognor Regis
    West Sussex
    EnglandBritish46424570001
    BURROWS, Alison Jane
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Amministratore
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    EnglandBritish123013760002
    BURROWS, Alison Jane
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Amministratore
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    EnglandBritish123013760002
    CLAMPIT, Diane
    99 Chepstow Road
    NN18 8QQ Corby
    Northamptonshire
    Amministratore
    99 Chepstow Road
    NN18 8QQ Corby
    Northamptonshire
    British105578650002
    CLARKE, Raymond James
    Sunnybank
    Hickmans Green, Boughton Under Blean
    ME13 9NT Faversham
    Kent
    Amministratore
    Sunnybank
    Hickmans Green, Boughton Under Blean
    ME13 9NT Faversham
    Kent
    British58678170002
    CROWFOOT, Martyn Christopher
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Amministratore
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    EnglandBritish85033580002
    FURLONG, David
    Forest Edge
    18 Sylvan Way
    IG7 4QB Chigwell
    Essex
    Amministratore
    Forest Edge
    18 Sylvan Way
    IG7 4QB Chigwell
    Essex
    British96183490001
    FURLONG, David
    Forest Edge
    18 Sylvan Way
    IG7 4QB Chigwell
    Essex
    Amministratore
    Forest Edge
    18 Sylvan Way
    IG7 4QB Chigwell
    Essex
    British96183490001
    GARRETT, Michael Stephan
    Wood Lodge
    Lughorse Lane, Yalding
    ME18 6EB Maidstone
    Kent
    Amministratore
    Wood Lodge
    Lughorse Lane, Yalding
    ME18 6EB Maidstone
    Kent
    United KingdomBritish70619210003
    HAMPSON, Anthony Peter
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Amministratore
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    UkBritish138791270001
    HARVEY, Paul
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Amministratore
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    EnglandBritish175308800001
    HOWIE, Alison Jane
    37 Lavengro Road
    West Norwood
    SE27 9EQ London
    Amministratore
    37 Lavengro Road
    West Norwood
    SE27 9EQ London
    British96185200001
    MCGILVRAY, Craig Matthew
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Amministratore
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    ScotlandBritish58993260002
    MOODY, Lee Mark
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Amministratore
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    United KingdomBritish114275100001
    POSKITT, John Robert
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Amministratore
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    United KingdomBritish92122220001
    ROGERS, Martin Phillip
    28 Fairfax Road
    NW6 4HA London
    Amministratore
    28 Fairfax Road
    NW6 4HA London
    British18752390002
    RUSSELL, Christopher John
    37 Glebe Street
    Chiswick
    W4 2BE London
    Amministratore
    37 Glebe Street
    Chiswick
    W4 2BE London
    British96185690001
    SHARP, Howard Graham
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Amministratore
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    EnglandBritish38254450005
    SHARP, Howard Graham
    Ridgefield 21 Blackmore Way
    Blackmore End
    AL4 8LJ Wheathampstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    Ridgefield 21 Blackmore Way
    Blackmore End
    AL4 8LJ Wheathampstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish38254450003
    SHEARMAN, Lesley
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    Amministratore
    186 City Road
    London
    EC1V 2NT
    United KingdomBritish82540740002
    WALKER, James Newman
    39 Coverside Road
    LE8 9EB Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    39 Coverside Road
    LE8 9EB Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish126676230001
    WEBSTER, Richard Edward
    1 Larkswood Road
    Corringham
    SS17 9DG Stanford-Le-Hope
    Essex
    Amministratore
    1 Larkswood Road
    Corringham
    SS17 9DG Stanford-Le-Hope
    Essex
    British116347910001
    WEBSTER, Richard Edward
    1 Larkswood Road
    Corringham
    SS17 9DG Stanford-Le-Hope
    Essex
    Amministratore
    1 Larkswood Road
    Corringham
    SS17 9DG Stanford-Le-Hope
    Essex
    British116347910001
    WHITTINGHAM, Ian Clive
    Swan Mews
    RG29 1DL North Warnborough
    7
    Hampshire
    Amministratore
    Swan Mews
    RG29 1DL North Warnborough
    7
    Hampshire
    United KingdomBritish151458200001
    INGLEBY HOLDINGS LIMITED
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    Amministratore delegato nominato
    55 Colmore Row
    B3 2AS Birmingham
    900007850001

    Chi sono le persone con controllo significativo di EMPRISE PLC?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    City Road
    EC1V 2NT London
    186
    England
    06 apr 2016
    City Road
    EC1V 2NT London
    186
    England
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 1985
    Luogo di registrazioneUnited Kingdom
    Numero di registrazione4915792
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    EMPRISE PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 12 apr 2013
    Consegnato il 26 apr 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 26 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 30 ago 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 14 mag 2007
    Consegnato il 19 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor or other member of the group to any of the senior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Agent)
    Transazioni
    • 19 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge of securities
    Creato il 30 set 2004
    Consegnato il 07 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of fixed charge any stocks shares bonds warrants or securities (certificated or uncertificated) from time to time named in any schedule supplied by or on behalf of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 lug 2001
    Consegnato il 26 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 26 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 31 ott 1995
    Consegnato il 09 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company (formerly known as ingleby (835) limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ago 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    EMPRISE PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 giu 2018Inizio della liquidazione
    07 feb 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Neil David Gostelow
    Gateway House Tollgate
    SO53 3TG Chandlers Ford
    Hampshire
    Praticante
    Gateway House Tollgate
    SO53 3TG Chandlers Ford
    Hampshire
    William James Wright
    Gateway House Tollgate
    SO53 3TG Chandlers Ford
    Hampshire
    Praticante
    Gateway House Tollgate
    SO53 3TG Chandlers Ford
    Hampshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0