EMPRISE PLC
Panoramica
| Nome della società | EMPRISE PLC |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società per azioni |
| Numero di società | 03089450 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EMPRISE PLC?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova EMPRISE PLC?
| Indirizzo della sede legale | Gateway House Tollgate, Chandlers Ford SO53 3TG Eastleigh Hampshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EMPRISE PLC?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| EMPRISE LIMITED | 02 mag 2007 | 02 mag 2007 |
| EMPRISE PLC | 21 ott 2004 | 21 ott 2004 |
| EMPRISE LIMITED | 02 nov 1995 | 02 nov 1995 |
| INGLEBY (835) LIMITED | 09 ago 1995 | 09 ago 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EMPRISE PLC?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 29 giu 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per EMPRISE PLC?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 3 pagine | LIQ14 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 25 lug 2019 | 31 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione delle attività | 8 pagine | LIQ02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Gateway House Tollgate, Chandlers Ford Eastleigh Hampshire SO53 3TG a Gateway House Tollgate, Chandlers Ford Eastleigh Hampshire SO53 3TG in data 17 lug 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 186 City Road London EC1V 2NT a Gateway House Tollgate, Chandlers Ford Eastleigh Hampshire SO53 3TG in data 17 lug 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Addleshaw Goddard (Scotland) Secretarial Limited come segretario in data 16 lug 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 29 giu 2017 al 29 dic 2017 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Nomina di Addleshaw Goddard (Scotland) Secretarial Limited come segretario in data 01 set 2017 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Ronald Sydney Beadle come segretario in data 01 set 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 030894500005 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 ago 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 29 giu 2016 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 giu 2016 al 29 giu 2016 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Nomina di Mr Mark Ronald Sydney Beadle come amministratore in data 01 apr 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Mark Ronald Sydney Beadle come segretario in data 01 apr 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Howard Graham Sharp come segretario in data 01 apr 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 05 ago 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Howard Graham Sharp come amministratore in data 01 apr 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio modificato redatto al 30 giu 2015 | 12 pagine | AAMD | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 giu 2015 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Howard Graham Sharp il 03 ago 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di EMPRISE PLC?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARRETT, Stephen John | Amministratore | Tollgate, Chandlers Ford SO53 3TG Eastleigh Gateway House Hampshire | United Kingdom | British | 5149580003 | |||||||||
| BEADLE, Mark Ronald Sydney | Amministratore | Tollgate, Chandlers Ford SO53 3TG Eastleigh Gateway House Hampshire | England | British | 198215750001 | |||||||||
| BEADLE, Mark Ronald Sydney | Segretario | 186 City Road London EC1V 2NT | 214739420001 | |||||||||||
| BURROWS, Alison Jane | Segretario | 186 City Road London EC1V 2NT | British | 166193310001 | ||||||||||
| CROWFOOT, Martyn Christopher | Segretario | 186 City Road London EC1V 2NT | British | 85033580002 | ||||||||||
| SHARP, Howard Graham | Segretario | 186 City Road London EC1V 2NT | 187487590001 | |||||||||||
| SHARP, Howard Graham | Segretario | Ridgefield 21 Blackmore Way Blackmore End AL4 8LJ Wheathampstead Hertfordshire | British | 38254450003 | ||||||||||
| ADDLESHAW GODDARD (SCOTLAND) SECRETARIAL LIMITED | Segretario | Canning Street EH3 8EH Edinburgh Exchange Tower, 19 Scotland |
| 665080009 | ||||||||||
| INGLEBY NOMINEES LIMITED | Segretario nominato | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007860001 | |||||||||||
| BARRETT, Stephen John | Amministratore | Amberley Lee's Hill RG29 1RQ South Warnborough Hampshire | British | 5149580002 | ||||||||||
| BENCE, Trevor William | Amministratore | 4 Chawkmare Coppice Aldwick PO21 3BT Bognor Regis West Sussex | England | British | 46424570001 | |||||||||
| BURROWS, Alison Jane | Amministratore | 186 City Road London EC1V 2NT | England | British | 123013760002 | |||||||||
| BURROWS, Alison Jane | Amministratore | 186 City Road London EC1V 2NT | England | British | 123013760002 | |||||||||
| CLAMPIT, Diane | Amministratore | 99 Chepstow Road NN18 8QQ Corby Northamptonshire | British | 105578650002 | ||||||||||
| CLARKE, Raymond James | Amministratore | Sunnybank Hickmans Green, Boughton Under Blean ME13 9NT Faversham Kent | British | 58678170002 | ||||||||||
| CROWFOOT, Martyn Christopher | Amministratore | 186 City Road London EC1V 2NT | England | British | 85033580002 | |||||||||
| FURLONG, David | Amministratore | Forest Edge 18 Sylvan Way IG7 4QB Chigwell Essex | British | 96183490001 | ||||||||||
| FURLONG, David | Amministratore | Forest Edge 18 Sylvan Way IG7 4QB Chigwell Essex | British | 96183490001 | ||||||||||
| GARRETT, Michael Stephan | Amministratore | Wood Lodge Lughorse Lane, Yalding ME18 6EB Maidstone Kent | United Kingdom | British | 70619210003 | |||||||||
| HAMPSON, Anthony Peter | Amministratore | 186 City Road London EC1V 2NT | Uk | British | 138791270001 | |||||||||
| HARVEY, Paul | Amministratore | 186 City Road London EC1V 2NT | England | British | 175308800001 | |||||||||
| HOWIE, Alison Jane | Amministratore | 37 Lavengro Road West Norwood SE27 9EQ London | British | 96185200001 | ||||||||||
| MCGILVRAY, Craig Matthew | Amministratore | 186 City Road London EC1V 2NT | Scotland | British | 58993260002 | |||||||||
| MOODY, Lee Mark | Amministratore | 186 City Road London EC1V 2NT | United Kingdom | British | 114275100001 | |||||||||
| POSKITT, John Robert | Amministratore | 186 City Road London EC1V 2NT | United Kingdom | British | 92122220001 | |||||||||
| ROGERS, Martin Phillip | Amministratore | 28 Fairfax Road NW6 4HA London | British | 18752390002 | ||||||||||
| RUSSELL, Christopher John | Amministratore | 37 Glebe Street Chiswick W4 2BE London | British | 96185690001 | ||||||||||
| SHARP, Howard Graham | Amministratore | 186 City Road London EC1V 2NT | England | British | 38254450005 | |||||||||
| SHARP, Howard Graham | Amministratore | Ridgefield 21 Blackmore Way Blackmore End AL4 8LJ Wheathampstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 38254450003 | |||||||||
| SHEARMAN, Lesley | Amministratore | 186 City Road London EC1V 2NT | United Kingdom | British | 82540740002 | |||||||||
| WALKER, James Newman | Amministratore | 39 Coverside Road LE8 9EB Leicester Leicestershire | England | British | 126676230001 | |||||||||
| WEBSTER, Richard Edward | Amministratore | 1 Larkswood Road Corringham SS17 9DG Stanford-Le-Hope Essex | British | 116347910001 | ||||||||||
| WEBSTER, Richard Edward | Amministratore | 1 Larkswood Road Corringham SS17 9DG Stanford-Le-Hope Essex | British | 116347910001 | ||||||||||
| WHITTINGHAM, Ian Clive | Amministratore | Swan Mews RG29 1DL North Warnborough 7 Hampshire | United Kingdom | British | 151458200001 | |||||||||
| INGLEBY HOLDINGS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 55 Colmore Row B3 2AS Birmingham | 900007850001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di EMPRISE PLC?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emprise Holdings Limited | 06 apr 2016 | City Road EC1V 2NT London 186 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
EMPRISE PLC ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 12 apr 2013 Consegnato il 26 apr 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 14 mag 2007 Consegnato il 19 mag 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor or other member of the group to any of the senior creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge of securities | Creato il 30 set 2004 Consegnato il 07 ott 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of fixed charge any stocks shares bonds warrants or securities (certificated or uncertificated) from time to time named in any schedule supplied by or on behalf of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 19 lug 2001 Consegnato il 26 lug 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 31 ott 1995 Consegnato il 09 nov 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company (formerly known as ingleby (835) limited) to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
EMPRISE PLC ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0