FORD PLACE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | FORD PLACE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03090556 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di FORD PLACE LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova FORD PLACE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Swanton Care & Community Limited Number Three, Siskin Drive Middlemarch Business Park CV3 4FJ Coventry England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di FORD PLACE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| TEMPOFORCE LIMITED | 11 ago 1995 | 11 ago 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di FORD PLACE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per FORD PLACE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 ott 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mrs Julianne Baker come amministratore in data 23 mar 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 ott 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 ott 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Gary David Thompson come amministratore in data 30 set 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 ott 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Andrew Dalton come amministratore in data 18 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 ott 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alexander Hendry Stuart Cowie come segretario in data 02 ott 2018 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alexander Hendry, Stuart Cowie come amministratore in data 02 ott 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 ott 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Garry Anthony Cross come amministratore in data 03 nov 2017 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Alexander Hendry Sturt Cowie come segretario in data 18 ott 2017 | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr Alexander Hendry, Stuart Cowie come amministratore in data 17 lug 2017 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Ford David Porter come amministratore in data 17 lug 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di FORD PLACE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKER, Julianne | Amministratore | Farlers End Nailsea BS48 4PG Bristol 11 Farlers End, Nailsea England | England | British | 303468550001 | |||||
| CROSS, Garry Anthony | Amministratore | Siskin Drive Middlemarch Business Park CV3 4FJ Coventry Number Three England United Kingdom | United Kingdom | British | 240022330001 | |||||
| DALTON, Andrew Mark | Amministratore | Siskin Drive Middlemarch Business Park CV3 4FJ Coventry Number Three England United Kingdom | England | British | 254318910001 | |||||
| GRAY, Samuel James Caiger | Amministratore | Godliman Street EC4V 5BD London Genesis House England | England | British | 214683980001 | |||||
| PORTER, Ford David | Amministratore | Godliman Street EC4V 5BD London Genesis House England | England | British,American | 235635120001 | |||||
| THOMPSON, Gary | Amministratore | Siskin Drive Middlemarch Business Park CV3 4FJ Coventry Number Three England | England | British | 147849060001 | |||||
| BACON, Deena Marie | Segretario | Hubbards Barn Bentley Road, Tacolneston NR16 1DL Norwich | British | 45542840004 | ||||||
| COWIE, Alexander Hendry Stuart | Segretario | Siskin Drive Middlemarch Business Park CV3 4FJ Coventry Swanton Care & Community Limited Number Three England | 239630130001 | |||||||
| DUNCAN, David Gregor | Segretario | Flat 43 The Piper Building Peterborough Road SW6 3EF London | British | 97755760001 | ||||||
| HATHER, Jon | Segretario | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | British | 68848420004 | ||||||
| PORTAL, Ian | Segretario | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | 165801810001 | |||||||
| RICHARDSON, Joanne | Segretario | Number Three, Siskin Drive Middlemarch Business Park CV3 4FJ Coventry Swanton Care & Community Limited England England | 179166220001 | |||||||
| ALPHA SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 2nd Floor 83 Clerkenwell Road EC1R 5AR London | 900004510001 | |||||||
| BACON, Dennis Matthew | Amministratore | Hubbards Barn Bentley Road Tacolneston NR16 1DL Norwich Norfolk | British | 42140300004 | ||||||
| COWIE, Alexander Hendry, Stuart | Amministratore | Siskin Drive Middlemarch Business Park CV3 4FJ Coventry Number Three England United Kingdom | England | English | 202436360001 | |||||
| DUNCAN, David Gregor | Amministratore | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 97755760001 | |||||
| DUNCAN, David Gregor | Amministratore | Flat 43 The Piper Building Peterborough Road SW6 3EF London | United Kingdom | British | 97755760001 | |||||
| GOWERS, Tobias Zachary | Amministratore | 226c Earlsfield Road SW18 3DX London | British | 114501770001 | ||||||
| GRINT, Peter | Amministratore | Normans Farm Wroxham Road Salhouse NR13 6EZ Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 45542770001 | |||||
| HATHER, Jon | Amministratore | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 68848420005 | |||||
| HAYES, Paul | Amministratore | Second Floor Design Centre East, Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 England England | United Kingdom | English | 157254680001 | |||||
| HILL, Paul Ian | Amministratore | Stephendale Road Fulham SW6 2PJ London Top Floor Flat, 144 | United Kingdom | British | 114501870007 | |||||
| MCGARTOLL, Owen Raphael | Amministratore | 58 The Anchorage, Clarence Street IRISH Dun Laoghaire County Dublin Ireland | Irish | 116537370001 | ||||||
| MURPHY, Paul Edward | Amministratore | Number Three, Siskin Drive Middlemarch Business Park CV3 4FJ Coventry Swanton Care & Community Limited England England | Ireland | Irish | 104969070004 | |||||
| PARSONS, Michael Dennis | Amministratore | The Chambers Chelsea Harbour SW10 0XF London Suite 201 United Kingdom | United Kingdom | British | 44895330007 | |||||
| ROSE-QUIRIE, Alison Jane, Dr | Amministratore | Number Three, Siskin Drive Middlemarch Business Park CV3 4FJ Coventry Swanton Care & Community Limited England England | England | British | 190407640001 | |||||
| SIMMONS, Dennis Edward | Amministratore | 7 Harvest Lane Seymour Place SG2 7RD Stevenage Hertfordshire | British | 55689910001 | ||||||
| ALPHA DIRECT LIMITED | Amministratore delegato nominato | 2nd Floor 83 Clerkenwell Road EC1R 5AR London | 900001400001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di FORD PLACE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swanton Care & Community (Andrew Frederick Care Homes) Limited | 06 apr 2016 | 3 Siskin Drive Middlemarch Business Park CV3 4FJ Coventry Swanton Care & Community Limited United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
FORD PLACE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 19 ott 2004 Consegnato il 02 nov 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the charging companies to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 01 apr 2004 Consegnato il 08 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 03 giu 1998 Consegnato il 23 giu 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a situate at ford place ford street thetford norfolk. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 mar 1997 Consegnato il 27 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £665,000 and all other moneys due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge | |
Brevi particolari F/H ford place thetford norfolk. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0