CENTRAL CRC LIMITED

CENTRAL CRC LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCENTRAL CRC LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03091290
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CENTRAL CRC LIMITED?

    • fabbricazione di altri prodotti in plastica (22290) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova CENTRAL CRC LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    11 Roman Way Business Centre
    Berry Hill
    WR9 9AJ Droitwich
    Worcester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CENTRAL CRC LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CENTRAL EXPRESS WINDOWS LIMITED 15 ago 199515 ago 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di CENTRAL CRC LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per CENTRAL CRC LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    26 pagineLIQ14

    Indirizzo della sede legale modificato da Hillcairnie House St Andrews Road Droitwich Worcestershire WR9 8DJ a 11 Roman Way Business Centre Berry Hill Droitwich Worcester WR9 9AJ in data 25 gen 2017

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Units 9-10 Kelvin Way Trading Estate Kelvin Way West Bromwich West Midlands B70 7TP a Hillcairnie House St Andrews Road Droitwich Worcestershire WR9 8DJ in data 03 gen 2017

    1 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 12 dic 2016

    LRESEX

    Cessazione della carica di Gary William Richards come amministratore in data 25 feb 2016

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2016

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 set 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio annuale redatto al 12 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 set 2015

    Stato del capitale al 28 set 2015

    • Capitale: GBP 38,800
    SH01

    Nomina di Mr Gary Morton come amministratore in data 07 lug 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nicholas John Allen come segretario in data 07 lug 2015

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di John Charles Allen come amministratore in data 07 lug 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nicholas John Allen come amministratore in data 07 lug 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 gen 2015

    5 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    5 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 gen 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 set 2014

    Stato del capitale al 22 set 2014

    • Capitale: GBP 38,800
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 gen 2013

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 set 2013

    Stato del capitale al 19 set 2013

    • Capitale: GBP 38,800
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 gen 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 12 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di CENTRAL CRC LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ELWELL, Martyn Craig
    Kelvin Way Trading Estate
    Kelvin Way
    B70 7TP West Bromwich
    Units 9-10
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Kelvin Way Trading Estate
    Kelvin Way
    B70 7TP West Bromwich
    Units 9-10
    West Midlands
    England
    United KingdomBritish162351050001
    MORTON, Gary
    Roman Way Business Centre
    Berry Hill
    WR9 9AJ Droitwich
    11
    Worcester
    Amministratore
    Roman Way Business Centre
    Berry Hill
    WR9 9AJ Droitwich
    11
    Worcester
    EnglandBritish196967230001
    ALLEN, Nicholas John
    Kelvin Way Trading Estate
    Kelvin Way
    B70 7TP West Bromwich
    Units 9-10
    West Midlands
    Segretario
    Kelvin Way Trading Estate
    Kelvin Way
    B70 7TP West Bromwich
    Units 9-10
    West Midlands
    British162418380001
    COTTAM, Terry
    11 Penleigh Gardens
    WV5 8EJ Wombourne
    Staffordshire
    Segretario
    11 Penleigh Gardens
    WV5 8EJ Wombourne
    Staffordshire
    British46827200003
    ELWELL, Martyn
    Southerndown Road
    DY3 3NB Sedgley
    28
    West Midlands
    England
    Segretario
    Southerndown Road
    DY3 3NB Sedgley
    28
    West Midlands
    England
    British111560970003
    WARNER, Kevin
    34 Woodford Way
    Wombourne
    WV5 8HD Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    34 Woodford Way
    Wombourne
    WV5 8HD Wolverhampton
    West Midlands
    British70799890001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    ALLEN, John Charles
    Kelvin Way Trading Estate
    Kelvin Way
    B70 7TP West Bromwich
    Units 9-10
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Kelvin Way Trading Estate
    Kelvin Way
    B70 7TP West Bromwich
    Units 9-10
    West Midlands
    England
    United KingdomBritish2635730003
    ALLEN, Nicholas John
    Kelvin Way Tradfing Estate
    Kelvin Way
    B70 7TP West Bromwich
    Units 9-10
    West Midlands
    England
    Amministratore
    Kelvin Way Tradfing Estate
    Kelvin Way
    B70 7TP West Bromwich
    Units 9-10
    West Midlands
    England
    United KingdomBritish76490930001
    BRUNT, Christopher Kenneth
    45 St Dunstans Close
    WR5 2AJ Battenhall
    Worcestershire
    Amministratore
    45 St Dunstans Close
    WR5 2AJ Battenhall
    Worcestershire
    EnglandBritish112028530001
    COTTAM, Terry
    11 Penleigh Gardens
    WV5 8EJ Wombourne
    Staffordshire
    Amministratore
    11 Penleigh Gardens
    WV5 8EJ Wombourne
    Staffordshire
    British44295570003
    MARTIN, Julie Elizabeth
    5 Hagley Court South, The
    Waterfront, Brierley Hill
    DY5 1XE West Midlands
    Amministratore
    5 Hagley Court South, The
    Waterfront, Brierley Hill
    DY5 1XE West Midlands
    EnglandBritish147418700001
    MORTON, Gary
    Whitecross House 87 Orton Lane
    Lower Penn
    WV4 4XA Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Whitecross House 87 Orton Lane
    Lower Penn
    WV4 4XA Wolverhampton
    West Midlands
    EnglandBritish23063020003
    MORTON, Gary
    Whitecross House 87 Orton Lane
    Lower Penn
    WV4 4XA Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Whitecross House 87 Orton Lane
    Lower Penn
    WV4 4XA Wolverhampton
    West Midlands
    EnglandBritish23063020003
    MORTON, Karen Debra
    5 Hagley Court South, The
    Waterfront, Brierley Hill
    DY5 1XE West Midlands
    Amministratore
    5 Hagley Court South, The
    Waterfront, Brierley Hill
    DY5 1XE West Midlands
    EnglandBritish105223680001
    RICHARDS, Gary William
    232 Jockey Road
    B73 5XP Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    232 Jockey Road
    B73 5XP Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish89447760001
    WARNER, Kevin
    34 Woodford Way
    Wombourne
    WV5 8HD Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    34 Woodford Way
    Wombourne
    WV5 8HD Wolverhampton
    West Midlands
    British70799890001
    WILLIAMS, Jean
    8 Dixon Close
    Horseley Heath
    DY4 7NL Tipton
    West Midlands
    Amministratore
    8 Dixon Close
    Horseley Heath
    DY4 7NL Tipton
    West Midlands
    British47160570001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CENTRAL CRC LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Central Rpl Limited
    Kelvin Way Trading Estate Kelvin Way
    B70 7TP West Bromwich
    Units 9 - 10
    West Midlands
    England
    06 apr 2016
    Kelvin Way Trading Estate Kelvin Way
    B70 7TP West Bromwich
    Units 9 - 10
    West Midlands
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione01639887
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    CENTRAL CRC LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 29 lug 2011
    Consegnato il 11 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gary Morton Karen Debra Morton Sophie Morton Martyn Elwell Sarah Elwell David Lawrence Martin Julie Elizabeth Martin Marie-Claire Martin Michelle Martin Gary William Richards and Ann Richards
    Transazioni
    • 11 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 lug 2011
    Consegnato il 10 ago 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a land and buildings on the west side of tunnel road west bromwich t/nos WM416156 and WM54926 and such other land adjoining thereto.
    Persone aventi diritto
    • Gary Morton Karen Morton Sophie Morton Martyn Elwell Sarah Elwell David Lawrence Martin Julie Elizabeth Martin Marie-Claire Martin Michelle Martin Gary William Richards and Ann Richards
    Transazioni
    • 10 ago 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 lug 2011
    Consegnato il 30 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aldermore Invoice Finance, a Division of Aldermore Bank PLC
    Transazioni
    • 30 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 05 ott 2007
    Consegnato il 16 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a or being 3 tunnel road hill top west bromwich west midlands t/nos WM416156 & WM54926. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 07 giu 2007
    Consegnato il 14 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and conservatory roof craft limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    All assets debenture
    Creato il 19 apr 2007
    Consegnato il 25 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 25 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Single debenture
    Creato il 09 set 1995
    Consegnato il 15 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 15 set 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    CENTRAL CRC LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 mag 2018Data di scioglimento
    12 dic 2016Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Elijah Thomas Bowen
    Hillcairnie House St Andrews Road
    WR9 8DJ Droitwich
    Worcestershire
    Praticante
    Hillcairnie House St Andrews Road
    WR9 8DJ Droitwich
    Worcestershire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0