MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED

MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03095524
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Laporte Road
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    North East Lincolnshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MILLENNIUM CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED12 mar 199712 mar 1997
    SCM CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED10 feb 199710 feb 1997
    ADVICEPHONE LIMITED25 ago 199525 ago 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2023 al 31 dic 2022

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    6 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Millennium Inorganic Chemicals Overseas Holdings come persona con controllo significativo il 29 set 2021

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Tronox Pigment Uk Limited Laporte Road Stallingborough Grimsby North East Lincolnshire DN40 2PR England a 54 Portland Place London W1B 1DY

    1 pagineAD02

    Nomina di Broughton Secretaries Limited come segretario in data 04 giu 2021

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Intertrust (Uk) Limited come segretario in data 04 giu 2021

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    9 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2019

    23 pagineAA

    Nomina di Shirley Fodor come amministratore in data 20 ott 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Timothy Craig Carlson come amministratore in data 20 ott 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Laporte Road Stallingborough Grimsby North East Lincolnshire DN40 2PR England a Laporte Road Stallingborough Grimsby North East Lincolnshire DN40 2PR in data 01 apr 2020

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 35 Great St. Helen's London EC3A 6AP England a Laporte Road Stallingborough Grimsby North East Lincolnshire DN40 2PR in data 01 apr 2020

    1 pagineAD01

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    1 pagineDS02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2018 al 31 mar 2019

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Anthony Box il 13 set 2019

    2 pagineCH01

    Iscrizione dell'ipoteca 030955240005, creata il 30 ago 2019

    33 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 030955240006, creata il 30 ago 2019

    15 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROUGHTON SECRETARIES LIMITED
    Portland Place
    W1B 1DY London
    54
    England
    Segretario
    Portland Place
    W1B 1DY London
    54
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione04569914
    86181860001
    BOX, Stephen Anthony
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    Amministratore
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    EnglandBritish127739900007
    FODOR, Shirley
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    Amministratore
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    South AfricaSouth African275639510001
    KAYE, Steven Andrew
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    Amministratore
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    United StatesAmerican237611780001
    BARNETT, Paul Andrew Hannington
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Linconshire
    Segretario
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Linconshire
    British162523520001
    BOX, Stephen Anthony
    78 Thrunscoe Road
    DN35 8TF Cleethorpes
    North East Lincolnshire
    Segretario
    78 Thrunscoe Road
    DN35 8TF Cleethorpes
    North East Lincolnshire
    British84011430004
    CAMPBELL, Nicola
    4 The Coppice School Lane
    HP9 2SH Seer Green
    Buckinghamshire
    Segretario
    4 The Coppice School Lane
    HP9 2SH Seer Green
    Buckinghamshire
    British104418770001
    CARMEAN, C William
    121 East Delaware Avenue
    Pennington Nj
    Mercer 08534
    Usa
    Segretario
    121 East Delaware Avenue
    Pennington Nj
    Mercer 08534
    Usa
    Us80303570001
    FURLING, Jean-Herve Gustave
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Linconshire
    Segretario
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Linconshire
    British169880960001
    FURLING, Jean-Herve Gustave
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Linconshire
    Segretario
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Linconshire
    French127752720001
    HARDJOMOHAMAD, Nancy Julianie Fatima
    Claes De Vrieselaan 131 A
    FOREIGN 3021 Jj
    Rotterdam
    The Netherlands
    Segretario
    Claes De Vrieselaan 131 A
    FOREIGN 3021 Jj
    Rotterdam
    The Netherlands
    Dutch109911890001
    HEMPSTEAD, George
    46 Mulberry Lane
    Colts Neck
    New Jersey
    07722
    Usa
    Segretario
    46 Mulberry Lane
    Colts Neck
    New Jersey
    07722
    Usa
    American51269500001
    JEGHER, Maria
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Linconshire
    Segretario
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Linconshire
    250522970001
    OTTER, Jamie Edward
    1 Wesleyan Court
    LN2 5BU Lincoln
    Lincolnshire
    Segretario
    1 Wesleyan Court
    LN2 5BU Lincoln
    Lincolnshire
    British116380260001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    5 Matthews Chase
    Binfield
    RG42 4UR Bracknell
    Berkshire
    Segretario
    5 Matthews Chase
    Binfield
    RG42 4UR Bracknell
    Berkshire
    British28994800002
    WARD, Stephen
    41 Marapana Road
    6015 City Beach
    Australia
    Segretario
    41 Marapana Road
    6015 City Beach
    Australia
    Australian122389150001
    INTERTRUST (UK) LIMITED
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Segretario
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione06307550
    188126550001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALEXANDER, Samuel Ray
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Linconshire
    Amministratore
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Linconshire
    UsaAmerican120943450001
    BOX, Stephen Anthony
    34 Links Road
    DN35 0HX Cleethorpes
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    34 Links Road
    DN35 0HX Cleethorpes
    North East Lincolnshire
    EnglandBritish127739900007
    CARLSON, Timothy Craig
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    Amministratore
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    United StatesAmerican237611750001
    CARMEAN, C William
    121 East Delaware Avenue
    Pennington Nj
    Mercer 08534
    Usa
    Amministratore
    121 East Delaware Avenue
    Pennington Nj
    Mercer 08534
    Usa
    Us80303570001
    DOCX, Koen Felix Lodewijk
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Linconshire
    Amministratore
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Linconshire
    BelgiumBelgian162523910004
    DRANSFIELD, Graham
    Downs Hill
    BR3 5HB Beckenham
    18
    Kent
    Amministratore
    Downs Hill
    BR3 5HB Beckenham
    18
    Kent
    EnglandBritish4655640001
    FURLING, Jean-Herve Gustave
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Linconshire
    Amministratore
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Linconshire
    BelgiumFrench127752720001
    HEMPSTEAD, George
    46 Mulberry Lane
    Colts Neck
    New Jersey
    07722
    Usa
    Amministratore
    46 Mulberry Lane
    Colts Neck
    New Jersey
    07722
    Usa
    American51269500001
    HOLMES, Allen
    2631 Sutton Court
    Houston
    Tx 77027
    Texas
    Usa
    Amministratore
    2631 Sutton Court
    Houston
    Tx 77027
    Texas
    Usa
    American104418610001
    HORAN, John Francis
    77 Park Lane
    Fair Haven
    FOREIGN New Jersey
    Usa
    Amministratore
    77 Park Lane
    Fair Haven
    FOREIGN New Jersey
    Usa
    American91180590001
    HURRELL, Samantha Jane
    Saffron Wharf, 20 Shad Thames
    SE1 2YQ London
    Amministratore
    Saffron Wharf, 20 Shad Thames
    SE1 2YQ London
    British68385620001
    JONGEN, Rene
    Top Farm
    Cheapside Brigsley
    DN37 0HT Grimsby
    South Humberside
    Amministratore
    Top Farm
    Cheapside Brigsley
    DN37 0HT Grimsby
    South Humberside
    Australian127740860001
    LEE, Raymond Frederick
    19 Oak Road
    Healing
    DN41 7RJ Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    19 Oak Road
    Healing
    DN41 7RJ Grimsby
    North East Lincolnshire
    Australian84010820001
    LEE, Robert Edward
    5 Pellinore Court
    Baltimore
    Maryland
    21208
    Usa
    Amministratore
    5 Pellinore Court
    Baltimore
    Maryland
    21208
    Usa
    American51260430004
    LUDLAM, Kenneth John
    16 Woodchurch Drive
    BR1 2TH Bromley
    Kent
    Amministratore
    16 Woodchurch Drive
    BR1 2TH Bromley
    Kent
    United KingdomBritish3893370001
    LUSHEFSKI, John Edward
    52 Bellevue Avenue
    Rumson
    FOREIGN New Jersey
    07760
    Usa
    Amministratore
    52 Bellevue Avenue
    Rumson
    FOREIGN New Jersey
    07760
    Usa
    American51260400001
    MCINTYRE, Robert, Dr
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Linconshire
    Amministratore
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Linconshire
    United KingdomBritish127734580001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    06 apr 2016
    Stallingborough
    DN40 2PR Grimsby
    Laporte Road
    North East Lincolnshire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleEngland & Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02362264
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 30 ago 2019
    Consegnato il 10 set 2019
    In corso
    Breve descrizione
    Not applicable.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of America, N.A. (As Collateral Agent)
    Transazioni
    • 10 set 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 ago 2019
    Consegnato il 10 set 2019
    In corso
    Breve descrizione
    Various intellecutual property held in the name of millennium inorganic chemicals UK holdings limited including: "composition for use nox removing translucent coating" bearing application no. 04706742.6 and patent no. 1706360. please refer to the security instruments supplement to schedule 5.2, ii. Intellectual property, part (c) for additional details and listings.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Bank of America, N.A. (As Collateral Agent)
    Transazioni
    • 10 set 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 ago 2019
    Consegnato il 05 set 2019
    In corso
    Breve descrizione
    Intellectual property. See clause 2.3(b)(i) of the debenture accession deed which creates a fixed charge over all rights, title and interest in the intellectual property (as defined in the debenture accession deed).
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Bank, National Association
    Transazioni
    • 05 set 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 ago 2019
    Consegnato il 05 set 2019
    In corso
    Breve descrizione
    Intellectual property. See section 2.1 of the pledge and security agreement which creates a fixed charge over all intellectual property (as defined in the pledge and security agreement) including the following:. Country/. Jurisdiction patent title application no. Filing date patent no. Issue date registered owner status. United kingdom coating composition having surface depolluting properties 05702293.1 1/10/2005 1709125 4/7/2010 millennium inorganic chemicals UK holdings limited issued. United kingdom composition for use nox removing translucent coating 04706742.6 1/30/2004 1706360 1/22/2014 millennium inorganic chemicals UK holdings limited issued. Mexico coating composition having surface depolluting properties pa/a/2006/008479 1/19/2005 292897 12/1/2011 millennium inorganic chemicals UK holdings limited issued. Please also see section ii(c) of the supplement to schedule 5.2 to the pledge and security agreement (this section includes further charged intellectual property).
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Bank, National Association
    Transazioni
    • 05 set 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A second lien debenture
    Creato il 15 mag 2007
    Consegnato il 31 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the real property, the accounts, the intellectual property, any goodwill, uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank Usa, National Association as Administrative Agent for the Secured Parties (The Secondlien Administrative Agent)
    Transazioni
    • 31 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A first lien debenture
    Creato il 15 mag 2007
    Consegnato il 31 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the real property, the accounts, the intellectual property, any goodwill, uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank Usa, National Association as Administrative Agent for the Secured Parties (The Firstlien Administrative Agent)
    Transazioni
    • 31 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0