MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03095524 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED?
- Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Laporte Road Stallingborough DN40 2PR Grimsby North East Lincolnshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| MILLENNIUM CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED | 12 mar 1997 | 12 mar 1997 |
| SCM CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED | 10 feb 1997 | 10 feb 1997 |
| ADVICEPHONE LIMITED | 25 ago 1995 | 25 ago 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2023 al 31 dic 2022 | 1 pagine | AA01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 6 pagine | AA | ||
Modifica dei dettagli di Millennium Inorganic Chemicals Overseas Holdings come persona con controllo significativo il 29 set 2021 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Tronox Pigment Uk Limited Laporte Road Stallingborough Grimsby North East Lincolnshire DN40 2PR England a 54 Portland Place London W1B 1DY | 1 pagine | AD02 | ||
Nomina di Broughton Secretaries Limited come segretario in data 04 giu 2021 | 2 pagine | AP04 | ||
Cessazione della carica di Intertrust (Uk) Limited come segretario in data 04 giu 2021 | 1 pagine | TM02 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 9 pagine | AA | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2019 | 23 pagine | AA | ||
Nomina di Shirley Fodor come amministratore in data 20 ott 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Timothy Craig Carlson come amministratore in data 20 ott 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Laporte Road Stallingborough Grimsby North East Lincolnshire DN40 2PR England a Laporte Road Stallingborough Grimsby North East Lincolnshire DN40 2PR in data 01 apr 2020 | 1 pagine | AD01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 35 Great St. Helen's London EC3A 6AP England a Laporte Road Stallingborough Grimsby North East Lincolnshire DN40 2PR in data 01 apr 2020 | 1 pagine | AD01 | ||
Ritiro della richiesta di cancellazione della società | 1 pagine | DS02 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2018 al 31 mar 2019 | 1 pagine | AA01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Anthony Box il 13 set 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 030955240005, creata il 30 ago 2019 | 33 pagine | MR01 | ||
Iscrizione dell'ipoteca 030955240006, creata il 30 ago 2019 | 15 pagine | MR01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 ago 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROUGHTON SECRETARIES LIMITED | Segretario | Portland Place W1B 1DY London 54 England |
| 86181860001 | ||||||||||
| BOX, Stephen Anthony | Amministratore | Stallingborough DN40 2PR Grimsby Laporte Road North East Lincolnshire England | England | British | 127739900007 | |||||||||
| FODOR, Shirley | Amministratore | Stallingborough DN40 2PR Grimsby Laporte Road North East Lincolnshire England | South Africa | South African | 275639510001 | |||||||||
| KAYE, Steven Andrew | Amministratore | Stallingborough DN40 2PR Grimsby Laporte Road North East Lincolnshire England | United States | American | 237611780001 | |||||||||
| BARNETT, Paul Andrew Hannington | Segretario | Stallingborough DN40 2PR Grimsby Laporte Road North East Linconshire | British | 162523520001 | ||||||||||
| BOX, Stephen Anthony | Segretario | 78 Thrunscoe Road DN35 8TF Cleethorpes North East Lincolnshire | British | 84011430004 | ||||||||||
| CAMPBELL, Nicola | Segretario | 4 The Coppice School Lane HP9 2SH Seer Green Buckinghamshire | British | 104418770001 | ||||||||||
| CARMEAN, C William | Segretario | 121 East Delaware Avenue Pennington Nj Mercer 08534 Usa | Us | 80303570001 | ||||||||||
| FURLING, Jean-Herve Gustave | Segretario | Stallingborough DN40 2PR Grimsby Laporte Road North East Linconshire | British | 169880960001 | ||||||||||
| FURLING, Jean-Herve Gustave | Segretario | Stallingborough DN40 2PR Grimsby Laporte Road North East Linconshire | French | 127752720001 | ||||||||||
| HARDJOMOHAMAD, Nancy Julianie Fatima | Segretario | Claes De Vrieselaan 131 A FOREIGN 3021 Jj Rotterdam The Netherlands | Dutch | 109911890001 | ||||||||||
| HEMPSTEAD, George | Segretario | 46 Mulberry Lane Colts Neck New Jersey 07722 Usa | American | 51269500001 | ||||||||||
| JEGHER, Maria | Segretario | Stallingborough DN40 2PR Grimsby Laporte Road North East Linconshire | 250522970001 | |||||||||||
| OTTER, Jamie Edward | Segretario | 1 Wesleyan Court LN2 5BU Lincoln Lincolnshire | British | 116380260001 | ||||||||||
| TYSON, Roger Thomas Virley | Segretario | 5 Matthews Chase Binfield RG42 4UR Bracknell Berkshire | British | 28994800002 | ||||||||||
| WARD, Stephen | Segretario | 41 Marapana Road 6015 City Beach Australia | Australian | 122389150001 | ||||||||||
| INTERTRUST (UK) LIMITED | Segretario | Great St. Helen's EC3A 6AP London 35 England |
| 188126550001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| ALEXANDER, Samuel Ray | Amministratore | Stallingborough DN40 2PR Grimsby Laporte Road North East Linconshire | Usa | American | 120943450001 | |||||||||
| BOX, Stephen Anthony | Amministratore | 34 Links Road DN35 0HX Cleethorpes North East Lincolnshire | England | British | 127739900007 | |||||||||
| CARLSON, Timothy Craig | Amministratore | Stallingborough DN40 2PR Grimsby Laporte Road North East Lincolnshire England | United States | American | 237611750001 | |||||||||
| CARMEAN, C William | Amministratore | 121 East Delaware Avenue Pennington Nj Mercer 08534 Usa | Us | 80303570001 | ||||||||||
| DOCX, Koen Felix Lodewijk | Amministratore | Stallingborough DN40 2PR Grimsby Laporte Road North East Linconshire | Belgium | Belgian | 162523910004 | |||||||||
| DRANSFIELD, Graham | Amministratore | Downs Hill BR3 5HB Beckenham 18 Kent | England | British | 4655640001 | |||||||||
| FURLING, Jean-Herve Gustave | Amministratore | Stallingborough DN40 2PR Grimsby Laporte Road North East Linconshire | Belgium | French | 127752720001 | |||||||||
| HEMPSTEAD, George | Amministratore | 46 Mulberry Lane Colts Neck New Jersey 07722 Usa | American | 51269500001 | ||||||||||
| HOLMES, Allen | Amministratore | 2631 Sutton Court Houston Tx 77027 Texas Usa | American | 104418610001 | ||||||||||
| HORAN, John Francis | Amministratore | 77 Park Lane Fair Haven FOREIGN New Jersey Usa | American | 91180590001 | ||||||||||
| HURRELL, Samantha Jane | Amministratore | Saffron Wharf, 20 Shad Thames SE1 2YQ London | British | 68385620001 | ||||||||||
| JONGEN, Rene | Amministratore | Top Farm Cheapside Brigsley DN37 0HT Grimsby South Humberside | Australian | 127740860001 | ||||||||||
| LEE, Raymond Frederick | Amministratore | 19 Oak Road Healing DN41 7RJ Grimsby North East Lincolnshire | Australian | 84010820001 | ||||||||||
| LEE, Robert Edward | Amministratore | 5 Pellinore Court Baltimore Maryland 21208 Usa | American | 51260430004 | ||||||||||
| LUDLAM, Kenneth John | Amministratore | 16 Woodchurch Drive BR1 2TH Bromley Kent | United Kingdom | British | 3893370001 | |||||||||
| LUSHEFSKI, John Edward | Amministratore | 52 Bellevue Avenue Rumson FOREIGN New Jersey 07760 Usa | American | 51260400001 | ||||||||||
| MCINTYRE, Robert, Dr | Amministratore | Stallingborough DN40 2PR Grimsby Laporte Road North East Linconshire | United Kingdom | British | 127734580001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millennium Inorganic Chemicals Overseas Holdings | 06 apr 2016 | Stallingborough DN40 2PR Grimsby Laporte Road North East Lincolnshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MILLENNIUM INORGANIC CHEMICALS UK HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 30 ago 2019 Consegnato il 10 set 2019 | In corso | ||
Breve descrizione Not applicable. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 30 ago 2019 Consegnato il 10 set 2019 | In corso | ||
Breve descrizione Various intellecutual property held in the name of millennium inorganic chemicals UK holdings limited including: "composition for use nox removing translucent coating" bearing application no. 04706742.6 and patent no. 1706360. please refer to the security instruments supplement to schedule 5.2, ii. Intellectual property, part (c) for additional details and listings. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 30 ago 2019 Consegnato il 05 set 2019 | In corso | ||
Breve descrizione Intellectual property. See clause 2.3(b)(i) of the debenture accession deed which creates a fixed charge over all rights, title and interest in the intellectual property (as defined in the debenture accession deed). L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 30 ago 2019 Consegnato il 05 set 2019 | In corso | ||
Breve descrizione Intellectual property. See section 2.1 of the pledge and security agreement which creates a fixed charge over all intellectual property (as defined in the pledge and security agreement) including the following:. Country/. Jurisdiction patent title application no. Filing date patent no. Issue date registered owner status. United kingdom coating composition having surface depolluting properties 05702293.1 1/10/2005 1709125 4/7/2010 millennium inorganic chemicals UK holdings limited issued. United kingdom composition for use nox removing translucent coating 04706742.6 1/30/2004 1706360 1/22/2014 millennium inorganic chemicals UK holdings limited issued. Mexico coating composition having surface depolluting properties pa/a/2006/008479 1/19/2005 292897 12/1/2011 millennium inorganic chemicals UK holdings limited issued. Please also see section ii(c) of the supplement to schedule 5.2 to the pledge and security agreement (this section includes further charged intellectual property). Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A second lien debenture | Creato il 15 mag 2007 Consegnato il 31 mag 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first fixed charge the real property, the accounts, the intellectual property, any goodwill, uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A first lien debenture | Creato il 15 mag 2007 Consegnato il 31 mag 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first fixed charge the real property, the accounts, the intellectual property, any goodwill, uncalled capital. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0