ROBIN A TECHNOLOGY REALISATIONS PLC

ROBIN A TECHNOLOGY REALISATIONS PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàROBIN A TECHNOLOGY REALISATIONS PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 03095862
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ROBIN A TECHNOLOGY REALISATIONS PLC?

    • Attività di consulenza in tecnologie dell'informazione (62020) / Informazione e comunicazione
    • Trattamento dei dati, hosting e attività correlate (63110) / Informazione e comunicazione
    • Attività di consulenza ambientale (74901) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova ROBIN A TECHNOLOGY REALISATIONS PLC?

    Indirizzo della sede legale
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ROBIN A TECHNOLOGY REALISATIONS PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AEA TECHNOLOGY PLC14 dic 199514 dic 1995
    2037TH SHELF INVESTMENT COMPANY LIMITED29 ago 199529 ago 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di ROBIN A TECHNOLOGY REALISATIONS PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per ROBIN A TECHNOLOGY REALISATIONS PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    22 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ott 2018

    22 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ott 2017

    23 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ott 2016

    22 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ott 2015

    19 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 ott 2014

    19 pagine4.68

    Cessazione della carica di Judith Cottrell come amministratore in data 25 set 2014

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Timothy John Curtis come amministratore in data 15 set 2014

    2 pagineTM01

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 30 ott 2013

    28 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Risultato della riunione dei creditori

    1 pagine2.23B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 07 mag 2013

    27 pagine2.24B

    Cessazione della carica di Kevin Higginson come amministratore

    2 pagineTM01

    Risultato della riunione dei creditori

    2 pagine2.23B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B

    56 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    30 pagine2.17B

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed aea technology PLC\certificate issued on 22/11/12
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name22 nov 2012

    Risoluzione di cambio di nome della società il 21 nov 2012

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Indirizzo della sede legale modificato da * Gemini Building Fermi Avenue Harwell Didcot Oxfordshire OX11 0QR England* in data 15 nov 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Chi sono gli amministratori di ROBIN A TECHNOLOGY REALISATIONS PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COTTRELL, Judith
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Llp
    Segretario
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Llp
    169075970001
    BELL, Robert Thomas
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Llp
    Amministratore
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Llp
    EnglandBritishCoo88691480001
    MASON, John Gerard
    Tall Trees 11 Rimes Close
    Kingston Bagpuize
    OX13 5AL Abingdon
    Oxfordshire
    Segretario
    Tall Trees 11 Rimes Close
    Kingston Bagpuize
    OX13 5AL Abingdon
    Oxfordshire
    British78919880002
    OWEN, Jennifer Margaret
    c/o Aea Technology Plc
    New Street Square
    EC4A 3BF London
    6
    London
    England
    Segretario
    c/o Aea Technology Plc
    New Street Square
    EC4A 3BF London
    6
    London
    England
    153020970001
    PARKER, Michael Jonathan Francis
    329 Harwell
    Didcot
    OX11 0QJ Oxfordshire
    Segretario
    329 Harwell
    Didcot
    OX11 0QJ Oxfordshire
    150275510001
    ROPER, Philip
    329 Harwell
    Didcot
    OX11 0QJ Oxfordshire
    Segretario
    329 Harwell
    Didcot
    OX11 0QJ Oxfordshire
    BritishAccountant104844230001
    RUSSELL, Keith John
    Elsfield Crafts End
    Chilton
    OX11 0SA Didcot
    Oxfordshire
    Segretario
    Elsfield Crafts End
    Chilton
    OX11 0SA Didcot
    Oxfordshire
    British44863460001
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Segretario nominato
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900001770001
    ATKINSON, Leslie, Dr
    Cobbs 62 The Street
    Manuden
    CM23 1DS Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Cobbs 62 The Street
    Manuden
    CM23 1DS Bishops Stortford
    Hertfordshire
    UkBritishCompany Director66795350002
    BRADY, John Michael, Prof. Sir
    4 Dominus Way Meridian Business Park
    LE19 1RP Leicester
    Amministratore
    4 Dominus Way Meridian Business Park
    LE19 1RP Leicester
    United KingdomBritishProfessor118605440001
    BULKIN, Bernard Joseph
    Hodford Road
    NW11 8NN London
    34
    Amministratore
    Hodford Road
    NW11 8NN London
    34
    EnglandBritishConsultant85310260001
    CAMPBELL, Gordon Arden
    The Parks
    Eastcote Lane Hampton In Arden
    B92 0AS Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    The Parks
    Eastcote Lane Hampton In Arden
    B92 0AS Solihull
    West Midlands
    BritishDirector14980740001
    CLEAVER, Anthony Brian, Sir
    20 Groom Place
    SW1X 7BA London
    Amministratore
    20 Groom Place
    SW1X 7BA London
    EnglandBritishDirector64551510001
    COTTRELL, Judith
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Llp
    Amministratore
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Llp
    United KingdomBritishDirector100656000002
    CUMMINGS, Alice Sarah Louise
    c/o Aea Technology Plc
    New Street Square
    EC4A 3BF London
    6
    London
    England
    Amministratore
    c/o Aea Technology Plc
    New Street Square
    EC4A 3BF London
    6
    London
    England
    EnglandBritishChartered Accountant91197880001
    CURTIS, Timothy John
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Llp
    Amministratore
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Llp
    United KingdomBritishDirector161577060001
    EYRE, Brian Leonard, Doctor
    Loughrigg Newbury Road
    East Hendred
    OX12 8LG Wantage
    Oxfordshire
    Amministratore
    Loughrigg Newbury Road
    East Hendred
    OX12 8LG Wantage
    Oxfordshire
    BritishMetallurgist71071890002
    GOLBY, Paul, Dr
    329 Harwell
    Didcot
    OX11 0QJ Oxfordshire
    Amministratore
    329 Harwell
    Didcot
    OX11 0QJ Oxfordshire
    United KingdomBritishChief Executive155012180001
    HIGGINSON, Kevin Mark
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Llp
    Amministratore
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg Llp
    EnglandBritishCfo190472550001
    HIPPSLEY, Charles
    Ashcroft Close
    OX2 9SE Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    Ashcroft Close
    OX2 9SE Oxford
    Oxfordshire
    BritishCompany Director83831170001
    LINDSAY, David
    92 Sandringham Road
    WD24 7BE Watford
    Hertfordshire
    Amministratore
    92 Sandringham Road
    WD24 7BE Watford
    Hertfordshire
    BritishFinance Director78093740001
    MCCREE, Andrew Charles Gambon
    c/o Aea Technology Plc
    New Street Square
    EC4A 3BF London
    6
    London
    England
    Amministratore
    c/o Aea Technology Plc
    New Street Square
    EC4A 3BF London
    6
    London
    England
    EnglandBritishCompany Director73351270004
    MOONIE, Lewis George, Lord
    85 Sauchenbush Road
    KY2 5RN Kirkcaldy
    Fife
    Amministratore
    85 Sauchenbush Road
    KY2 5RN Kirkcaldy
    Fife
    United KingdomBritishWorking Peer95052530001
    NIGRO, Michael Joseph
    329 Harwell
    Didcot
    OX11 0QJ Oxfordshire
    Amministratore
    329 Harwell
    Didcot
    OX11 0QJ Oxfordshire
    UsaUnited StatesDirector133069940001
    PROCTOR, Raymond
    Meadow House
    25 Summer Lane
    DE4 4EB Wirksworth
    Derbyshire
    Amministratore
    Meadow House
    25 Summer Lane
    DE4 4EB Wirksworth
    Derbyshire
    United KingdomBritishAccountant42424650002
    SHARMAN OF REDLYNCH, Colin, Lord
    Manor Farm
    Teffont Magna
    SP3 5QY Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Manor Farm
    Teffont Magna
    SP3 5QY Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishChartered Accountant66768660001
    SHILSTON, Andrew Barkley
    96 Oakhill Road
    TN13 1NU Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    96 Oakhill Road
    TN13 1NU Sevenoaks
    Kent
    BritishFinance Director36182580001
    SHIRLEY, Vera Stephanie, Dame
    47 Thames House
    Phyllis Court Drive
    RG9 2NA Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    47 Thames House
    Phyllis Court Drive
    RG9 2NA Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritishCompany Director18089720002
    THORNTON, Stephen Patrick
    66 Eaton Place
    Top Flat
    SW1X 8AT London
    Amministratore
    66 Eaton Place
    Top Flat
    SW1X 8AT London
    BritishDirector96048220001
    VENTRIS, Gwendoline
    329 Harwell
    Didcot
    OX11 0QJ Oxfordshire
    Amministratore
    329 Harwell
    Didcot
    OX11 0QJ Oxfordshire
    EnglandBritishCompany Director13311450002
    WATSON, John Michael
    Bank House
    High Street
    OX7 6BA Shipton Under Wychwood
    Oxfordshire
    Amministratore
    Bank House
    High Street
    OX7 6BA Shipton Under Wychwood
    Oxfordshire
    EnglandBritishChartered Engineer85376850001
    WATSON, Peter
    49 Suckling Green Lane
    WV8 2BT Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    49 Suckling Green Lane
    WV8 2BT Wolverhampton
    West Midlands
    EnglandBritishChief Executive118957580001
    WESTHEAD, Rodney James
    329 Harwell
    Didcot
    OX11 0QJ Oxfordshire
    Amministratore
    329 Harwell
    Didcot
    OX11 0QJ Oxfordshire
    EnglandBritishCeo25196960001
    WOOD, Melvyn Harry
    6 Orchard Close
    Corfe Mullen
    BH21 3TW Wimborne
    Dorset
    Amministratore
    6 Orchard Close
    Corfe Mullen
    BH21 3TW Wimborne
    Dorset
    BritishPhysicist35740750001
    WRIGHT, Christopher John, Dr
    22 Pettiwell
    Garsington
    OX44 9DB Oxford
    The Malthouse
    United Kingdom
    Amministratore
    22 Pettiwell
    Garsington
    OX44 9DB Oxford
    The Malthouse
    United Kingdom
    United KingdomBritishEngineer131895700001

    ROBIN A TECHNOLOGY REALISATIONS PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An english law governed security agreement
    Creato il 05 ago 2012
    Consegnato il 14 ago 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from an obligor to any finance party and all monies not exceeding £2,000,000 due or to become due from original borrowers to the ancillary lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 30 mag 2012
    Consegnato il 01 giu 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The tenants rights and interest in the deposit account the rent deposit being £45,776.25 the deposit balance and any income moneys and proceeds paid or payable see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Almacantar Private Trustee Company Limited and Almacantar Private Trustee Company (No.2) Limited
    Transazioni
    • 01 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    - omnibus letter of set-off
    Creato il 11 feb 2011
    Consegnato il 17 feb 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 17 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Shares pledge
    Creato il 14 giu 2005
    Consegnato il 27 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to a facility creditor and to an external ancillary provider and all monies due or to become due from any contributing employer under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The right title interest and benefit in and to the security shares being the investments together with all investments rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 27 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Pledge agreement
    Creato il 14 giu 2005
    Consegnato il 27 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to a facility creditor and to an external ancillary provider and all monies due or to become due from any contributing employer under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in to and under the collateral being the initial pledged equity, all cash securities or other property representing a dividend or other distribution out of income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 27 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 14 giu 2005
    Consegnato il 27 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to a facility creditor and to an external ancillary provider and all monies due or to become due from any contributing employer under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 27 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2005Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 28 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share pledge agreement
    Creato il 13 giu 2005
    Consegnato il 27 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any pledgee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The existing share and all additional shares in the registered share capital of the gmbh. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 27 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit agreement
    Creato il 20 lug 1999
    Consegnato il 24 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease dated 27 january 1998
    Brevi particolari
    The sum deposit of £2,375.00.
    Persone aventi diritto
    • Robert Ian Gordon Finlayson
    Transazioni
    • 24 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 giu 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ROBIN A TECHNOLOGY REALISATIONS PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 nov 2012Inizio dell'amministrazione
    30 ott 2013Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    William James Wright
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praticante
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praticante
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    2
    DataTipo
    30 ott 2013Inizio della liquidazione
    08 apr 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    William James Wright
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praticante
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praticante
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0