CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED

CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03099160
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED?

    • (7487) /
    • (9305) /

    Dove si trova CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Santia House
    Caerphilly Business Park
    CF83 3GG Caerphilly
    Mid Glamorgan
    Wales
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CONNAUGHT GASFORCE LIMITED17 gen 200717 gen 2007
    GASFORCE LIMITED01 set 199501 set 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ago 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rinvio della dissoluzione

    1 pagineL64.04

    Completamento della liquidazione

    1 pagineL64.07

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Cessazione della carica di Ian Carlisle come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Julia Cavanagh come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Julia Cavanagh come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Wells come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Connaught House Grenadier Road Exeter Business Park Exeter Devon EX1 3QF* in data 01 dic 2010

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Francis Wells il 02 nov 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Francis Wells il 02 nov 2010

    2 pagineCH01

    legacy

    6 pagineMG04

    legacy

    5 pagineMG04

    legacy

    3 pagineMG04

    Nomina di Julia Cavanagh come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 set 2010

    Stato del capitale al 07 set 2010

    • Capitale: GBP 1,296,931
    SH01

    Cessazione della carica di Stephen Hill come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Tincknell come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 ago 2009

    32 pagineAA

    Cessazione della carica di Mark Davies come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Julia Cavanagh come segretario

    1 pagineAP03

    Nomina di Mr Ian Carlisle come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Prowse come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 set 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAVANAGH, Julia
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Segretario
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    British146809420001
    HURST, Paul Stuart
    68 Abbot Meadow
    Penwortham
    PR1 9JX Preston
    Lancashire
    Segretario
    68 Abbot Meadow
    Penwortham
    PR1 9JX Preston
    Lancashire
    British22359600001
    JAMES, Royston
    St Jude
    Glynbargoed Close Treharris
    CF46 6AA Merthyr Tydfil
    Mid Glam
    Segretario
    St Jude
    Glynbargoed Close Treharris
    CF46 6AA Merthyr Tydfil
    Mid Glam
    British14506510001
    JONES, Graham William John
    14 Whitehall Gardens
    Undy Magor
    NP6 3EW Newport
    Gwent
    Segretario
    14 Whitehall Gardens
    Undy Magor
    NP6 3EW Newport
    Gwent
    British44462340001
    PEAGAM, Garry John
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    Segretario
    The Four Winds 54 Middle Stoke
    Limpley Stoke
    BA2 7GG Bath
    BritishGroup Finance Director64426280002
    PHILLIPS, Jackey
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    Segretario
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    Devon
    British104367080003
    PIKE, David Kenneth
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    Segretario
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    BritishFinance Director99914770001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BROOK, Richard William
    Stonebrook 7a Foxholes Crescent
    Calverley
    LS28 5NT Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    Stonebrook 7a Foxholes Crescent
    Calverley
    LS28 5NT Leeds
    Yorkshire
    BritishDivisional Manager42200750001
    CARLISLE, Ian
    Caerphilly Business Park
    CF83 3GG Caerphilly
    Santia House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Amministratore
    Caerphilly Business Park
    CF83 3GG Caerphilly
    Santia House
    Mid Glamorgan
    Wales
    EnglandBritishChief Executive146715900001
    CAVANAGH, Julia
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    United Kingdom
    Amministratore
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3QF Exeter
    Connaught House
    United Kingdom
    United KingdomBritish-140133020001
    DARBY SHIRE, Ian
    High Barn
    BD23 3PU Flasby
    North Yorkshire
    Amministratore
    High Barn
    BD23 3PU Flasby
    North Yorkshire
    BritishManaging Director101620840001
    DAVIES, Mark Dingad
    Cold Ash Farm
    Long Lane
    RG18 9LT Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Cold Ash Farm
    Long Lane
    RG18 9LT Newbury
    Berkshire
    EnglandBritishDirector203044250004
    FALLOW, John Ronald Thomlinson
    Oakridge Chiltern Hill
    SL9 9TY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Oakridge Chiltern Hill
    SL9 9TY Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishRegional Service Director45848980001
    GREGORY, Alan James
    Edenhurst Cottage 3 Sheep Hill Lane
    New Longton
    PR4 4ZN Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Edenhurst Cottage 3 Sheep Hill Lane
    New Longton
    PR4 4ZN Preston
    Lancashire
    BritishManager45849250001
    HILL, Stephen Ronald
    Oakfield House
    Stoke Hill
    EX4 9JN Exeter
    Devon
    Amministratore
    Oakfield House
    Stoke Hill
    EX4 9JN Exeter
    Devon
    United KingdomBritishFinance Director115233060001
    HURST, Paul Stuart
    68 Abbot Meadow
    Penwortham
    PR1 9JX Preston
    Lancashire
    Amministratore
    68 Abbot Meadow
    Penwortham
    PR1 9JX Preston
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director22359600001
    JAMES, Royston
    St Jude
    Glynbargoed Close Treharris
    CF46 6AA Merthyr Tydfil
    Mid Glam
    Amministratore
    St Jude
    Glynbargoed Close Treharris
    CF46 6AA Merthyr Tydfil
    Mid Glam
    BritishService Officer14506510001
    MCCLUNE, Neil Kenneth
    7 Old Fox Close
    CR3 5QU Caterham
    Surrey
    Amministratore
    7 Old Fox Close
    CR3 5QU Caterham
    Surrey
    BritishService Technician49736330001
    MILTON, Anthony William
    65 Wannock Lane
    Lower Willingdon
    BN20 9SE Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    65 Wannock Lane
    Lower Willingdon
    BN20 9SE Eastbourne
    East Sussex
    BritishGas Service Manager45849130001
    ORD, John Raymond
    17 Langham Place
    Highwoods
    CO4 9GB Colchester
    Essex
    Amministratore
    17 Langham Place
    Highwoods
    CO4 9GB Colchester
    Essex
    United KingdomBritishGeneral Manager101450630001
    PIKE, David Kenneth
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    Willow House
    100 Sandford View
    TQ12 2TH Newton Abbot
    Devon
    EnglandBritishFinance Director99914770001
    PROWSE, John
    317 Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    Essex
    Amministratore
    317 Ongar Road
    CM15 9HP Brentwood
    Essex
    EnglandBritishDirector96786510001
    SIMMONDS, Michael Kenneth
    36 Byron Road
    CR2 8DY Selsdon
    Surrey
    Amministratore
    36 Byron Road
    CR2 8DY Selsdon
    Surrey
    BritishTechnician72441900001
    TINCKNELL, Mark William
    Hayne Barton
    Tipton St. John
    EX10 0AL Sidmouth
    Devon
    Amministratore
    Hayne Barton
    Tipton St. John
    EX10 0AL Sidmouth
    Devon
    EnglandBritishDirector4088810003
    WELLS, David Francis
    Caerphilly Business Park
    CF83 3GG Caerphilly
    Santia House
    Mid Glamorgan
    Wales
    Amministratore
    Caerphilly Business Park
    CF83 3GG Caerphilly
    Santia House
    Mid Glamorgan
    Wales
    United KingdomBritishAccountant104366980002
    WOODLEY, Eustace Vernon
    155 Highfield Road
    Idle
    BD10 8QN Bradford
    Amministratore
    155 Highfield Road
    Idle
    BD10 8QN Bradford
    BritishIndustrial Service Engineer45849310002

    CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage of shares
    Creato il 06 ago 2009
    Consegnato il 25 ago 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the shares and interest in the shares including all related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security agreement
    Creato il 06 ago 2009
    Consegnato il 25 ago 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wilmington Trust (London) Limited as Trustee for the Holders of the Notes (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Security agreement
    Creato il 10 lug 2009
    Consegnato il 23 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (Note Hedging Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    Mortgage of shares
    Creato il 10 lug 2009
    Consegnato il 23 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first equitable mortgage all the shares owned by the chargor or held by any nominee on its behalf in the share capital of each mortgaged company, including any dividend. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Note Hedging Security Trustee)
    Transazioni
    • 23 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    A security agreement
    Creato il 17 ago 2007
    Consegnato il 31 ago 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transazioni
    • 31 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    A mortgage of shares agreement
    Creato il 17 ago 2007
    Consegnato il 31 ago 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the shares owned by it (including all related rights). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Agent and Trustee for the Financeparties
    Transazioni
    • 31 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 13 dic 2006
    Consegnato il 16 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC Acting as Security Trustee for Itself and for Each of Thefinance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 16 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 mag 2004
    Consegnato il 20 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 20 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 ago 2002
    Consegnato il 24 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 20 mar 1997
    Consegnato il 22 mar 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mar 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 mag 1996
    Consegnato il 31 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £750,000 together with all other monies due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • British Gas PLC
    Transazioni
    • 31 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    09 giu 2016Conclusione della liquidazione
    07 giu 2011Data della petizione
    20 lug 2011Inizio della liquidazione
    10 mar 2022Data di scioglimento
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or Cardiff
    3rd Floor, Companies House Crown Way
    CF14 3ZA Cardiff
    Praticante
    3rd Floor, Companies House Crown Way
    CF14 3ZA Cardiff

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0