CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED
Panoramica
Nome della società | CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03099160 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED?
- (7487) /
- (9305) /
Dove si trova CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Santia House Caerphilly Business Park CF83 3GG Caerphilly Mid Glamorgan Wales |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CONNAUGHT GASFORCE LIMITED | 17 gen 2007 | 17 gen 2007 |
GASFORCE LIMITED | 01 set 1995 | 01 set 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 ago 2009 |
Quali sono le ultime deposizioni per CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Rinvio della dissoluzione | 1 pagine | L64.04 | ||||||||||
Completamento della liquidazione | 1 pagine | L64.07 | ||||||||||
Ordine del tribunale di liquidazione | 2 pagine | COCOMP | ||||||||||
Ordine del tribunale di liquidazione | 2 pagine | COCOMP | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Carlisle come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Julia Cavanagh come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Julia Cavanagh come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Wells come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Connaught House Grenadier Road Exeter Business Park Exeter Devon EX1 3QF* in data 01 dic 2010 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Francis Wells il 02 nov 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Francis Wells il 02 nov 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
legacy | 6 pagine | MG04 | ||||||||||
legacy | 5 pagine | MG04 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG04 | ||||||||||
Nomina di Julia Cavanagh come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 set 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Hill come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Tincknell come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 ago 2009 | 32 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Davies come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Julia Cavanagh come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr Ian Carlisle come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Prowse come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 set 2009 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAVANAGH, Julia | Segretario | Grenadier Road Exeter Business Park EX1 3QF Exeter Connaught House Devon | British | 146809420001 | ||||||
HURST, Paul Stuart | Segretario | 68 Abbot Meadow Penwortham PR1 9JX Preston Lancashire | British | 22359600001 | ||||||
JAMES, Royston | Segretario | St Jude Glynbargoed Close Treharris CF46 6AA Merthyr Tydfil Mid Glam | British | 14506510001 | ||||||
JONES, Graham William John | Segretario | 14 Whitehall Gardens Undy Magor NP6 3EW Newport Gwent | British | 44462340001 | ||||||
PEAGAM, Garry John | Segretario | The Four Winds 54 Middle Stoke Limpley Stoke BA2 7GG Bath | British | Group Finance Director | 64426280002 | |||||
PHILLIPS, Jackey | Segretario | Grenadier Road Exeter Business Park EX1 3QF Exeter Connaught House Devon | British | 104367080003 | ||||||
PIKE, David Kenneth | Segretario | Willow House 100 Sandford View TQ12 2TH Newton Abbot Devon | British | Finance Director | 99914770001 | |||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BROOK, Richard William | Amministratore | Stonebrook 7a Foxholes Crescent Calverley LS28 5NT Leeds Yorkshire | British | Divisional Manager | 42200750001 | |||||
CARLISLE, Ian | Amministratore | Caerphilly Business Park CF83 3GG Caerphilly Santia House Mid Glamorgan Wales | England | British | Chief Executive | 146715900001 | ||||
CAVANAGH, Julia | Amministratore | Grenadier Road Exeter Business Park EX1 3QF Exeter Connaught House United Kingdom | United Kingdom | British | - | 140133020001 | ||||
DARBY SHIRE, Ian | Amministratore | High Barn BD23 3PU Flasby North Yorkshire | British | Managing Director | 101620840001 | |||||
DAVIES, Mark Dingad | Amministratore | Cold Ash Farm Long Lane RG18 9LT Newbury Berkshire | England | British | Director | 203044250004 | ||||
FALLOW, John Ronald Thomlinson | Amministratore | Oakridge Chiltern Hill SL9 9TY Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | Regional Service Director | 45848980001 | ||||
GREGORY, Alan James | Amministratore | Edenhurst Cottage 3 Sheep Hill Lane New Longton PR4 4ZN Preston Lancashire | British | Manager | 45849250001 | |||||
HILL, Stephen Ronald | Amministratore | Oakfield House Stoke Hill EX4 9JN Exeter Devon | United Kingdom | British | Finance Director | 115233060001 | ||||
HURST, Paul Stuart | Amministratore | 68 Abbot Meadow Penwortham PR1 9JX Preston Lancashire | England | British | Finance Director | 22359600001 | ||||
JAMES, Royston | Amministratore | St Jude Glynbargoed Close Treharris CF46 6AA Merthyr Tydfil Mid Glam | British | Service Officer | 14506510001 | |||||
MCCLUNE, Neil Kenneth | Amministratore | 7 Old Fox Close CR3 5QU Caterham Surrey | British | Service Technician | 49736330001 | |||||
MILTON, Anthony William | Amministratore | 65 Wannock Lane Lower Willingdon BN20 9SE Eastbourne East Sussex | British | Gas Service Manager | 45849130001 | |||||
ORD, John Raymond | Amministratore | 17 Langham Place Highwoods CO4 9GB Colchester Essex | United Kingdom | British | General Manager | 101450630001 | ||||
PIKE, David Kenneth | Amministratore | Willow House 100 Sandford View TQ12 2TH Newton Abbot Devon | England | British | Finance Director | 99914770001 | ||||
PROWSE, John | Amministratore | 317 Ongar Road CM15 9HP Brentwood Essex | England | British | Director | 96786510001 | ||||
SIMMONDS, Michael Kenneth | Amministratore | 36 Byron Road CR2 8DY Selsdon Surrey | British | Technician | 72441900001 | |||||
TINCKNELL, Mark William | Amministratore | Hayne Barton Tipton St. John EX10 0AL Sidmouth Devon | England | British | Director | 4088810003 | ||||
WELLS, David Francis | Amministratore | Caerphilly Business Park CF83 3GG Caerphilly Santia House Mid Glamorgan Wales | United Kingdom | British | Accountant | 104366980002 | ||||
WOODLEY, Eustace Vernon | Amministratore | 155 Highfield Road Idle BD10 8QN Bradford | British | Industrial Service Engineer | 45849310002 |
CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Mortgage of shares | Creato il 06 ago 2009 Consegnato il 25 ago 2009 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All the shares and interest in the shares including all related rights see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security agreement | Creato il 06 ago 2009 Consegnato il 25 ago 2009 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security agreement | Creato il 10 lug 2009 Consegnato il 23 lug 2009 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage of shares | Creato il 10 lug 2009 Consegnato il 23 lug 2009 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any note hedging party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first equitable mortgage all the shares owned by the chargor or held by any nominee on its behalf in the share capital of each mortgaged company, including any dividend. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A security agreement | Creato il 17 ago 2007 Consegnato il 31 ago 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A mortgage of shares agreement | Creato il 17 ago 2007 Consegnato il 31 ago 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All the shares owned by it (including all related rights). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 13 dic 2006 Consegnato il 16 dic 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 17 mag 2004 Consegnato il 20 mag 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 21 ago 2002 Consegnato il 24 ago 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 20 mar 1997 Consegnato il 22 mar 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 28 mag 1996 Consegnato il 31 mag 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £750,000 together with all other monies due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
CONNAUGHT COMPLIANCE GAS SERVICES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione coatta |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0