NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED

NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03102566
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED?

    • Edizione di giornali (58130) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Loudwater Mill
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Buckinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NEWSQUEST (LANCASHIRE) LIMITED03 apr 199603 apr 1996
    RRN (LANCASHIRE) LIMITED09 nov 199509 nov 1995
    TAUPAQ LIMITED15 set 199515 set 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al25 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 12 set 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 25 dic 2016

    26 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 07 dic 2016

    • Capitale: GBP 10,000,301
    3 pagineSH01

    Bilancio redatto al 27 dic 2015

    29 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Anthony Hunter il 26 nov 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 28 dic 2014

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 set 2015

    Stato del capitale al 15 set 2015

    • Capitale: GBP 302
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Henry Kennedy Faure Walker il 13 gen 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Simon Alton Westrop il 13 gen 2015

    1 pagineCH03

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Neil Edward Carpenter il 13 gen 2015

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Anthony Hunter il 13 gen 2015

    2 pagineCH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS

    1 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da 58 Church Street Weybridge Surrey KT13 8DP a Loudwater Mill Station Road High Wycombe Buckinghamshire HP10 9TY in data 11 dic 2014

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Paul Davidson come amministratore in data 11 nov 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 ott 2014

    Stato del capitale al 01 ott 2014

    • Capitale: GBP 302
    SH01

    Bilancio redatto al 29 dic 2013

    19 pagineAA

    Nomina di Henry Kennedy Faure Walker come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 15 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 ott 2013

    Stato del capitale al 01 ott 2013

    • Capitale: GBP 302
    SH01

    Bilancio redatto al 30 dic 2012

    20 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CARPENTER, Neil Edward
    Quadrant House
    The Quadrant
    SM2 5AS Sutton
    9th And 10th Floors
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Quadrant House
    The Quadrant
    SM2 5AS Sutton
    9th And 10th Floors
    Surrey
    United Kingdom
    British90209080001
    WESTROP, Simon Alton
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British109662340001
    FAURE WALKER, Henry Kennedy
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director187012370001
    HUNTER, Paul Anthony
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Road
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandEnglishFinancial Director69320190004
    GLASS, Josephine Mary
    Cairn Cottage Woodham Park Way
    Woodham
    KT15 3SD Addlestone
    Surrey
    Segretario
    Cairn Cottage Woodham Park Way
    Woodham
    KT15 3SD Addlestone
    Surrey
    British44504060001
    HUNTER, Paul Anthony
    15 Downs Way
    KT18 5LU Epsom
    Surrey
    Segretario
    15 Downs Way
    KT18 5LU Epsom
    Surrey
    British69320190002
    JOSEPH, Anne Janette
    68 Hillway
    N6 6DP London
    Segretario
    68 Hillway
    N6 6DP London
    BritishLegal Dir60285460001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AIKEN, Iain William
    Pendle View, Primrose Hill
    BB2 7EQ Mellor
    Lancashire
    Amministratore
    Pendle View, Primrose Hill
    BB2 7EQ Mellor
    Lancashire
    BritishNewspaper Publisher83849650001
    ARMOUR, Mark Henry
    48 Bellamy Street
    SW12 8BU London
    Amministratore
    48 Bellamy Street
    SW12 8BU London
    BritishDirector58001830001
    BROWN, James Thomson
    Eyhurst Hall 8 Manor House
    Eyhurst Park Outwood Lane
    KT20 6JP Kingswood
    Surrey
    Amministratore
    Eyhurst Hall 8 Manor House
    Eyhurst Park Outwood Lane
    KT20 6JP Kingswood
    Surrey
    BritishNewspaper Chief Executive4154210013
    CHRISTIE, David Gordon
    53 The Mount
    Fetcham
    KT22 9EG Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    53 The Mount
    Fetcham
    KT22 9EG Leatherhead
    Surrey
    BritishCompany Director75461250001
    DAVIDSON, Paul
    Church Street
    KT13 8DP Weybridge
    58
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Church Street
    KT13 8DP Weybridge
    58
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishNewspaper Publisher46356560004
    GRAY, Robert Fullarton
    2 Trawlboat Cottage
    Blackpool Road Ansdell
    FY8 4AH Lytham St Annes
    Lancashire
    Amministratore
    2 Trawlboat Cottage
    Blackpool Road Ansdell
    FY8 4AH Lytham St Annes
    Lancashire
    BritishNewspaper Editor58776560001
    JOSEPH, Anne Janette
    68 Hillway
    N6 6DP London
    Amministratore
    68 Hillway
    N6 6DP London
    EnglandBritishLegal Dir60285460001
    MELLON, John Benedict
    Westward House
    7 Hayes Lane
    CR8 5LE Kenley
    Surrey
    Amministratore
    Westward House
    7 Hayes Lane
    CR8 5LE Kenley
    Surrey
    BritishCompany Director35523050001
    PFEIL, John Christopher
    148 High Street
    ME19 6NE West Malling
    Kent
    Amministratore
    148 High Street
    ME19 6NE West Malling
    Kent
    EnglandBritishFinance Director93412530001
    RADBURN, Philip Arthur
    Pyebirch Manor
    Eccleshall
    ST21 6JG Stafford
    Staffordshire
    Amministratore
    Pyebirch Manor
    Eccleshall
    ST21 6JG Stafford
    Staffordshire
    United KingdomBritishNewspaper Publisher46357310001
    RADCLIFFE, Willoughby Mark St John
    14 The Orchard
    Bedford Park
    W4 1JX London
    Amministratore
    14 The Orchard
    Bedford Park
    W4 1JX London
    EnglandBritishDir Corporate Services32447610001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Newsquest Media Group Limited
    Station Road
    Loudwater
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    England
    08 apr 2016
    Station Road
    Loudwater
    HP10 9TY High Wycombe
    Loudwater Mill
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneRegister Of Companies England & Wales
    Numero di registrazione01676637
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture
    Creato il 05 dic 1996
    Consegnato il 17 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations whatsoever of each obligor (as defined) to the chargee and the lenders (as defined) or any of them under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisseas Agent and Trustee for Itself and the Lenders
    Transazioni
    • 17 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 04 gen 1996
    Consegnato il 19 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the chargees under the terms of each or any of the finance documents in each case together with all costs charges and expenses incurred by any lender in connection with it's rights under the finance documents or any other documents securing such liabilities
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse(The "Security Agent") as Agent and Trustee Foritself and Each of the Lenders or Any of Them (as Defined)
    Transazioni
    • 19 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 dic 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0