NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED
Panoramica
Nome della società | NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03102566 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED?
- Edizione di giornali (58130) / Informazione e comunicazione
Dove si trova NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Loudwater Mill Station Road HP10 9TY High Wycombe Buckinghamshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
NEWSQUEST (LANCASHIRE) LIMITED | 03 apr 1996 | 03 apr 1996 |
RRN (LANCASHIRE) LIMITED | 09 nov 1995 | 09 nov 1995 |
TAUPAQ LIMITED | 15 set 1995 | 15 set 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 25 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 set 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 25 dic 2016 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 07 dic 2016
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 27 dic 2015 | 29 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Anthony Hunter il 26 nov 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 28 dic 2014 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Henry Kennedy Faure Walker il 13 gen 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Simon Alton Westrop il 13 gen 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Neil Edward Carpenter il 13 gen 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Anthony Hunter il 13 gen 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 9Th and 10Th Floors Quadrant House Sutton Surrey SM2 5AS | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 58 Church Street Weybridge Surrey KT13 8DP a Loudwater Mill Station Road High Wycombe Buckinghamshire HP10 9TY in data 11 dic 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Davidson come amministratore in data 11 nov 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 set 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 29 dic 2013 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Henry Kennedy Faure Walker come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 set 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 30 dic 2012 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARPENTER, Neil Edward | Segretario | Quadrant House The Quadrant SM2 5AS Sutton 9th And 10th Floors Surrey United Kingdom | British | 90209080001 | ||||||
WESTROP, Simon Alton | Segretario | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | British | 109662340001 | ||||||
FAURE WALKER, Henry Kennedy | Amministratore | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Company Director | 187012370001 | ||||
HUNTER, Paul Anthony | Amministratore | Station Road HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill Buckinghamshire United Kingdom | England | English | Financial Director | 69320190004 | ||||
GLASS, Josephine Mary | Segretario | Cairn Cottage Woodham Park Way Woodham KT15 3SD Addlestone Surrey | British | 44504060001 | ||||||
HUNTER, Paul Anthony | Segretario | 15 Downs Way KT18 5LU Epsom Surrey | British | 69320190002 | ||||||
JOSEPH, Anne Janette | Segretario | 68 Hillway N6 6DP London | British | Legal Dir | 60285460001 | |||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
AIKEN, Iain William | Amministratore | Pendle View, Primrose Hill BB2 7EQ Mellor Lancashire | British | Newspaper Publisher | 83849650001 | |||||
ARMOUR, Mark Henry | Amministratore | 48 Bellamy Street SW12 8BU London | British | Director | 58001830001 | |||||
BROWN, James Thomson | Amministratore | Eyhurst Hall 8 Manor House Eyhurst Park Outwood Lane KT20 6JP Kingswood Surrey | British | Newspaper Chief Executive | 4154210013 | |||||
CHRISTIE, David Gordon | Amministratore | 53 The Mount Fetcham KT22 9EG Leatherhead Surrey | British | Company Director | 75461250001 | |||||
DAVIDSON, Paul | Amministratore | Church Street KT13 8DP Weybridge 58 Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Newspaper Publisher | 46356560004 | ||||
GRAY, Robert Fullarton | Amministratore | 2 Trawlboat Cottage Blackpool Road Ansdell FY8 4AH Lytham St Annes Lancashire | British | Newspaper Editor | 58776560001 | |||||
JOSEPH, Anne Janette | Amministratore | 68 Hillway N6 6DP London | England | British | Legal Dir | 60285460001 | ||||
MELLON, John Benedict | Amministratore | Westward House 7 Hayes Lane CR8 5LE Kenley Surrey | British | Company Director | 35523050001 | |||||
PFEIL, John Christopher | Amministratore | 148 High Street ME19 6NE West Malling Kent | England | British | Finance Director | 93412530001 | ||||
RADBURN, Philip Arthur | Amministratore | Pyebirch Manor Eccleshall ST21 6JG Stafford Staffordshire | United Kingdom | British | Newspaper Publisher | 46357310001 | ||||
RADCLIFFE, Willoughby Mark St John | Amministratore | 14 The Orchard Bedford Park W4 1JX London | England | British | Dir Corporate Services | 32447610001 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Newsquest Media Group Limited | 08 apr 2016 | Station Road Loudwater HP10 9TY High Wycombe Loudwater Mill England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
NEWSQUEST (NORTH WEST)LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Creato il 05 dic 1996 Consegnato il 17 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations whatsoever of each obligor (as defined) to the chargee and the lenders (as defined) or any of them under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee and debenture | Creato il 04 gen 1996 Consegnato il 19 gen 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the chargees under the terms of each or any of the finance documents in each case together with all costs charges and expenses incurred by any lender in connection with it's rights under the finance documents or any other documents securing such liabilities | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0