BORDEN CHEMICAL UK LIMITED

BORDEN CHEMICAL UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBORDEN CHEMICAL UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03104655
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BORDEN CHEMICAL UK LIMITED?

    • fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a. (20590) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova BORDEN CHEMICAL UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Frp Advisory Trading Limited 2nd Floor
    170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BORDEN CHEMICAL UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INHOCO 436 LIMITED21 set 199521 set 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di BORDEN CHEMICAL UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per BORDEN CHEMICAL UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 set 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Momentive Specialty Chemicals Uk Ltd Sully Moors Road Penarth South Glamorgan CF64 5YU a Frp Advisory Trading Limited 2nd Floor 170 Edmund Street Birmingham B3 2HB in data 08 apr 2020

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 17 mar 2020

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    10 pagineLIQ01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    19 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 set 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 031046550010 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 031046550011 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 set 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    19 pagineAA

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 14 nov 2017

    • Capitale: GBP 750,000
    3 pagineSH01

    Nomina di Jean-Paul Aucoin come amministratore in data 01 nov 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di George Christopher Mackenzie Gallacher come amministratore in data 01 nov 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    19 pagineAA

    Nomina di Jaap Schilder come segretario in data 14 dic 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Richard Oliver Healey come segretario in data 07 ott 2016

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 set 2016 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    9 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Approval of accounts 01/04/2016
    RES13

    Chi sono gli amministratori di BORDEN CHEMICAL UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SCHILDER, Jaap
    3195 Nd Pernis
    Rotterdam
    Seattleweg 17
    Netherlands
    Segretario
    3195 Nd Pernis
    Rotterdam
    Seattleweg 17
    Netherlands
    220578750001
    AUCOIN, Jean-Paul
    East Broad Street
    Columbus
    180
    Ohio 43215
    United States
    Amministratore
    East Broad Street
    Columbus
    180
    Ohio 43215
    United States
    United StatesCanadian239792590001
    MERTENS, Arnoldus Wilhelmus Maria
    Building 4, 3195 Nd Pernis
    Rotterdam
    'Port Park' Seattleweg 17
    Netherlands
    Amministratore
    Building 4, 3195 Nd Pernis
    Rotterdam
    'Port Park' Seattleweg 17
    Netherlands
    NetherlandsDutch171400070001
    DAVIES, Leighton Wynne
    64 Cornerswell Road
    CF64 2WA Penarth
    Vale Of Glamorgan
    Segretario
    64 Cornerswell Road
    CF64 2WA Penarth
    Vale Of Glamorgan
    British94154900001
    FRAZIER, Peter Stokes
    57 Andes Close
    SO14 3HS Southampton
    Segretario
    57 Andes Close
    SO14 3HS Southampton
    American49919650001
    GREEN, Anthony
    29 Kenson Gardens
    Sholing
    SO19 8RE Southampton
    Hampshire
    Segretario
    29 Kenson Gardens
    Sholing
    SO19 8RE Southampton
    Hampshire
    British803990001
    HEALEY, Richard Oliver
    8 Clos Y Mynydd
    Morganstown
    CF15 8FH Cardiff
    Segretario
    8 Clos Y Mynydd
    Morganstown
    CF15 8FH Cardiff
    British91123950004
    JONES, Benjamin Harrison
    5 Riverview Road
    W4 3QH Chiswick
    London
    Segretario
    5 Riverview Road
    W4 3QH Chiswick
    London
    British American78219060001
    A B & C SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006570001
    BEVILAQUA, Joseph Patrick
    3895 Fairlington Drive
    Columbus
    43220
    Ohio
    Amministratore
    3895 Fairlington Drive
    Columbus
    43220
    Ohio
    UsaUnited States84251820001
    BOKMANS, Cornelis Adrianus
    Windrush Barn
    Police Row, Therfield
    SG8 9QE Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    Windrush Barn
    Police Row, Therfield
    SG8 9QE Royston
    Hertfordshire
    Dutch65565210001
    FRAZIER, Peter Stokes
    2 Wentworth Grange
    SO22 4HZ Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    2 Wentworth Grange
    SO22 4HZ Winchester
    Hampshire
    American49919650002
    GALLACHER, George Christopher Mackenzie
    14 Bellister Park
    SR8 1PH Peterlee
    County Durham
    Amministratore
    14 Bellister Park
    SR8 1PH Peterlee
    County Durham
    United KingdomBritish70971860001
    HARTLAND, Peter John
    8 Ty Westonia
    Chandler's Quay
    CF64 1SL Penarth
    South Glamorgan
    Amministratore
    8 Ty Westonia
    Chandler's Quay
    CF64 1SL Penarth
    South Glamorgan
    British76931030002
    JONES, Benjamin Harrison
    5 Riverview Road
    W4 3QH Chiswick
    London
    Amministratore
    5 Riverview Road
    W4 3QH Chiswick
    London
    British American78219060001
    LANGSTON, James
    Jakarama
    Raridge Lane
    SO32 1DX Bishops Waltham
    Hampshire
    Amministratore
    Jakarama
    Raridge Lane
    SO32 1DX Bishops Waltham
    Hampshire
    EnglandBritish94593180001
    MONTE, Ricardo Marcelo
    Juan Cruz Varela 737
    Acassuso
    Buenos Aires
    1640
    Argentina
    Amministratore
    Juan Cruz Varela 737
    Acassuso
    Buenos Aires
    1640
    Argentina
    Agrentinian47099280002
    SAGGESE, Joseph Michael
    172 Castle Ridge Road
    Manhasset
    New York Ny11030
    Usa
    Amministratore
    172 Castle Ridge Road
    Manhasset
    New York Ny11030
    Usa
    Usa17838840001
    VOLKING, Robert Jan
    Oakley House
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    Amministratore
    Oakley House
    Sway Road
    SO42 7SG Brockenhurst
    Hampshire
    Dutch45659130001
    WHITNEY, Derek Martin
    Lakeside House
    Brighton Road, Sway
    SO41 6EB Lymington
    Hampshire
    Amministratore
    Lakeside House
    Brighton Road, Sway
    SO41 6EB Lymington
    Hampshire
    British68115770001
    YOUNG, Roger Neville
    Deane Cottage Dean
    Sparsholt
    SO21 2LP Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    Deane Cottage Dean
    Sparsholt
    SO21 2LP Winchester
    Hampshire
    British59587740002
    ZAPPALA, Timothy Joseph
    8 Preservation Way
    Westford
    Mass 01886
    Usa
    Amministratore
    8 Preservation Way
    Westford
    Mass 01886
    Usa
    American67618550001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore delegato nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Chi sono le persone con controllo significativo di BORDEN CHEMICAL UK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Apollo Global Management Llc
    Centerville Road
    Suite 400
    Wilmington
    2711
    United States
    06 apr 2016
    Centerville Road
    Suite 400
    Wilmington
    2711
    United States
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Company
    Paese di registrazioneUsa
    Autorità legaleNew York Stock Exchange Listed
    Luogo di registrazioneState Of Delaware - Division Of Corporations
    Numero di registrazione4382726
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Borden International Holdings Limited
    Sully Moors Road
    Sully
    CF64 5YU Penarth
    C/O Momentive Specialty Chemicals Uk Limited
    Wales
    06 apr 2016
    Sully Moors Road
    Sully
    CF64 5YU Penarth
    C/O Momentive Specialty Chemicals Uk Limited
    Wales
    No
    Forma giuridicaLimited Liability Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales Registry
    Numero di registrazione3745631
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    BORDEN CHEMICAL UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 28 set 2015
    Consegnato il 05 ott 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Jpmorgan Chase Bank, N.A.
    Transazioni
    • 05 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 lug 2015
    Consegnato il 12 ago 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Jpmorgan Chase Bank, N.A.
    Transazioni
    • 12 ago 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 06 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security deed
    Creato il 28 mar 2013
    Consegnato il 10 apr 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any foreign subsidiary loan party to any receiver or any delegate of a receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge the inventory, accounts, collection accounts, licences, other documents see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jpmorgan Chase Bank, N.A. (The "Collateral Agent")
    Transazioni
    • 10 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 mag 2005
    Consegnato il 13 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H hollins vale works croft lane bury t/no GM206532, l/h hollins vale works croft lane t/no GM1717 and GM357591,f/h northwest industrial estate peterlee co durham t/no DU187150. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jp Morgan Chase Bank N.A.
    Transazioni
    • 13 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Intellectual property security agreement
    Creato il 31 mag 2005
    Consegnato il 13 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the chargor's entire right,title and interest now owned or existing and hereafter acquired or arising in the intellectual property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P.Morgan Europe Limited
    Transazioni
    • 13 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 31 mag 2005
    Consegnato il 07 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property k/a land to the north of davy drive peterlee t/no DU187150 any buildings, fixtures, fittings, fixed plant or machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jpmorgan Chase Bank, N.a,
    Transazioni
    • 07 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 31 mag 2005
    Consegnato il 07 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property k/a hollins vale works, croft lane, bury, greater manchester t/no GM206532, GM375911, GM1717 any buildings, fixtures, fittings, fixed plant or machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jpmorgan Chase Bank, N.a,
    Transazioni
    • 07 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    An amended and restated loan and security agreement
    Creato il 12 ago 2004
    Consegnato il 23 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the U.K. borrowers and canadian borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in all of the following property and interests in property: (I) accounts (ii) certificated securities (iii) chattel paper (iv) computer hardware and software (v) contract rights (vi) deposit accounts. For further details of charges please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fleet National Bank, London Branch as UK Collateral Agent for the U.K. Secured Parties Andfleet Capital Global Finance Inc. as Canadian Collateral Agent for the Canadian Secured Parties
    Transazioni
    • 23 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Trademark security agreement
    Creato il 12 ago 2004
    Consegnato il 23 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the U.K. borrowers and canadian borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in (I) all trademarks and trademark licenses (ii) all reissues continuations or extensions (iii) all goodwill (iv) all products and proceeds of the foregoing. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fleet National Bank, London Branch as UK Collateral Agent for the U.K. Secured Parties Andfleet Capital Global Finance Inc. as Canadian Collateral Agent for the Canadian Secured Parties
    Transazioni
    • 23 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Patent security agreement
    Creato il 12 ago 2004
    Consegnato il 23 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the U.K. borrowers and canadian borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in to and under (I) all patents and patents licenses (ii) all reissues continuations or extensions (iii) all products and proceeds of the foregoing. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fleet National Bank, London Branch as UK Collateral Agent for the U.K. Secured Parties Andfleet Capital Global Finance Inc. as Canadian Collateral Agent for the Canadian Secured Parties
    Transazioni
    • 23 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 23 set 2002
    Consegnato il 03 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the agent on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fleet National Bank (The Security Agent)
    Transazioni
    • 03 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BORDEN CHEMICAL UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    17 mar 2020Inizio della liquidazione
    13 feb 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Anthony Steven Barrell
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Praticante
    2nd Floor 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Gerald Clifford Smith
    2nd Floor, 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham
    Praticante
    2nd Floor, 170 Edmund Street
    B3 2HB Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0