BORDEN CHEMICAL UK LIMITED
Panoramica
| Nome della società | BORDEN CHEMICAL UK LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03104655 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BORDEN CHEMICAL UK LIMITED?
- fabbricazione di altri prodotti chimici n.c.a. (20590) / Industrie manifatturiere
Dove si trova BORDEN CHEMICAL UK LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Frp Advisory Trading Limited 2nd Floor 170 Edmund Street B3 2HB Birmingham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BORDEN CHEMICAL UK LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| INHOCO 436 LIMITED | 21 set 1995 | 21 set 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BORDEN CHEMICAL UK LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per BORDEN CHEMICAL UK LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 11 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 set 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Momentive Specialty Chemicals Uk Ltd Sully Moors Road Penarth South Glamorgan CF64 5YU a Frp Advisory Trading Limited 2nd Floor 170 Edmund Street Birmingham B3 2HB in data 08 apr 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 10 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 031046550010 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 031046550011 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 9 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 set 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 14 nov 2017
| 3 pagine | SH01 | ||||||||||
Nomina di Jean-Paul Aucoin come amministratore in data 01 nov 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di George Christopher Mackenzie Gallacher come amministratore in data 01 nov 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Jaap Schilder come segretario in data 14 dic 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Oliver Healey come segretario in data 07 ott 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 27 set 2016 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 21 set 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di BORDEN CHEMICAL UK LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHILDER, Jaap | Segretario | 3195 Nd Pernis Rotterdam Seattleweg 17 Netherlands | 220578750001 | |||||||
| AUCOIN, Jean-Paul | Amministratore | East Broad Street Columbus 180 Ohio 43215 United States | United States | Canadian | 239792590001 | |||||
| MERTENS, Arnoldus Wilhelmus Maria | Amministratore | Building 4, 3195 Nd Pernis Rotterdam 'Port Park' Seattleweg 17 Netherlands | Netherlands | Dutch | 171400070001 | |||||
| DAVIES, Leighton Wynne | Segretario | 64 Cornerswell Road CF64 2WA Penarth Vale Of Glamorgan | British | 94154900001 | ||||||
| FRAZIER, Peter Stokes | Segretario | 57 Andes Close SO14 3HS Southampton | American | 49919650001 | ||||||
| GREEN, Anthony | Segretario | 29 Kenson Gardens Sholing SO19 8RE Southampton Hampshire | British | 803990001 | ||||||
| HEALEY, Richard Oliver | Segretario | 8 Clos Y Mynydd Morganstown CF15 8FH Cardiff | British | 91123950004 | ||||||
| JONES, Benjamin Harrison | Segretario | 5 Riverview Road W4 3QH Chiswick London | British American | 78219060001 | ||||||
| A B & C SECRETARIAL LIMITED | Segretario nominato | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006570001 | |||||||
| BEVILAQUA, Joseph Patrick | Amministratore | 3895 Fairlington Drive Columbus 43220 Ohio | Usa | United States | 84251820001 | |||||
| BOKMANS, Cornelis Adrianus | Amministratore | Windrush Barn Police Row, Therfield SG8 9QE Royston Hertfordshire | Dutch | 65565210001 | ||||||
| FRAZIER, Peter Stokes | Amministratore | 2 Wentworth Grange SO22 4HZ Winchester Hampshire | American | 49919650002 | ||||||
| GALLACHER, George Christopher Mackenzie | Amministratore | 14 Bellister Park SR8 1PH Peterlee County Durham | United Kingdom | British | 70971860001 | |||||
| HARTLAND, Peter John | Amministratore | 8 Ty Westonia Chandler's Quay CF64 1SL Penarth South Glamorgan | British | 76931030002 | ||||||
| JONES, Benjamin Harrison | Amministratore | 5 Riverview Road W4 3QH Chiswick London | British American | 78219060001 | ||||||
| LANGSTON, James | Amministratore | Jakarama Raridge Lane SO32 1DX Bishops Waltham Hampshire | England | British | 94593180001 | |||||
| MONTE, Ricardo Marcelo | Amministratore | Juan Cruz Varela 737 Acassuso Buenos Aires 1640 Argentina | Agrentinian | 47099280002 | ||||||
| SAGGESE, Joseph Michael | Amministratore | 172 Castle Ridge Road Manhasset New York Ny11030 Usa | Usa | 17838840001 | ||||||
| VOLKING, Robert Jan | Amministratore | Oakley House Sway Road SO42 7SG Brockenhurst Hampshire | Dutch | 45659130001 | ||||||
| WHITNEY, Derek Martin | Amministratore | Lakeside House Brighton Road, Sway SO41 6EB Lymington Hampshire | British | 68115770001 | ||||||
| YOUNG, Roger Neville | Amministratore | Deane Cottage Dean Sparsholt SO21 2LP Winchester Hampshire | British | 59587740002 | ||||||
| ZAPPALA, Timothy Joseph | Amministratore | 8 Preservation Way Westford Mass 01886 Usa | American | 67618550001 | ||||||
| INHOCO FORMATIONS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006560001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BORDEN CHEMICAL UK LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Global Management Llc | 06 apr 2016 | Centerville Road Suite 400 Wilmington 2711 United States | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Borden International Holdings Limited | 06 apr 2016 | Sully Moors Road Sully CF64 5YU Penarth C/O Momentive Specialty Chemicals Uk Limited Wales | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
BORDEN CHEMICAL UK LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 28 set 2015 Consegnato il 05 ott 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 27 lug 2015 Consegnato il 12 ago 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security deed | Creato il 28 mar 2013 Consegnato il 10 apr 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any foreign subsidiary loan party to any receiver or any delegate of a receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge the inventory, accounts, collection accounts, licences, other documents see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 31 mag 2005 Consegnato il 13 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H hollins vale works croft lane bury t/no GM206532, l/h hollins vale works croft lane t/no GM1717 and GM357591,f/h northwest industrial estate peterlee co durham t/no DU187150. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Intellectual property security agreement | Creato il 31 mag 2005 Consegnato il 13 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargor to the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All of the chargor's entire right,title and interest now owned or existing and hereafter acquired or arising in the intellectual property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 31 mag 2005 Consegnato il 07 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The property k/a land to the north of davy drive peterlee t/no DU187150 any buildings, fixtures, fittings, fixed plant or machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 31 mag 2005 Consegnato il 07 giu 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The property k/a hollins vale works, croft lane, bury, greater manchester t/no GM206532, GM375911, GM1717 any buildings, fixtures, fittings, fixed plant or machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| An amended and restated loan and security agreement | Creato il 12 ago 2004 Consegnato il 23 ago 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the U.K. borrowers and canadian borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right title and interest in all of the following property and interests in property: (I) accounts (ii) certificated securities (iii) chattel paper (iv) computer hardware and software (v) contract rights (vi) deposit accounts. For further details of charges please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Trademark security agreement | Creato il 12 ago 2004 Consegnato il 23 ago 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the U.K. borrowers and canadian borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right title and interest in (I) all trademarks and trademark licenses (ii) all reissues continuations or extensions (iii) all goodwill (iv) all products and proceeds of the foregoing. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Patent security agreement | Creato il 12 ago 2004 Consegnato il 23 ago 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the U.K. borrowers and canadian borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right title and interest in to and under (I) all patents and patents licenses (ii) all reissues continuations or extensions (iii) all products and proceeds of the foregoing. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee & debenture | Creato il 23 set 2002 Consegnato il 03 ott 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the agent on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
BORDEN CHEMICAL UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0