SUPERIOR PRODUCE LIMITED

SUPERIOR PRODUCE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSUPERIOR PRODUCE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03107069
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SUPERIOR PRODUCE LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova SUPERIOR PRODUCE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SUPERIOR PRODUCE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GROWERS CHOICE LIMITED05 dic 199505 dic 1995
    GREENSENSE LIMITED27 set 199527 set 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di SUPERIOR PRODUCE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 mar 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SUPERIOR PRODUCE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SUPERIOR PRODUCE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 mar 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 set 2014

    Stato del capitale al 01 set 2014

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    11 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2013 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 set 2013

    Stato del capitale al 10 set 2013

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Food Partners House Poyle Road Colnbrook Slough SL3 0QX England* in data 10 set 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 mar 2013

    5 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Varie

    Section 519
    2 pagineMISC

    Cessazione della carica di Christopher Thomas come amministratore

    2 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2012 al 31 mar 2013

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Steve Wood come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Gavin Cox il 01 nov 2011

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Steve Wood il 01 nov 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Gavin Cox il 01 nov 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Thomas il 01 nov 2011

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Food Partners House Poyle Road Colnbrook, Slough England SL3 0EN England* in data 13 nov 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 01 ott 2011

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Ritiro della richiesta di cancellazione della società

    2 pagineDS02

    Chi sono gli amministratori di SUPERIOR PRODUCE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COX, Gavin
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Segretario
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    165756720001
    COX, Gavin Eliot
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    Amministratore
    The Square
    Southall Lane
    UB2 5NH Heathrow
    2
    England
    United KingdomBritish153840250001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    Segretario
    Tanners Drive
    MK14 5BN Blakelands
    28
    Milton Keynes
    British150501100001
    TAYLOR, Michael Dennis
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Segretario
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British18385410004
    VINCENT, Guy Wyndham
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    Segretario
    50 Broadway
    SW1H 0BL London
    British70893430002
    MACLAY MURRAY & SPENS LLP
    One London Wall
    EC2Y 5AB London
    Segretario
    One London Wall
    EC2Y 5AB London
    116685100001
    SECRETAIRE LIMITED
    3rd Floor
    2 Luke Street
    EC2A 4NT London
    Segretario nominato
    3rd Floor
    2 Luke Street
    EC2A 4NT London
    900011490001
    BROWN, Kevin Thomas
    30 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    Amministratore delegato nominato
    30 Harts Grove
    IG8 0BN Woodford Green
    Essex
    EnglandBritish900008020001
    CHISAMBI, Rodgers Yalamila
    Flat 7
    30 Longridge Road
    SW5 9SJ Earls Court
    London
    Amministratore
    Flat 7
    30 Longridge Road
    SW5 9SJ Earls Court
    London
    Zambian77986900001
    FEE, Paul
    285 Yorktown Road
    College Town
    GU47 0QA Sandhurst
    Berkshire
    Amministratore
    285 Yorktown Road
    College Town
    GU47 0QA Sandhurst
    Berkshire
    British55281590001
    GUY, David Simon
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Amministratore
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    British119214340001
    HALL, Fraser Scott
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Amministratore
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    British4578740001
    HAZELDEAN, William James
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    Amministratore
    6a Balmoral Court
    Gleneagles Village
    PH3 1SH Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritish83660790002
    KINGSLEY BATES, Paul
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Amministratore
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    United KingdomBritish132962170001
    MCLELLAND, Stewart
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    36 East Craigs Rigg
    EH12 8JA Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish157009150001
    MELLORS, William Peter Stewart
    5 Limetree Court
    103 Straight Road
    SL4 2SS Old Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    5 Limetree Court
    103 Straight Road
    SL4 2SS Old Windsor
    Berkshire
    British107055640001
    MOMEN, Julian Akhtar Karim
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    Amministratore
    Tanners Drive
    Blakelands
    MK14 5BN Milton Keynes
    28
    United Kingdom
    EnglandBritish51784930002
    NELSON, Finlay Macarthur
    Stamford Road
    Barnack
    PE9 3HA Stamford
    Quarry House
    Lincolnshire
    Amministratore
    Stamford Road
    Barnack
    PE9 3HA Stamford
    Quarry House
    Lincolnshire
    EnglandBritish132363820001
    NUDDS, Anthony John
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    Amministratore
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    British62512350001
    NUDDS, Anthony John
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    Amministratore
    8 Tawny Close
    TW13 7LH Feltham
    Middlesex
    British62512350001
    POCOCK, Patrick William
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    Amministratore
    The Steadings
    Woodside Of Cloghill, Kingswells
    AB15 8SA Aberdeen
    British96978470001
    SINCLAIR, John Frederick
    16 Old Coastguard Road
    Sandbanks
    BH13 7RL Poole
    Dorset
    Amministratore
    16 Old Coastguard Road
    Sandbanks
    BH13 7RL Poole
    Dorset
    British46006710001
    SMITH, Andrew Macdonald
    Chimneys
    Westbury Road
    BR1 2QB Bromley
    Kent
    Amministratore
    Chimneys
    Westbury Road
    BR1 2QB Bromley
    Kent
    British74660050001
    TAYLOR, Agatha
    Woodstock Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Woodstock Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British58350880001
    TAYLOR, Michael Dennis
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Woodstock
    Dukes Ride
    SL9 7LD Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British18385410004
    THOMAS, Christopher
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Amministratore
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    EnglandBritish63844650001
    TRUELOVE, Amelia Anne
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    Amministratore
    Bentley Hall
    Fenny Bentley
    DE6 1LE Ashbourne
    Derbyshire
    British37845970003
    WEBB, Robert John
    5 Underwood Cottages
    The Coombe, Streatley
    RG8 9RA Reading
    Berkshire
    Amministratore
    5 Underwood Cottages
    The Coombe, Streatley
    RG8 9RA Reading
    Berkshire
    British65669490001
    WOOD, Steven John
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    Amministratore
    Poyle Road
    Colnbrook
    SL3 0QX Slough
    Food Partners House
    England
    United KingdomBritish232132390001
    WORT, Edward George
    28 Crown Meadow
    Colnbrook
    SL3 0LT Slough
    Berkshire
    Amministratore
    28 Crown Meadow
    Colnbrook
    SL3 0LT Slough
    Berkshire
    British77987180001

    SUPERIOR PRODUCE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 21 apr 2008
    Consegnato il 02 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Duke Street Capital General Partner Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 02 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture accession deed
    Creato il 16 feb 2007
    Consegnato il 05 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title and interest in and to the property assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Secured Parties)(the Security Agent)
    Transazioni
    • 05 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 08 gen 2004
    Consegnato il 10 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transazioni
    • 10 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 23 mar 1999
    Consegnato il 01 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 01 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 dic 1996
    Consegnato il 07 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H or l/h property k/a units 187-189 and 190-192A western international market heston l/b of hounslow & all buildings & structures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Superior Foods Limited
    Transazioni
    • 07 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 13 dic 1995
    Consegnato il 19 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0