SUPERIOR PRODUCE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SUPERIOR PRODUCE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03107069 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SUPERIOR PRODUCE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova SUPERIOR PRODUCE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 2 The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SUPERIOR PRODUCE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| GROWERS CHOICE LIMITED | 05 dic 1995 | 05 dic 1995 |
| GREENSENSE LIMITED | 27 set 1995 | 27 set 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SUPERIOR PRODUCE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 mar 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SUPERIOR PRODUCE LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per SUPERIOR PRODUCE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 mar 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 ago 2014 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 11 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 ago 2013 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Food Partners House Poyle Road Colnbrook Slough SL3 0QX England* in data 10 set 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 mar 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 2 pagine | AUD | ||||||||||
Varie Section 519 | 2 pagine | MISC | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Thomas come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2012 al 31 mar 2013 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steve Wood come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 ago 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Gavin Cox il 01 nov 2011 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Steve Wood il 01 nov 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Gavin Cox il 01 nov 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher Thomas il 01 nov 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Food Partners House Poyle Road Colnbrook, Slough England SL3 0EN England* in data 13 nov 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 01 ott 2011 | 6 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Ritiro della richiesta di cancellazione della società | 2 pagine | DS02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SUPERIOR PRODUCE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COX, Gavin | Segretario | The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow 2 England | 165756720001 | |||||||
| COX, Gavin Eliot | Amministratore | The Square Southall Lane UB2 5NH Heathrow 2 England | United Kingdom | British | 153840250001 | |||||
| MOMEN, Julian Akhtar Karim | Segretario | Tanners Drive MK14 5BN Blakelands 28 Milton Keynes | British | 150501100001 | ||||||
| TAYLOR, Michael Dennis | Segretario | Woodstock Dukes Ride SL9 7LD Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 18385410004 | ||||||
| VINCENT, Guy Wyndham | Segretario | 50 Broadway SW1H 0BL London | British | 70893430002 | ||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Segretario | One London Wall EC2Y 5AB London | 116685100001 | |||||||
| SECRETAIRE LIMITED | Segretario nominato | 3rd Floor 2 Luke Street EC2A 4NT London | 900011490001 | |||||||
| BROWN, Kevin Thomas | Amministratore delegato nominato | 30 Harts Grove IG8 0BN Woodford Green Essex | England | British | 900008020001 | |||||
| CHISAMBI, Rodgers Yalamila | Amministratore | Flat 7 30 Longridge Road SW5 9SJ Earls Court London | Zambian | 77986900001 | ||||||
| FEE, Paul | Amministratore | 285 Yorktown Road College Town GU47 0QA Sandhurst Berkshire | British | 55281590001 | ||||||
| GUY, David Simon | Amministratore | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 United Kingdom | British | 119214340001 | ||||||
| HALL, Fraser Scott | Amministratore | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 United Kingdom | British | 4578740001 | ||||||
| HAZELDEAN, William James | Amministratore | 6a Balmoral Court Gleneagles Village PH3 1SH Auchterarder Perthshire | Scotland | British | 83660790002 | |||||
| KINGSLEY BATES, Paul | Amministratore | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 United Kingdom | United Kingdom | British | 132962170001 | |||||
| MCLELLAND, Stewart | Amministratore | 36 East Craigs Rigg EH12 8JA Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 157009150001 | |||||
| MELLORS, William Peter Stewart | Amministratore | 5 Limetree Court 103 Straight Road SL4 2SS Old Windsor Berkshire | British | 107055640001 | ||||||
| MOMEN, Julian Akhtar Karim | Amministratore | Tanners Drive Blakelands MK14 5BN Milton Keynes 28 United Kingdom | England | British | 51784930002 | |||||
| NELSON, Finlay Macarthur | Amministratore | Stamford Road Barnack PE9 3HA Stamford Quarry House Lincolnshire | England | British | 132363820001 | |||||
| NUDDS, Anthony John | Amministratore | 8 Tawny Close TW13 7LH Feltham Middlesex | British | 62512350001 | ||||||
| NUDDS, Anthony John | Amministratore | 8 Tawny Close TW13 7LH Feltham Middlesex | British | 62512350001 | ||||||
| POCOCK, Patrick William | Amministratore | The Steadings Woodside Of Cloghill, Kingswells AB15 8SA Aberdeen | British | 96978470001 | ||||||
| SINCLAIR, John Frederick | Amministratore | 16 Old Coastguard Road Sandbanks BH13 7RL Poole Dorset | British | 46006710001 | ||||||
| SMITH, Andrew Macdonald | Amministratore | Chimneys Westbury Road BR1 2QB Bromley Kent | British | 74660050001 | ||||||
| TAYLOR, Agatha | Amministratore | Woodstock Dukes Ride SL9 7LD Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 58350880001 | ||||||
| TAYLOR, Michael Dennis | Amministratore | Woodstock Dukes Ride SL9 7LD Gerrards Cross Buckinghamshire | British | 18385410004 | ||||||
| THOMAS, Christopher | Amministratore | Poyle Road Colnbrook SL3 0QX Slough Food Partners House England | England | British | 63844650001 | |||||
| TRUELOVE, Amelia Anne | Amministratore | Bentley Hall Fenny Bentley DE6 1LE Ashbourne Derbyshire | British | 37845970003 | ||||||
| WEBB, Robert John | Amministratore | 5 Underwood Cottages The Coombe, Streatley RG8 9RA Reading Berkshire | British | 65669490001 | ||||||
| WOOD, Steven John | Amministratore | Poyle Road Colnbrook SL3 0QX Slough Food Partners House England | United Kingdom | British | 232132390001 | |||||
| WORT, Edward George | Amministratore | 28 Crown Meadow Colnbrook SL3 0LT Slough Berkshire | British | 77987180001 |
SUPERIOR PRODUCE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 21 apr 2008 Consegnato il 02 mag 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture accession deed | Creato il 16 feb 2007 Consegnato il 05 mar 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All its right title and interest in and to the property assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 08 gen 2004 Consegnato il 10 gen 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 23 mar 1999 Consegnato il 01 apr 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 03 dic 1996 Consegnato il 07 dic 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H or l/h property k/a units 187-189 and 190-192A western international market heston l/b of hounslow & all buildings & structures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating charge | Creato il 13 dic 1995 Consegnato il 19 dic 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0