SHL (UK) LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSHL (UK) LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03109066
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SHL (UK) LTD?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SHL (UK) LTD?

    Indirizzo della sede legale
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SHL (UK) LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SAVILLE & HOLDSWORTH (UK) LIMITED11 dic 199511 dic 1995
    STUDIOPRICE LIMITED02 ott 199502 ott 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di SHL (UK) LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per SHL (UK) LTD?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per SHL (UK) LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 mag 2014

    Stato del capitale al 01 mag 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di Catherine Phillips come amministratore in data 31 lug 2013

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Cessazione della carica di Catherine Phillips come segretario in data 31 lug 2013

    1 pagineTM02

    Nomina di David Edward Ryell come amministratore in data 31 lug 2013

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Emma Voirrey Lancaster come amministratore in data 27 nov 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Martin David Franks come amministratore in data 27 nov 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Catherine Phillips come segretario in data 01 giu 2012

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Suzanna Barrett come segretario in data 01 giu 2012

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Suzanna Barrett come amministratore in data 01 giu 2012

    1 pagineTM01

    Nomina di Catherine Phillips come amministratore in data 01 giu 2012

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Emma Voirrey Lancaster il 10 feb 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Suzanna Barrett il 10 feb 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    legacy

    7 pagineMG01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    15 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SHL (UK) LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FRANKS, Martin David
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Amministratore
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    EnglandBritish173954290001
    RYELL, David Edward
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Amministratore
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    EnglandBritish180882130001
    BARRETT, Suzanna
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Segretario
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    British106880710002
    BURNIP, Alexandra Elizabeth
    7 Oatlands Close
    KT13 9ED Weybridge
    Surrey
    Segretario
    7 Oatlands Close
    KT13 9ED Weybridge
    Surrey
    British12239690001
    CADMAN, John William
    42 Albert Road
    South Woodford
    E18 1LE London
    Segretario
    42 Albert Road
    South Woodford
    E18 1LE London
    British66894390001
    EVANS, Paul Anthony James
    24 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    Segretario
    24 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    British38068300001
    PHILLIPS, Catherine
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Segretario
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    170384570001
    PRICE, David Robert
    1 Titchfield Close
    RH15 0RX Burgess Hill
    West Sussex
    Segretario
    1 Titchfield Close
    RH15 0RX Burgess Hill
    West Sussex
    British76272880001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AUSTIN, Roger John
    57 Howards Wood Drive
    SL9 7HS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    57 Howards Wood Drive
    SL9 7HS Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British67674990001
    BARRETT, Suzanna
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Amministratore
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    EnglandBritish106880710002
    BURGE, Alan
    Home Farm Close
    BA14 6AH Steeple Ashton
    5
    Wiltshire
    Amministratore
    Home Farm Close
    BA14 6AH Steeple Ashton
    5
    Wiltshire
    United KingdomBritish197259620001
    BURNIP, Alexandra Elizabeth
    7 Oatlands Close
    KT13 9ED Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    7 Oatlands Close
    KT13 9ED Weybridge
    Surrey
    British12239690001
    CADMAN, John William
    42 Albert Road
    South Woodford
    E18 1LE London
    Amministratore
    42 Albert Road
    South Woodford
    E18 1LE London
    British66894390001
    CRAMP, Elisabeth Lyndsay
    4 Claremont End
    KT10 9LZ Esher
    Surrey
    Amministratore
    4 Claremont End
    KT10 9LZ Esher
    Surrey
    EnglandBritish97695420001
    GREGORY, Roger William
    26 Magnus Drive
    Hatch Warren
    RG22 4TX Basingstoke
    Hampshire
    Amministratore
    26 Magnus Drive
    Hatch Warren
    RG22 4TX Basingstoke
    Hampshire
    British59500110001
    HOLDSWORTH, Roger Francis
    Parc St Roman,
    7 Avenue Saint Roman
    FOREIGN Monaco
    98000
    Monaco
    Amministratore
    Parc St Roman,
    7 Avenue Saint Roman
    FOREIGN Monaco
    98000
    Monaco
    British112662000001
    HOWARD, Simon John
    107 Bridge House
    Saint George Wharf
    SW8 2LQ London
    Amministratore
    107 Bridge House
    Saint George Wharf
    SW8 2LQ London
    United KingdomBritish73313240006
    LANCASTER, Emma Voirrey
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Amministratore
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    United KingdomBritish79034410005
    MABEY, William
    Sunnyfields Meadowside
    Bookham
    KT23 3LF Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Sunnyfields Meadowside
    Bookham
    KT23 3LF Leatherhead
    Surrey
    British12239710001
    PHILLIPS, Catherine
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    Amministratore
    The Pavilion
    1 Atwell Place
    KT7 0NE Thames Ditton
    Surrey
    United KingdomBritish170338110001
    PRICE, David Robert
    1 Titchfield Close
    RH15 0RX Burgess Hill
    West Sussex
    Amministratore
    1 Titchfield Close
    RH15 0RX Burgess Hill
    West Sussex
    British76272880001
    SAVILLE, Peter Francis, Dr
    Wildacre
    21 Esher Park
    KT10 9NX Esher
    Surrey
    Amministratore
    Wildacre
    21 Esher Park
    KT10 9NX Esher
    Surrey
    British12239700001
    STEVENSON, Hazel Helena
    70 Seymour Avenue
    Ewell
    KT17 2RR Epsom
    Surrey
    Amministratore
    70 Seymour Avenue
    Ewell
    KT17 2RR Epsom
    Surrey
    United KingdomBritish51232470001
    VAN RAAY, Paul Bernard
    Velsgoed 24
    Prinsenbeek
    4841el
    Netherlands
    Amministratore
    Velsgoed 24
    Prinsenbeek
    4841el
    Netherlands
    Dutch90966240001
    VISSER, Gerbrand Joannes Antonius
    Watertuin 27
    3648GA De Ronde Venen
    Netherlands
    Amministratore
    Watertuin 27
    3648GA De Ronde Venen
    Netherlands
    Dutch51232680001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    SHL (UK) LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 10 gen 2011
    Consegnato il 15 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cit Capital Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 15 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    A share pledge agreement
    Creato il 27 mar 2009
    Consegnato il 06 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due of the obligors to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The pledgors have pledged the 12,434 shares no.1 To 12,434 shares inclusive held by shl people solutions group holdings limited and one share no.12,435 Held by the company in shl belgium sa and any other shares in shl belgium that they may subscribe to or acquire in the future see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cit Capital Finance (UK) Limited Acting for Itself and for the Account of the Secured Parties
    Transazioni
    • 06 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 27 mar 2009
    Consegnato il 06 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cit Capital Finance (UK) Limited as Trustee for Itself and the Other Persons (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 06 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 31 gen 2007
    Consegnato il 07 feb 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cit Capital Finance (UK) Limited in Its Capacity Trustee
    Transazioni
    • 07 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 19 ago 1997
    Consegnato il 08 set 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the debenture
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 set 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 gen 1997
    Consegnato il 22 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 22 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0