REBUS GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | REBUS GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03109650 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di REBUS GROUP LIMITED?
- Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova REBUS GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Corporation Service Company (Uk) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor E14 5HU London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di REBUS GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| RICHTRACK PUBLIC LIMITED COMPANY | 03 ott 1995 | 03 ott 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di REBUS GROUP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per REBUS GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
Notifica di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo | 2 pagine | PSC08 | ||||||||||
La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta | 1 pagine | DISS40 | ||||||||||
Cessazione di Stephen Allen Schwarzman come persona con controllo significativo il 06 lug 2021 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Stato del capitale al 07 mag 2021
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 58 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT1 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 apr 2021 al 31 dic 2020 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di Stephen Allen Schwarzman come persona con controllo significativo il 04 nov 2019 | 2 pagine | PSC01 | ||||||||||
Cessazione di Rebus Hr Holdings Limited come persona con controllo significativo il 04 nov 2019 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4NW a C/O Corporation Service Company (Uk) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor London E14 5HU in data 04 nov 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Phillip Monshaw come amministratore in data 21 ott 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Malcolm Robert Bennett come segretario in data 10 lug 2020 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steven James Chalker come amministratore in data 30 giu 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms Gillian Tiffney Gilliat Nolan come amministratore in data 30 giu 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE1 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di REBUS GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOLAN, Gillian Tiffney Gilliatt | Amministratore | 5 Churchill Place, 10th Floor E14 5HU London C/O Corporation Service Company (Uk) Limited United Kingdom | United Kingdom | British | 271694390001 | |||||
| BENNETT, Malcolm Robert | Segretario | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | 208002930001 | |||||||
| FARRIMOND, Nicholas Brian | Segretario | 51 The Avenue WD17 4NU Watford Hertfordshire | British | 75357260001 | ||||||
| LONEY, Nicholas John | Segretario | 31 Viewfield Road Southfields SW18 5JD London | British | 8511300001 | ||||||
| MEADES, Derek Leslie | Segretario | Alfriston House The Avenue SL5 7LY Ascot Berkshire | British | 8142960002 | ||||||
| NUNN, Carol Jayne | Segretario | Boundary Way HP2 7HU Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 101872040001 | ||||||
| RICHARDSON, John David | Segretario | High Street Burnham SL1 7JD Slough 27 Berks | British | 128558470001 | ||||||
| SCHENCK, Daniel William | Segretario | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | Usa | 181204960001 | ||||||
| SCORE, Timothy | Segretario | Chestnut Farmhouse Aylesbury Road HP27 0JT Monks Risborough Buckinghamshire | British | 103319060001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| AL-SALEH, Adel Bedry | Amministratore | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Marylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead 3rd Floor Hertfordshire United Kingdom | United States | American | 165900220001 | |||||
| BIDWELL, Hugh Charles Philip, Sir | Amministratore | The Parsonage Goodnestone CT3 1PJ Canterbury Kent | British | 58932210001 | ||||||
| BURTON, Michael John | Amministratore | 4a Langton Way SE3 7TL London | British | 63922600001 | ||||||
| CHALKER, Steven James | Amministratore | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 221085650001 | |||||
| COTTAM, Harold, Managing Director | Amministratore | Pentwyn Farm Dorstone HR3 6AD Hereford | United Kingdom | British | 32116700002 | |||||
| DENLEY, Gareth Phillip | Amministratore | 31 Ashley Road KT12 1JB Walton On Thames Surrey | British | 38711220001 | ||||||
| GREAVES, Andrew David | Amministratore | Wood End Cottage Wood Lane SL2 3YY Hedgerley Buckinghamshire | British | 50048250001 | ||||||
| HELLER, Robert Gordon Barry | Amministratore | 53 Fitzroy Park N6 6JA London | British | 2883040001 | ||||||
| HODGSON, David Charles | Amministratore | 755 Park Avenue New York 10021 Usa | American | 63989560001 | ||||||
| LAKING, David Albert | Amministratore | 33 Station Road Nassington PE8 6QB Peterborough Cambridgeshire | United Kingdom | British | 82424930001 | |||||
| LONEY, Nicholas John | Amministratore | 31 Viewfield Road Southfields SW18 5JD London | British | 8511300001 | ||||||
| MCKINLEY, Edward Joseph | Amministratore | The Priory 3a Seymour Walk SW10 9NF London | American | 38853950001 | ||||||
| MEADES, Derek Leslie | Amministratore | Alfriston House The Avenue SL5 7LY Ascot Berkshire | British | 8142960002 | ||||||
| MONSHAW, Andrew Phillip | Amministratore | Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Herts | United States | American | 239664830001 | |||||
| PRESLAND, Peter Eric | Amministratore | Rats Castle Castletons Oak Cranbrook Road TN27 8DY Biddenden Ashford Kent | England | British | 7649630002 | |||||
| ROSS, Stuart | Amministratore | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | England | British | 20168110001 | |||||
| SCORE, Timothy | Amministratore | Chestnut Farmhouse Aylesbury Road HP27 0JT Monks Risborough Buckinghamshire | British | 103319060001 | ||||||
| SEED, John Junior | Amministratore | Highfield House North Road BA2 6HW Bath Bath & North East Somerset | British | 8670120001 | ||||||
| STIER, John Robert | Amministratore | Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 78901530003 | |||||
| STONE, Christopher Michael Renwick | Amministratore | Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate Maylands Avenue HP2 4NW Hemel Hempstead Hertfordshire | United Kingdom | British | 66955690003 | |||||
| SUMMERS, Roger Denis | Amministratore | 15 Five Acres Danbury CM3 4NB Chelmsford Essex | British | 8559710001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Amministratore delegato nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di REBUS GROUP LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mr Stephen Allen Schwarzman | 04 nov 2019 | Park Ave NY 10154 New York 345 United States | Sì | ||||||||||
Nazionalità: American Paese di residenza: United States | |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Rebus Hr Holdings Limited | 03 ott 2016 | Peoplebuilding Estate, Maylands Avenue Hemel Hempstead Industrial Estate HP2 4NW Hemel Hempstead Peoplebuilding 2 England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per REBUS GROUP LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 06 lug 2021 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
REBUS GROUP LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 20 giu 2016 Consegnato il 23 giu 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Nil. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A grant of security interest in trademark rights | Creato il 19 apr 2011 Consegnato il 04 mag 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right title and interest in, to and under the trademarks being- star design reg no: 2,940,278 see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A grant of security interest in trademark rights | Creato il 19 apr 2011 Consegnato il 04 mag 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right title and interest in, to and under the trademarks being- star design, reg no:2,940,278 see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Intellectual property security agreement | Creato il 19 apr 2011 Consegnato il 03 mag 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Intellectual property being registered trademarks and trademark applications in rebus group limited, trademark star design, all proceeds and products of the foregoing, see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A deed of accession | Creato il 29 apr 2008 Consegnato il 12 mag 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from that charging company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A supplemental debenture | Creato il 09 lug 1999 Consegnato il 28 lug 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined therein) | |
Brevi particolari All freehold and leasehold property and all assets and undertakings. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creato il 18 mar 1999 Consegnato il 30 mar 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the finance documents defined therein | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 21 mar 1996 Consegnato il 27 mar 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0