REBUS GROUP LIMITED

REBUS GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàREBUS GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03109650
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di REBUS GROUP LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova REBUS GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Corporation Service Company (Uk) Limited
    5 Churchill Place, 10th Floor
    E14 5HU London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di REBUS GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    RICHTRACK PUBLIC LIMITED COMPANY03 ott 199503 ott 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di REBUS GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per REBUS GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    Notifica di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo

    2 paginePSC08

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Cessazione di Stephen Allen Schwarzman come persona con controllo significativo il 06 lug 2021

    1 paginePSC07

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Stato del capitale al 07 mag 2021

    • Capitale: GBP 0.02
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    legacy

    58 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 apr 2021 al 31 dic 2020

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Notifica di Stephen Allen Schwarzman come persona con controllo significativo il 04 nov 2019

    2 paginePSC01

    Cessazione di Rebus Hr Holdings Limited come persona con controllo significativo il 04 nov 2019

    1 paginePSC07

    Indirizzo della sede legale modificato da Peoplebuilding 2 Peoplebuilding Estate Maylands Avenue Hemel Hempstead Herts HP2 4NW a C/O Corporation Service Company (Uk) Limited 5 Churchill Place, 10th Floor London E14 5HU in data 04 nov 2020

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Andrew Phillip Monshaw come amministratore in data 21 ott 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Malcolm Robert Bennett come segretario in data 10 lug 2020

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Steven James Chalker come amministratore in data 30 giu 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Gillian Tiffney Gilliat Nolan come amministratore in data 30 giu 2020

    2 pagineAP01

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Chi sono gli amministratori di REBUS GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NOLAN, Gillian Tiffney Gilliatt
    5 Churchill Place, 10th Floor
    E14 5HU London
    C/O Corporation Service Company (Uk) Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    5 Churchill Place, 10th Floor
    E14 5HU London
    C/O Corporation Service Company (Uk) Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish271694390001
    BENNETT, Malcolm Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    208002930001
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    51 The Avenue
    WD17 4NU Watford
    Hertfordshire
    Segretario
    51 The Avenue
    WD17 4NU Watford
    Hertfordshire
    British75357260001
    LONEY, Nicholas John
    31 Viewfield Road
    Southfields
    SW18 5JD London
    Segretario
    31 Viewfield Road
    Southfields
    SW18 5JD London
    British8511300001
    MEADES, Derek Leslie
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    Segretario
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    British8142960002
    NUNN, Carol Jayne
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Segretario
    Boundary Way
    HP2 7HU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British101872040001
    RICHARDSON, John David
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    Segretario
    High Street
    Burnham
    SL1 7JD Slough
    27
    Berks
    British128558470001
    SCHENCK, Daniel William
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Usa181204960001
    SCORE, Timothy
    Chestnut Farmhouse
    Aylesbury Road
    HP27 0JT Monks Risborough
    Buckinghamshire
    Segretario
    Chestnut Farmhouse
    Aylesbury Road
    HP27 0JT Monks Risborough
    Buckinghamshire
    British103319060001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AL-SALEH, Adel Bedry
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Marylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    3rd Floor
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United StatesAmerican165900220001
    BIDWELL, Hugh Charles Philip, Sir
    The Parsonage
    Goodnestone
    CT3 1PJ Canterbury
    Kent
    Amministratore
    The Parsonage
    Goodnestone
    CT3 1PJ Canterbury
    Kent
    British58932210001
    BURTON, Michael John
    4a Langton Way
    SE3 7TL London
    Amministratore
    4a Langton Way
    SE3 7TL London
    British63922600001
    CHALKER, Steven James
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish221085650001
    COTTAM, Harold, Managing Director
    Pentwyn Farm
    Dorstone
    HR3 6AD Hereford
    Amministratore
    Pentwyn Farm
    Dorstone
    HR3 6AD Hereford
    United KingdomBritish32116700002
    DENLEY, Gareth Phillip
    31 Ashley Road
    KT12 1JB Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    31 Ashley Road
    KT12 1JB Walton On Thames
    Surrey
    British38711220001
    GREAVES, Andrew David
    Wood End Cottage Wood Lane
    SL2 3YY Hedgerley
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Wood End Cottage Wood Lane
    SL2 3YY Hedgerley
    Buckinghamshire
    British50048250001
    HELLER, Robert Gordon Barry
    53 Fitzroy Park
    N6 6JA London
    Amministratore
    53 Fitzroy Park
    N6 6JA London
    British2883040001
    HODGSON, David Charles
    755 Park Avenue
    New York 10021
    Usa
    Amministratore
    755 Park Avenue
    New York 10021
    Usa
    American63989560001
    LAKING, David Albert
    33 Station Road
    Nassington
    PE8 6QB Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    33 Station Road
    Nassington
    PE8 6QB Peterborough
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish82424930001
    LONEY, Nicholas John
    31 Viewfield Road
    Southfields
    SW18 5JD London
    Amministratore
    31 Viewfield Road
    Southfields
    SW18 5JD London
    British8511300001
    MCKINLEY, Edward Joseph
    The Priory
    3a Seymour Walk
    SW10 9NF London
    Amministratore
    The Priory
    3a Seymour Walk
    SW10 9NF London
    American38853950001
    MEADES, Derek Leslie
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Alfriston House
    The Avenue
    SL5 7LY Ascot
    Berkshire
    British8142960002
    MONSHAW, Andrew Phillip
    Peoplebuilding 2 Peoplebuilding
    Estate Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Herts
    Amministratore
    Peoplebuilding 2 Peoplebuilding
    Estate Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Herts
    United StatesAmerican239664830001
    PRESLAND, Peter Eric
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    Amministratore
    Rats Castle
    Castletons Oak Cranbrook Road
    TN27 8DY Biddenden Ashford
    Kent
    EnglandBritish7649630002
    ROSS, Stuart
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish20168110001
    SCORE, Timothy
    Chestnut Farmhouse
    Aylesbury Road
    HP27 0JT Monks Risborough
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Chestnut Farmhouse
    Aylesbury Road
    HP27 0JT Monks Risborough
    Buckinghamshire
    British103319060001
    SEED, John Junior
    Highfield House North Road
    BA2 6HW Bath
    Bath & North East Somerset
    Amministratore
    Highfield House North Road
    BA2 6HW Bath
    Bath & North East Somerset
    British8670120001
    STIER, John Robert
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish78901530003
    STONE, Christopher Michael Renwick
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Amministratore
    Peoplebuilding 2, Peoplebuilding Estate
    Maylands Avenue
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    United KingdomBritish66955690003
    SUMMERS, Roger Denis
    15 Five Acres
    Danbury
    CM3 4NB Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    15 Five Acres
    Danbury
    CM3 4NB Chelmsford
    Essex
    British8559710001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Amministratore delegato nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001

    Chi sono le persone con controllo significativo di REBUS GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Stephen Allen Schwarzman
    Park Ave
    NY 10154 New York
    345
    United States
    04 nov 2019
    Park Ave
    NY 10154 New York
    345
    United States
    Nazionalità: American
    Paese di residenza: United States
    Natura del controllo
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Rebus Hr Holdings Limited
    Peoplebuilding Estate, Maylands Avenue
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    England
    03 ott 2016
    Peoplebuilding Estate, Maylands Avenue
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 4NW Hemel Hempstead
    Peoplebuilding 2
    England
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneUk Companies House
    Numero di registrazione03719768
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per REBUS GROUP LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    06 lug 2021La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    REBUS GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 giu 2016
    Consegnato il 23 giu 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Nil.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 23 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 feb 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A grant of security interest in trademark rights
    Creato il 19 apr 2011
    Consegnato il 04 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in, to and under the trademarks being- star design reg no: 2,940,278 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A grant of security interest in trademark rights
    Creato il 19 apr 2011
    Consegnato il 04 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in, to and under the trademarks being- star design, reg no:2,940,278 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Intellectual property security agreement
    Creato il 19 apr 2011
    Consegnato il 03 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Intellectual property being registered trademarks and trademark applications in rebus group limited, trademark star design, all proceeds and products of the foregoing, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A deed of accession
    Creato il 29 apr 2008
    Consegnato il 12 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from that charging company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 12 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2008
    • 21 mag 2008
    • 05 apr 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A supplemental debenture
    Creato il 09 lug 1999
    Consegnato il 28 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under or pursuant to the finance documents (as defined therein)
    Brevi particolari
    All freehold and leasehold property and all assets and undertakings.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited as Security Agent for and on Behalf of the Financeparties (As Defined in the Supplemental Debenture)
    Transazioni
    • 28 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 18 mar 1999
    Consegnato il 30 mar 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge and the finance documents defined therein
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited(Acting as Security Agent for the Finance Parties Pursuant to the Facilities Agreement)
    Transazioni
    • 30 mar 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 mar 1996
    Consegnato il 27 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0