FLOMERICS GROUP LIMITED
Panoramica
| Nome della società | FLOMERICS GROUP LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03109660 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di FLOMERICS GROUP LIMITED?
- Altre ricerche e sviluppo sperimentale in scienze naturali e ingegneria (72190) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova FLOMERICS GROUP LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Pinehurst 2 Pinehurst Road GU14 7BF Farnborough Hampshire United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di FLOMERICS GROUP LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| FLOMERICS GROUP PLC | 22 nov 1995 | 22 nov 1995 |
| SHARETIMED PUBLIC LIMITED COMPANY | 03 ott 1995 | 03 ott 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di FLOMERICS GROUP LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per FLOMERICS GROUP LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 ago 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2022 al 30 mar 2023 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 ago 2022 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 18 ago 2022
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2021 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Adrian Gerald Buckley il 04 gen 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Faraday House Sir William Siemens Square Frimley Camberley GU16 8QD England a Pinehurst 2 Pinehurst Road Farnborough Hampshire GU14 7BF in data 04 gen 2022 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Sharon Hana Kahanov come segretario in data 13 dic 2021 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Oliver Paul Piers Lewis il 24 set 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 28 set 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2020 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 mar 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Darren Lee Macaskill come amministratore in data 01 mar 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Oliver Paul Piers Lewis come amministratore in data 01 mar 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 gen 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2019 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Simone Eufemia Agatha Davina come segretario in data 01 giu 2020 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Sharon Hana Kahanov come segretario in data 01 giu 2020 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 gen 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di FLOMERICS GROUP LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCKLEY, Adrian Gerald | Amministratore | Pinehurst Road GU14 7BF Farnborough Pinehurst 2 Hampshire United Kingdom | England | British | 78617250001 | |||||
| LEWIS, Oliver Paul Piers | Amministratore | Pinehurst Road GU14 7BF Farnborough Pinehurst 2 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 280292590002 | |||||
| ADRIAN, Anthony Brian | Segretario | 1083 Highland View Loop Redmond Oregon 97756 United States | British | 133502360001 | ||||||
| BUTCHER, Keith | Segretario | 35 Langdon Park TW11 9PR Teddington Middlesex | British | 295528240001 | ||||||
| DAVINA, Simone Eufemia Agatha | Segretario | Sir William Siemens Square Frimley GU16 8QD Camberley Faraday House England | 234711620001 | |||||||
| KAHANOV, Sharon Hana | Segretario | Sir William Siemens Square Frimley GU16 8QD Camberley Faraday House England | 270250710001 | |||||||
| OGLE, Christopher John Rathmell | Segretario | Tedwood 18 St Omer Road GU1 2DB Guildford Surrey | British | 41417240002 | ||||||
| PHILLIPS, David Peter | Segretario | 5 Fairlands Road GU3 3JB Guildford Surrey | British | 65269160001 | ||||||
| TATCHELL, David George | Segretario | 11 Longdown Lane North KT17 3HY Epsom Surrey | British | 45711320001 | ||||||
| WETZEL, Shannon | Segretario | c/o Mentor Graphics Corporation Sw Boeckman Road Wilsonville 97070 8005 Oregon Usa | British | 134659610001 | ||||||
| EPS SECRETARIES LIMITED | Segretario | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | 67339580001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| BEL BALZO, Mary | Amministratore | Nw 132nd Avenue Portland 2849 Oregon 97229 United States | Usa | United States | 138567060001 | |||||
| BIEDERMANN, Wolfgang Josef | Amministratore | Oberstrasse 62 FOREIGN Hamburg D-20144 Germany | German | 115385760001 | ||||||
| BUTCHER, Keith | Amministratore | 35 Langdon Park TW11 9PR Teddington Middlesex | England | British | 295528240001 | |||||
| CARTER, Gary, Dr | Amministratore | 6 Fairview SO24 9PR Alresford Hampshire | British | 76022920001 | ||||||
| FREED, Dean Mclean | Amministratore | 2766 Sw Hillsboro Avenue Portland Oregon 97201 Usa | United States | American | 46133630001 | |||||
| MACASKILL, Darren Lee | Amministratore | Sir William Siemens Square Frimley GU16 8QD Camberley Faraday House England | England | British | 178736540003 | |||||
| MANN, David William | Amministratore | Theydon Copt Forest Side CM16 4ED Epping Essex | England | British | 11201900001 | |||||
| MCNAIR, Martin Alexander | Amministratore | Highwood Lodge 31 Hampstead Lane N6 4RT London | British | 45711180001 | ||||||
| MORRIS, Timothy Richard Thomas | Amministratore | 6 Embankment Putney SW15 1LB London | British | 47240180002 | ||||||
| OGLE, Christopher John Rathmell | Amministratore | Tedwood 18 St Omer Road GU1 2DB Guildford Surrey | England | British | 41417240002 | |||||
| PHILLIPS, David Peter | Amministratore | 5 Fairlands Road GU3 3JB Guildford Surrey | British | 65269160001 | ||||||
| POPE, Maria | Amministratore | Sw Elm Street 97201 Portland 1717 Oregan Usa | American | 132567320001 | ||||||
| ROSTEN, Harvey Ivor | Amministratore | 148 Elm Road KT3 3HT New Malden Surrey | British | 27949440001 | ||||||
| ROWBOTHAM, Thomas Robert, Dr | Amministratore | The Old Rectory IP13 0BS Little Glenham Suffolk | England | British | 152082160001 | |||||
| TATCHELL, David George | Amministratore | Courtlands Park Copse RH5 4BL Dorking Surrey | British | 45711320002 | ||||||
| TEAGUE, Peter Roy | Amministratore | 25 Woodhayes Road Wimbledon SW19 4RF London | British | 51732720001 | ||||||
| VERMIJS, Walter Ernest | Amministratore | Holten Hommelteweg 2 7451km Netherlands | Netherlands | Dutch | 138281800001 | |||||
| EPS SECRETARIES LIMITED | Amministratore | Lacon House Theobalds Road WC1X 8RW London | 67339580001 | |||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||
| MIKJON LIMITED | Amministratore | 50 Stratton Street W1X 5FL London | 44503290001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Amministratore delegato nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di FLOMERICS GROUP LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siemens Aktiengesellschaft | 30 mar 2017 | Werner-Von-Siemens-Str. 80333 Munich 1 Germany | No | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||||
| Mentor Graphics Corporation | 06 apr 2016 | Sw Boeckman Road 97070 Wilsonville 8005 Oregon Usa | Sì | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0