PARK ROW GROUP LIMITED

PARK ROW GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPARK ROW GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03109700
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PARK ROW GROUP LIMITED?

    • Attività di società holding di servizi finanziari (64205) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova PARK ROW GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Central Square 8th Floor
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PARK ROW GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PARK ROW GROUP PLC07 mag 200207 mag 2002
    BIRCHIN INTERNATIONAL PLC19 set 199719 set 1997
    RUSHMERE WYNNE GROUP PLC28 nov 199528 nov 1995
    MARKETCOIN PUBLIC LIMITED COMPANY03 ott 199503 ott 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di PARK ROW GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per PARK ROW GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    17 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 apr 2017

    20 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da Benson House 33 Wellington Street Leeds LS1 4JP a Central Square 8th Floor 29 Wellington Street Leeds LS1 4DL in data 14 ott 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 apr 2016

    17 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 apr 2015

    11 pagine4.68

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O C/O Ambant Limited Marlow House Fifth Floor 1a Lloyds Avenue London EC3N 3AA United Kingdom* in data 27 mag 2014

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    5 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Bilancio annuale redatto al 03 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 ott 2013

    Stato del capitale al 10 ott 2013

    • Capitale: GBP 70,728,395
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Ambant Limited Lloyds Avenue House 6 Lloyds Avenue London EC3N 3AX

    1 pagineAD02

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2012

    27 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O 6Th Floor 14 South Parade Leeds West Yorkshire LS1 5QS United Kingdom* in data 04 dic 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 03 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2011

    28 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Royal Liver Building Liverpool Merseyside L3 1HT* in data 19 apr 2011

    1 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    2 pagineAD02

    Chi sono gli amministratori di PARK ROW GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COPPELL, Helen
    Chalky Bank Road
    Rainham
    ME8 7NP Gillingham
    27
    Kent
    Segretario
    Chalky Bank Road
    Rainham
    ME8 7NP Gillingham
    27
    Kent
    British159189030001
    CRABB, Steven Lee
    The Byeway
    WD31 1JW Rickmansworth
    2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    The Byeway
    WD31 1JW Rickmansworth
    2
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish93134850002
    GRANT, Philip James
    Albury Road
    Furneux Pelham
    SG9 0LP Buntingford
    Clay Chimneys House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Albury Road
    Furneux Pelham
    SG9 0LP Buntingford
    Clay Chimneys House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish34492660002
    ADAMS, Derek Stanley
    Lane End
    Birch Green
    CO2 0NH Colchester
    Essex
    Segretario
    Lane End
    Birch Green
    CO2 0NH Colchester
    Essex
    British45970110001
    CHAUDHRI, Farzana
    Oaklands
    Oudle Lane
    SG10 6DQ Much Hadham
    Hertfordshire
    Segretario
    Oaklands
    Oudle Lane
    SG10 6DQ Much Hadham
    Hertfordshire
    British55239490003
    CONNOLLY, William Stephen
    3 Dodleston Close
    CH43 9QZ Birkenhead
    Merseyside
    Segretario
    3 Dodleston Close
    CH43 9QZ Birkenhead
    Merseyside
    British86840740001
    LITTLE, David Anthony
    100 Kyrle Road
    SW11 6BA London
    Segretario
    100 Kyrle Road
    SW11 6BA London
    British77215960002
    MARKS, David Jeffrey
    Virginia Lodge
    Royston Grove
    HA5 4HE Pinner
    Middlesex
    Segretario
    Virginia Lodge
    Royston Grove
    HA5 4HE Pinner
    Middlesex
    British78129600001
    STEVENSON, Sandra Maureen
    197 Cotefield Drive
    LU7 8DW Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Segretario
    197 Cotefield Drive
    LU7 8DW Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British48454410001
    EMCEE NOMINEES LIMITED
    First Floor 31 Southampton Row
    WC1B 5HT London
    Segretario
    First Floor 31 Southampton Row
    WC1B 5HT London
    38708590001
    EPS SECRETARIES LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Segretario
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    67339580001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ABBOTT, Richard David
    The Old Parsonage
    Church Street, Ropley
    SO24 0DS Hampshire
    Amministratore
    The Old Parsonage
    Church Street, Ropley
    SO24 0DS Hampshire
    EnglandBritish78205110001
    ADAMS, Derek Stanley
    Lane End
    Birch Green
    CO2 0NH Colchester
    Essex
    Amministratore
    Lane End
    Birch Green
    CO2 0NH Colchester
    Essex
    British45970110001
    ALBERGE, Maurice Ernest
    27 Glenloch Road
    NW3 4DJ London
    Amministratore
    27 Glenloch Road
    NW3 4DJ London
    British49539510001
    ALLSUP, Mark William
    34 Dewhurst Road
    W14 0ES London
    Amministratore
    34 Dewhurst Road
    W14 0ES London
    British42154290002
    BAILEY, Martin
    Daisybank Drive
    CW11 4JR Sandbach
    Heathside
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Daisybank Drive
    CW11 4JR Sandbach
    Heathside
    Cheshire
    England
    EnglandBritish95450450003
    BURNETT, Steven Robert
    The Belfry Northop Country Park
    Northop
    CH7 6WD Mold
    Flintshire
    Amministratore
    The Belfry Northop Country Park
    Northop
    CH7 6WD Mold
    Flintshire
    United KingdomBritish56044450001
    BURR, Reginald Ivor
    21 St James Close
    Prince Albert Road St Johns Wood
    NW8 7LG London
    Amministratore
    21 St James Close
    Prince Albert Road St Johns Wood
    NW8 7LG London
    British70371780001
    BURR, Rosemary Karen
    8 Hamilton House
    NW8 9PN London
    Amministratore
    8 Hamilton House
    NW8 9PN London
    British15659480001
    DAVIES, Elzbieta Krystyna
    Gravee Du Sud
    The Grange
    GY1 1RP St Peter Port
    Guernsey
    Amministratore
    Gravee Du Sud
    The Grange
    GY1 1RP St Peter Port
    Guernsey
    British115958830001
    DAVIES, John Hamilton
    Denbies
    Bardfield Saling
    CM7 5EG Braintree
    Essex
    Amministratore
    Denbies
    Bardfield Saling
    CM7 5EG Braintree
    Essex
    EnglandBritish62682160001
    DENHEEN, Peter Gerard
    3 Pitcullen Terrace
    PH2 7EQ Perth
    Perthshire
    Amministratore
    3 Pitcullen Terrace
    PH2 7EQ Perth
    Perthshire
    British112863220001
    DOBSON, Kevin James, Dr
    9 Harris Close
    Spital
    CH63 9YX Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    9 Harris Close
    Spital
    CH63 9YX Wirral
    Merseyside
    EnglandBritish69819530006
    DRURY, Anthony Charles
    39 Redwood Glade
    LU7 3JT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Amministratore
    39 Redwood Glade
    LU7 3JT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    EnglandBritish78025460001
    FITZSIMMONS, Edward
    91 Glenferness Avenue
    Talbot Woods
    BH3 7ES Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    91 Glenferness Avenue
    Talbot Woods
    BH3 7ES Bournemouth
    Dorset
    EnglandBritish35037160002
    GARDENER, Edward Patrick Montgomery, Professor
    The Gables
    Gannock Park, Deganwy
    LL31 9PZ Conwy
    Gwynedd
    Amministratore
    The Gables
    Gannock Park, Deganwy
    LL31 9PZ Conwy
    Gwynedd
    WalesBritish66368000001
    GARDNER, Colyn, Doctor
    5 Oakley Street
    SW3 5NN London
    Amministratore
    5 Oakley Street
    SW3 5NN London
    British114586870001
    HARDY, Carol Margaret
    6 Bawson Court
    Gomersal
    BD19 4SA Cleckheaton
    West Yorkshire
    Amministratore
    6 Bawson Court
    Gomersal
    BD19 4SA Cleckheaton
    West Yorkshire
    EnglandBritish89078690001
    LASSEN, Richard Guy
    The Coach House
    27 Southern Road
    SO41 9HR Lymington
    Hampshire
    Amministratore
    The Coach House
    27 Southern Road
    SO41 9HR Lymington
    Hampshire
    EnglandBritish111572370001
    MAPES, Pamela
    75 Greenside Road
    W12 9JQ London
    Amministratore
    75 Greenside Road
    W12 9JQ London
    British60465150001
    MARKS, David Jeffrey
    Virginia Lodge
    Royston Grove
    HA5 4HE Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    Virginia Lodge
    Royston Grove
    HA5 4HE Pinner
    Middlesex
    EnglandBritish78129600001
    MCGREGOR, George
    7 Westmoreland Road
    PR8 6NX Southport
    Merseyside
    Amministratore
    7 Westmoreland Road
    PR8 6NX Southport
    Merseyside
    United KingdomBritish88000730002
    MCGREGOR, George
    94 Forest Road
    PR8 6HY Southport
    Merseyside
    Amministratore
    94 Forest Road
    PR8 6HY Southport
    Merseyside
    British88000730001
    MINNS, Anthony Stirling
    Stoney Ridge House
    Headley Road Grayshott
    GU26 6DP Hindhead
    Surrey
    Amministratore
    Stoney Ridge House
    Headley Road Grayshott
    GU26 6DP Hindhead
    Surrey
    United KingdomBritish1852650004

    PARK ROW GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security over shares agreement
    Creato il 29 mar 2011
    Consegnato il 04 apr 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from ambant limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    40,849,000 ordinary shares of £1 of park row associates limited and the related assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Liver (Ifa Holdings) PLC
    Transazioni
    • 04 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 15 apr 2008
    Consegnato il 29 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £5875.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    £5875.00.
    Persone aventi diritto
    • Bw Sipp Trustees Limited
    Transazioni
    • 29 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities
    Creato il 11 nov 2002
    Consegnato il 18 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All stocks shares bonds debentures or other securities deposited with the bank and any bonus or other new securities and all rights,moneys or property accruing. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 11 nov 2002
    Consegnato il 18 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as blue bridge house (essex); t/no EX431528.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creato il 11 nov 2002
    Consegnato il 18 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and liabilities due or to become due from the company (the "chargor") and by any other company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 06 ago 2002
    Consegnato il 07 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Bluebridge house colchester road halstead braintree district essex t/no EX431528. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    Transazioni
    • 07 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 06 ago 2002
    Consegnato il 09 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland International Limited
    Transazioni
    • 09 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 22 mag 1998
    Consegnato il 03 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a plot 155 princes riverside t/n 384711 the goodwill and connection of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 03 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 01 apr 1998
    Consegnato il 03 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £20,775 to be held by the landlord on deposit of a separate designated interest bearing account in england bearing interest at a competitive rate available in the market for such long term deposits at the bank of scotland in the name of the landlord
    Brevi particolari
    The rent interest or any other moneys payable to the landlord pursuant to a lease dated 1/4/98 (as defined) over premises on the 6TH floor of 1/6 lombard st,london EC3 may be withdrawn from the deposit account if the tenant does not pay after the 21 days time limit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Scottish Provident Institution
    Transazioni
    • 03 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 giu 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 25 set 1997
    Consegnato il 01 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 01 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 mar 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 13 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PARK ROW GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 set 2018Data di scioglimento
    25 apr 2014Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian C. Oakley-Smith
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0