MASTERFONE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMASTERFONE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03110370
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MASTERFONE LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MASTERFONE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    First Floor, Finchale House
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    Durham
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MASTERFONE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per MASTERFONE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    pagineGAZ2(A)

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 mar 2019

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 mar 2018

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 mar 2017

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Mr Robert William Jefferson come persona con controllo significativo il 31 mag 2017

    2 paginePSC04

    Modifica dei dettagli di Mr John Corbitt Barnsley come persona con controllo significativo il 31 mag 2017

    2 paginePSC04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Spencer Trerise Glanville il 05 ott 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Helen Louise Austin il 31 mag 2017

    1 pagineCH03

    Indirizzo della sede legale modificato da First Floor Earl Grey House 75-85 Grey Street Newcastle upon Tyne NE1 6EF a First Floor, Finchale House Belmont Business Park Durham Durham DH1 1TW in data 31 mag 2017

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 ott 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Cessazione della carica di Richard Mark Wright come amministratore in data 31 ago 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Spencer Trerise Glanville come amministratore in data 04 lug 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Thomas Michael Scott Wooldridge come amministratore in data 04 lug 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Helen Louise Austin come segretario in data 24 mar 2016

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Robert William Jefferson come amministratore in data 24 mar 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr John Corbitt Barnsley come amministratore in data 24 mar 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Thomas Michael Scott Wooldridge come segretario in data 24 mar 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Christopher John Dalzell come amministratore in data 15 dic 2015

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di MASTERFONE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AUSTIN, Helen Louise
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    Segretario
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    206671010001
    BARNSLEY, John Corbitt
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    Amministratore
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    EnglandBritish79608860004
    GLANVILLE, Spencer Trerise
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    Amministratore
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    EnglandBritish210542980002
    JEFFERSON, Robert William
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    Amministratore
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    EnglandBritish8394160003
    DYKE, Karin Patricia
    117 Moorside North
    NE4 9DY Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    117 Moorside North
    NE4 9DY Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British111712790001
    MCLACHLAN, Elsie
    Burn Brae
    Gilsland
    CA8 7BE Brampton
    Cumbria
    Segretario
    Burn Brae
    Gilsland
    CA8 7BE Brampton
    Cumbria
    British33660580003
    SWEETBAUM, Peter Mark
    Flat 1
    7 Ranulf Road
    NW2 2BT London
    Segretario
    Flat 1
    7 Ranulf Road
    NW2 2BT London
    American69912090001
    WOOLDRIDGE, Thomas Michael Scott
    Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    First Floor
    Segretario
    Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    First Floor
    146628670001
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Segretario
    112 Quayside
    NE99 1SB Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04363143
    94529700001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DALZELL, Christopher John
    Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    First Floor
    Amministratore
    Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    First Floor
    EnglandBritish9520500003
    HENDERSON, Anne Patricia
    38 Jesmond Dene Road
    Jesmond
    NE2 3LQ Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    38 Jesmond Dene Road
    Jesmond
    NE2 3LQ Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritish45099880001
    WILLIAMS, Nicholas Arthur Ross
    32 Fitzwilliam Road
    SW14 0DN London
    Amministratore
    32 Fitzwilliam Road
    SW14 0DN London
    British55342890002
    WOOLDRIDGE, Thomas Michael Scott
    Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    First Floor
    Amministratore
    Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    First Floor
    United KingdomBritish99757110003
    WRIGHT, Richard Mark
    Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    First Floor
    Amministratore
    Earl Grey House
    75-85 Grey Street
    NE1 6EF Newcastle Upon Tyne
    First Floor
    United KingdomBritish126811670002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MASTERFONE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Robert William Jefferson
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    06 apr 2016
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr John Corbitt Barnsley
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    06 apr 2016
    Belmont Business Park
    DH1 1TW Durham
    First Floor, Finchale House
    Durham
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    MASTERFONE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security dated 4, 9, 11, 27 and 29 september 2009 and 13 october 2009
    Creato il 13 ott 2009
    Consegnato il 05 nov 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole subjects k/a and forming part eurocentral mcneil drive, holytown t/no's LAN136498 and LAN136562.
    Persone aventi diritto
    • Ionic Limited
    Transazioni
    • 05 nov 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rental assignation
    Creato il 07 nov 2007
    Consegnato il 21 nov 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Lease between the members of the 2000/2001 europoint syndicate and amey infastructure services limited dated 9 july and. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rental assignation
    Creato il 14 ago 2007
    Consegnato il 30 ago 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The whole entitlement to receive all rents and other sums.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rental assignation
    Creato il 14 ago 2007
    Consegnato il 30 ago 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The whole entitlement to receive all rents and other sums.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 15/12/05 and
    Creato il 30 nov 2005
    Consegnato il 23 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects at netherhall road, excelsior park, wishaw t/no LAN115430 and LAN115136.
    Persone aventi diritto
    • Justus Corporation Limited
    Transazioni
    • 23 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 28 april 2004 and
    Creato il 01 apr 2004
    Consegnato il 18 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects at woodhall, mossend, registered in the land register of scotland under t/n 115607.
    Persone aventi diritto
    • Liverpool Victoria Friendly Society Limited
    Transazioni
    • 18 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 21 january 2004 and
    Creato il 15 gen 2004
    Consegnato il 28 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Woodhall mossend lanarkshire t/n LAN111466.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Holburn Life Limited
    Transazioni
    • 28 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment dated 5 april 2001 made between the members of the 2001 europoint syndicate (as defined)
    Creato il 05 apr 2001
    Consegnato il 20 apr 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    With full title guarantee assigns by way of security to bos the payment and discharge of the secured liabilities all right, title, benefit and interest of the assignor to: the rent guarantee charge (as defined): the construction cost charge (as defined).. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 9 april 2001 and
    Creato il 04 apr 2001
    Consegnato il 21 apr 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The area of ground extending to 1.789 acres lying in the county of lanark to the north of mcneil drive,eurocentral,holytown,lanarkshire; lan 136498.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Sale/purchase agreement assignation
    Creato il 04 apr 2001
    Consegnato il 13 apr 2001
    In corso
    Importo garantito
    In consideration of facilities made available by the governor and company of the bank of scotland to the company including all sums of money including principal interest and charges due and that may become due to the mortgagee in any manner of way by the company solely or jointly with any other person or persons or corporation and whether as principal or surety
    Brevi particolari
    The companys whole right and interest in a sale and purchase agreement between the members of the 2000/2001 europoint syndicate and brs developments limited of even date the companys whole right and interest in and to paragraph 3 of a letter of undertaking by the members of the 1998/1999 eurocentral syndicate in favour of brs developments limited of even date.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rental assignation
    Creato il 04 apr 2001
    Consegnato il 13 apr 2001
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in the terms of a personal bond of even date
    Brevi particolari
    Rent and other sums payable under a lease between the members of the 2000/2001 europoint syndicate and brs developments limited of 1.789 acres at mcneil.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 apr 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 5TH september 2000 and
    Creato il 30 giu 2000
    Consegnato il 13 set 2000
    In corso
    Importo garantito
    All present and future sums of money whatsoever due or to become due in terms of the personal bond granted by the members of the 1998/99 eurocentral syndicate (as defined in part 4 of the schedule) in favour of the governor and company of the bank of scotland dated 1 april 1999 as varied,amended or supplemented from time to time
    Brevi particolari
    The plot or area of ground lying within the district of motherwell,county of lanark extending to 2.65 hectares or thereby known as plot 4,mcneil drive,holytown,eurocentral business park,lanarkshire; t/nos LAN112513 and LAN94501; all parts,privileges and pertinents and all right,title and interest thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge and assignment of film rights and revenues between voyager 19 partnership ("voyager") (1), factor 8 films limited ("factor 8") (2) (together the "chargors") and the chargee (3)
    Creato il 21 mar 2000
    Consegnato il 30 mar 2000
    In corso
    Importo garantito
    The obligations and liabilities of the chargors to the chargee under or pursuant to clauses 4.2 and 4.3 of the chargee, together with the obligations of factor 8 and the rights of the chargee under clause 11 of the first acquisition agreement dated 21 march 2000 and voyager under clause 4.13 of the charge. The rights of recourse of the chargee under the charge against the partners (as defined) in voyager shall be limited to the proceeds of realisation of the security assets (as defined)
    Brevi particolari
    The master negative and the film rights and allrights title and interest in and to all monies payable to it under the first acquisition agreement, the second acquisition agreement and the sale agreement.
    Persone aventi diritto
    • Beautiful Films Limited
    Transazioni
    • 30 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 16TH april 1999 and
    Creato il 10 apr 1999
    Consegnato il 29 apr 1999
    In corso
    Importo garantito
    All present and future sums of money (howsoever arising) due and that may become due to the chargee in terms of the personal bond granted by masterfone limited as one of the members of the 1998/99 eurocentral syndicate
    Brevi particolari
    Plot 2 (0.55 hectares) and 3 (1.50 hectares) at mcneil drive, holytown, lanarkshire title number lan 136562.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on the 14TH april 1999 and
    Creato il 01 apr 1999
    Consegnato il 29 apr 1999
    In corso
    Importo garantito
    All present and future sums of money (howsoever arising) due and that may becomde due to the chargee in terms of the personal bond granted by masterfone limited as one of the members of the 1998/99 eurocentral syndicate
    Brevi particolari
    Plot 1 (4.65 hectares) at mcneil drive, holytown, lanarkshire title number LAN136498.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 29 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 07 nov 1997
    Consegnato il 14 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a site 2 royal quays coble dene north shields tyne and wear t/n TY335252 together with all buildings and fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Girobank PLC
    Transazioni
    • 14 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation in security
    Creato il 03 mag 1996
    Consegnato il 18 mag 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations monies and liabilities due or to become due owing or incurred by the borrowers (as defined in the charge) to the chargee in terms of a facility letter dated 29TH march 1996 (as defined) with the acceptance endorsed thereon (the facility letter) and any letter deed document or other confirming varying or amending or supplemental to the facility letter
    Brevi particolari
    All right title and benefit in and to the account numbered 00223888 held in the name of the 1995/1996 scottish power ez syndicate and maintained with bank of scotland edinburgh together with all balances standing to the credit of the account, any agreements or instruments and all rights.
    Persone aventi diritto
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transazioni
    • 18 mag 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 5TH april 1996
    Creato il 01 apr 1996
    Consegnato il 24 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by the borrowers (as defined) in favour of the united bank of kuwait PLC in terms of the facility letter and the facility agreement (as defined)
    Brevi particolari
    The lands and estate of woodhall lying in the county of lanark t/no lna 86593. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transazioni
    • 24 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland
    Creato il 29 mar 1996
    Consegnato il 12 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers (as defined therein) to the chargee under the terms of the facility letter and the facility agreement (both as defined therein)
    Brevi particolari
    All and whole those two plots or areas of ground lying in the former burgh of motherwell and wishaw and county of lanark extending in total to 4.597 hectares t/no. LAN115430.
    Persone aventi diritto
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transazioni
    • 12 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation in security
    Creato il 15 mar 1996
    Consegnato il 25 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of a facility letter dated 12TH march 1996,any letter deed,document or other confirming varying amending or supplemental thereto
    Brevi particolari
    The company's wholr right title and interest in the account details of which are set out on the paper apart to form 395 see form for details.
    Persone aventi diritto
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transazioni
    • 25 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignation in security
    Creato il 23 feb 1996
    Consegnato il 26 mar 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations monies and liabilities due from the borrowers as defined to the chargee in terms of a facility letter dated 21ST december 1995 and acceptance of the facility letter by the borrowers dated 21ST december 1995 and any letter deed document or other confirming or verifying amending or supplemental to the facility letter
    Brevi particolari
    The company's whole right title and interest in the account please see form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transazioni
    • 26 mar 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland
    Creato il 29 dic 1995
    Consegnato il 12 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and all or any of the other companies named therein to the chargee in terms of the facility letter and the facility agreement (both as defined)
    Brevi particolari
    All and whole the subjects forming part of the land and estate of woodhall liying in the county of lanark extending to 4.267 hectares or thereacouts (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transazioni
    • 12 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 dic 1995
    Consegnato il 10 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms iof the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The United Bank of Kuwait PLC
    Transazioni
    • 10 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0