ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED

ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03112560
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Dock No. 1
    Chatham Docks
    ME4 4SW Chatham
    Kent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NORDIC FOREST TERMINALS LIMITED01 mar 199601 mar 1996
    ASTRAL RAM LIMITED11 ott 199511 ott 1995

    Quali sono gli ultimi bilanci di ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2014 al 30 dic 2014

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    24 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 nov 2014

    Stato del capitale al 07 nov 2014

    • Capitale: GBP 300,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Philip Andrew Taylor il 07 feb 2014

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Leslie Ford House Tilbury Freeport Tilbury Essex RM18 7EH* in data 03 lug 2014

    1 pagineAD01

    Varie

    Section 519
    3 pagineMISC

    Nomina di Simon Lewis Collins come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Philip Andrew Taylor come amministratore

    3 pagineAP01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Cessazione della carica di Stuart Paterson come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Perry Glading come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Charles Hammond come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Kingston come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Pamela Smyth come segretario

    2 pagineTM02

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed nordic forest terminals LIMITED\certificate issued on 07/02/14
    4 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name07 feb 2014

    Risoluzione di cambio di nome della società il 31 gen 2014

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 11 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 ott 2013

    Stato del capitale al 18 ott 2013

    • Capitale: GBP 300,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    23 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Dettagli del direttore cambiati per Michael John Kingston il 27 set 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Charles Graham Hammond il 27 set 2013

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COLLINS, Simon Lewis
    Tradescant Drive
    DA13 0EL Meopham
    1
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Tradescant Drive
    DA13 0EL Meopham
    1
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish83026730002
    TAYLOR, Philip Andrew
    Mackintosh Close
    High Halstow
    ME3 8EQ Rochester
    19
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Mackintosh Close
    High Halstow
    ME3 8EQ Rochester
    19
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish70375340003
    MCNEILL, Morag
    9 Wester Coates Gardens
    Wester Coates
    EH12 5LT Edinburgh
    Segretario
    9 Wester Coates Gardens
    Wester Coates
    EH12 5LT Edinburgh
    British2396760002
    SMYTH, Pamela June
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    Segretario
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    British172006950001
    STEWART, Toni Maria
    9 Northwood Avenue
    High Halstow
    ME3 8SX Rochester
    Kent
    Segretario
    9 Northwood Avenue
    High Halstow
    ME3 8SX Rochester
    Kent
    British16959850001
    VON HACHT, Patrick
    Korsvagen 28
    Nacka 13142
    Sweden
    Segretario
    Korsvagen 28
    Nacka 13142
    Sweden
    Swedish107409340001
    FNCS SECRETARIES LIMITED
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    Segretario nominato
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    900011830001
    GLADING, Perry Dean
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    Amministratore
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    EnglandBritish261672620002
    HAMMOND, Charles Graham
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    Amministratore
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    ScotlandBritish498460009
    KINGSTON, Michael John
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    Amministratore
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    UkBritish83677410001
    MURRAY, William Wilson
    35a Barnton Avenue West
    EH4 6DF Edinburgh
    Amministratore
    35a Barnton Avenue West
    EH4 6DF Edinburgh
    United KingdomBritish498890002
    PATERSON, Stuart Randall
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    Amministratore
    Leslie Ford House
    Tilbury Freeport
    RM18 7EH Tilbury
    Essex
    ScotlandBritish64281400001
    PRICE, Colin John
    Orchard House
    164 Wateringbury Road
    ME19 6JD East Malling
    Kent
    Amministratore
    Orchard House
    164 Wateringbury Road
    ME19 6JD East Malling
    Kent
    EnglandBritish147963010001
    VON HACHT, Patrick
    Korsvagen 28
    Nacka 13142
    Sweden
    Amministratore
    Korsvagen 28
    Nacka 13142
    Sweden
    Swedish107409340001
    VON HACHT, Patrick
    Korsvagen 28
    Nacka 13142
    Sweden
    Amministratore
    Korsvagen 28
    Nacka 13142
    Sweden
    Swedish107409340001
    FNCS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    16 Churchill Way
    CF1 4DX Cardiff
    900011820001

    ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 30 mag 2006
    Consegnato il 13 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £12,000.00 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    The deposit and all interest.
    Persone aventi diritto
    • Redington Design Company Limited
    Transazioni
    • 13 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage deed
    Creato il 26 set 2001
    Consegnato il 28 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property known as land adjoining nos 6 and 7 berth chatham dockyard,gillingham kent. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage deed
    Creato il 26 set 2001
    Consegnato il 28 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property known as land to the north east of nos 6 and 7 berths at chatham docks gillingham kent. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge
    Creato il 11 gen 2001
    Consegnato il 12 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £81,000 from the company to the chargee with interest and charges thereon
    Brevi particolari
    A first fixed charge over the goods listed in the schedule attached to the form 395.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Udt Limited
    Transazioni
    • 12 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 21 ott 1997
    Consegnato il 05 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a berth 6, basin 3 chatham dockyard gillingham kent t/n K759631. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 05 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture deed
    Creato il 25 apr 1997
    Consegnato il 10 mag 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mag 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0