ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 03112560 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED?
- Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi
Dove si trova ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Dock No. 1 Chatham Docks ME4 4SW Chatham Kent |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| NORDIC FOREST TERMINALS LIMITED | 01 mar 1996 | 01 mar 1996 |
| ASTRAL RAM LIMITED | 11 ott 1995 | 11 ott 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2014 al 30 dic 2014 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Philip Andrew Taylor il 07 feb 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Leslie Ford House Tilbury Freeport Tilbury Essex RM18 7EH* in data 03 lug 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Varie Section 519 | 3 pagine | MISC | ||||||||||
Nomina di Simon Lewis Collins come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Philip Andrew Taylor come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Cessazione della carica di Stuart Paterson come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Perry Glading come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Charles Hammond come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Kingston come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Pamela Smyth come segretario | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed nordic forest terminals LIMITED\certificate issued on 07/02/14 | 4 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Michael John Kingston il 27 set 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Charles Graham Hammond il 27 set 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLLINS, Simon Lewis | Amministratore | Tradescant Drive DA13 0EL Meopham 1 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 83026730002 | |||||
| TAYLOR, Philip Andrew | Amministratore | Mackintosh Close High Halstow ME3 8EQ Rochester 19 Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 70375340003 | |||||
| MCNEILL, Morag | Segretario | 9 Wester Coates Gardens Wester Coates EH12 5LT Edinburgh | British | 2396760002 | ||||||
| SMYTH, Pamela June | Segretario | Leslie Ford House Tilbury Freeport RM18 7EH Tilbury Essex | British | 172006950001 | ||||||
| STEWART, Toni Maria | Segretario | 9 Northwood Avenue High Halstow ME3 8SX Rochester Kent | British | 16959850001 | ||||||
| VON HACHT, Patrick | Segretario | Korsvagen 28 Nacka 13142 Sweden | Swedish | 107409340001 | ||||||
| FNCS SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 16 Churchill Way CF1 4DX Cardiff | 900011830001 | |||||||
| GLADING, Perry Dean | Amministratore | Leslie Ford House Tilbury Freeport RM18 7EH Tilbury Essex | England | British | 261672620002 | |||||
| HAMMOND, Charles Graham | Amministratore | Leslie Ford House Tilbury Freeport RM18 7EH Tilbury Essex | Scotland | British | 498460009 | |||||
| KINGSTON, Michael John | Amministratore | Leslie Ford House Tilbury Freeport RM18 7EH Tilbury Essex | Uk | British | 83677410001 | |||||
| MURRAY, William Wilson | Amministratore | 35a Barnton Avenue West EH4 6DF Edinburgh | United Kingdom | British | 498890002 | |||||
| PATERSON, Stuart Randall | Amministratore | Leslie Ford House Tilbury Freeport RM18 7EH Tilbury Essex | Scotland | British | 64281400001 | |||||
| PRICE, Colin John | Amministratore | Orchard House 164 Wateringbury Road ME19 6JD East Malling Kent | England | British | 147963010001 | |||||
| VON HACHT, Patrick | Amministratore | Korsvagen 28 Nacka 13142 Sweden | Swedish | 107409340001 | ||||||
| VON HACHT, Patrick | Amministratore | Korsvagen 28 Nacka 13142 Sweden | Swedish | 107409340001 | ||||||
| FNCS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 16 Churchill Way CF1 4DX Cardiff | 900011820001 |
ARCELORMITTAL KENT WIRE TERMINALS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creato il 30 mag 2006 Consegnato il 13 giu 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £12,000.00 due or to become due from the company to | |
Brevi particolari The deposit and all interest. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage deed | Creato il 26 set 2001 Consegnato il 28 set 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/Hold property known as land adjoining nos 6 and 7 berth chatham dockyard,gillingham kent. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage deed | Creato il 26 set 2001 Consegnato il 28 set 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/Hold property known as land to the north east of nos 6 and 7 berths at chatham docks gillingham kent. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed charge | Creato il 11 gen 2001 Consegnato il 12 gen 2001 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £81,000 from the company to the chargee with interest and charges thereon | |
Brevi particolari A first fixed charge over the goods listed in the schedule attached to the form 395. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 21 ott 1997 Consegnato il 05 nov 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The l/h property k/a berth 6, basin 3 chatham dockyard gillingham kent t/n K759631. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture deed | Creato il 25 apr 1997 Consegnato il 10 mag 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0