THE CENTRE FOR ACCESSIBLE ENVIRONMENTS
Panoramica
| Nome della società | THE CENTRE FOR ACCESSIBLE ENVIRONMENTS |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale, esenzione dall'uso di 'Limited' |
| Numero di società | 03112684 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE CENTRE FOR ACCESSIBLE ENVIRONMENTS?
- Altre attività di servizi di informazione n.c.a. (63990) / Informazione e comunicazione
- Attività di consulenza ambientale (74901) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova THE CENTRE FOR ACCESSIBLE ENVIRONMENTS?
| Indirizzo della sede legale | 4th Floor Holyer House 20-21 Red Lion Court EC4A 3EB London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE CENTRE FOR ACCESSIBLE ENVIRONMENTS?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per THE CENTRE FOR ACCESSIBLE ENVIRONMENTS?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Cessazione della carica di Jim Watt come amministratore in data 29 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di John Ramm come amministratore in data 29 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Sheila Ann Hyde come amministratore in data 29 dic 2016 | 1 pagine | TM01 | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Nomina di Mr Jim Watt come amministratore in data 27 set 2016 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr John Ramm come amministratore in data 27 set 2016 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Paul Gamble come amministratore in data 30 set 2016 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Ms Sheila Ann Hyde come amministratore in data 27 set 2016 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 ago 2016 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Patrick Shaw come segretario in data 26 ago 2016 | 1 pagine | TM02 | ||
Bilancio redatto al 31 mar 2015 | 22 pagine | AA | ||
Bilancio annuale redatto al 06 ago 2015, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 3 pagine | AR01 | ||
Cessazione della carica di David William Petherick come amministratore in data 22 giu 2015 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Mary Pauline Nee come amministratore in data 10 mar 2015 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Vidur Lekh Chandra Dindayal come amministratore in data 22 giu 2015 | 1 pagine | TM01 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Patrick Shaw il 04 nov 2014 | 1 pagine | CH03 | ||
Cessazione della carica di Peter Lainson come amministratore in data 22 giu 2015 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2014 | 3 pagine | AA | ||
Bilancio annuale redatto al 06 ago 2014, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 5 pagine | AR01 | ||
Cessazione della carica di Barry Alan Chalkley come segretario in data 31 lug 2014 | 1 pagine | TM02 | ||
Nomina di Mr Patrick Shaw come segretario in data 01 ago 2014 | 2 pagine | AP03 | ||
Chi sono gli amministratori di THE CENTRE FOR ACCESSIBLE ENVIRONMENTS?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTER, Helen | Segretario | 70 South Lambeth Road London SW8 1RL | British | 121063730001 | ||||||
| CHALKLEY, Barry Alan | Segretario | 20-21 Red Lion Court EC4A 3EB London Holyer House United Kingdom | 170949300001 | |||||||
| LANGTON-LOCKTON, Sarah Lavinia | Segretario | 124 Harlesden Road NW10 2BB London | British | 48224380002 | ||||||
| SHAW, Patrick | Segretario | Havillands Place Wye TN25 5GJ Ashford 38 Kent England | 190473120001 | |||||||
| AINSLEY, David Richard Derek | Amministratore | Flat 1 Priory House 6 Friar Street EC4V 5DT London | United Kingdom | British | 75229950002 | |||||
| APLIN, David Thomas | Amministratore | 6 Maplehurst Road PO19 6QL Chichester West Sussex | British | 104119890001 | ||||||
| BONNETT, David Christopher Sturgess, Doctor | Amministratore | Floor Holyer House 20-21 Red Lion Court EC4A 3EB London 4th United Kingdom | United Kingdom | British | 81060210001 | |||||
| BUSH, Paul Hubert | Amministratore | Fawsley Fields Fawsley NN11 3BY Daventry Northamptonshire | United Kingdom | British | 142042900001 | |||||
| CAVE, Adrian Oswald Wynn | Amministratore | 21 Kenilworth Road W5 5PA London | Uk (England) | British | 40158610001 | |||||
| CONNOLLY, Philip John | Amministratore | 39 Derrick Gardens Anchor And Hope Lane SE7 7TA Charlton London | United Kingdom | British | 74044760001 | |||||
| DAVIES, Kathleen Anne | Amministratore | 1 Stirling Lodge Richmond Road EN5 1SL Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | 44865670001 | |||||
| DINDAYAL, Vidur Lekh Chandra | Amministratore | Floor Holyer House 20-21 Red Lion Court EC4A 3EB London 4th United Kingdom | England | British | 150366850002 | |||||
| EVANS, Barrie Nigel | Amministratore | 19 Record Road PO10 7NS Emsworth Hampshire | British | 53565190001 | ||||||
| GAMBLE, Paul | Amministratore | 20-21 Red Lion Court EC4A 3EB London Holyer House United Kingdom | United Kingdom | British | 170958450001 | |||||
| GOLDSMITH, Philip Selwyn | Amministratore | 41 Valiant House Vicarage Crescent SW11 3LU London | British | 44865660001 | ||||||
| GREGORY, John Howard | Amministratore | Fern House Whitchurch Road Cublington LU7 0LP Leighton Buzzard Bedfordshire | England | British | 49215480001 | |||||
| GUPTA, Patricia | Amministratore | 8 Lodge Road CM9 6HW Maldon Essex | United Kingdom | British | 44865650002 | |||||
| HANSON, Julienne, Professor | Amministratore | 70 South Lambeth Road London SW8 1RL | United Kingdom | British | 51731070002 | |||||
| HUNT, Arthur William | Amministratore | 20 Thorold Road Bitterne Park SO18 1JB Southampton Hampshire | British | 22836210001 | ||||||
| HYDE, Sheila Ann | Amministratore | Red Lion Court EC4A 3EB London Holyer House England | England | British | 129168190001 | |||||
| IRVING, Judith Marie | Amministratore | 10 Mayfield Grove M18 7JS Manchester | American | 61683850001 | ||||||
| KING, Vivien Margaret | Amministratore | Hatherleigh Place EX20 3JT Hatherleigh Devon | England | British | 114071620001 | |||||
| LAINSON, Peter | Amministratore | Floor Holyer House 20-21 Red Lion Court EC4A 3EB London 4th United Kingdom | United Kingdom | British | 155114550001 | |||||
| LISICKI, Andrew Zbigniew | Amministratore | Goat Hall Moreton Morrell CV35 9AN Warwick | British | 44865630002 | ||||||
| MALYAN, John Leonard | Amministratore | Brooklands Barn Wisborough Green RH14 0DQ Billingshurst West Sussex | British | 104459720001 | ||||||
| MORLAND, Charles Francis Harold | Amministratore | 2 Cottesmore Court Stanford Road W8 5QL London | British | 113814800001 | ||||||
| NEE, Mary Pauline | Amministratore | Floor Holyer House 20-21 Red Lion Court EC4A 3EB London 4th United Kingdom | England | British | 173271640001 | |||||
| NEWELL, Christopher William Paul | Amministratore | Woodleigh Ridgway Pyrford GU22 8PW Woking | England | British | 78225650002 | |||||
| PENTON, John Howard | Amministratore | 5a George Street AL3 4ER St Albans Hertfordshire | British | 44865610001 | ||||||
| PETHERICK, David William | Amministratore | Floor Holyer House 20-21 Red Lion Court EC4A 3EB London 4th United Kingdom | United Kingdom | British.New Zraland | 134067250001 | |||||
| PITTS, Joanna Harriet | Amministratore | 24 Carthew Villas W6 0BS London | British | 44865600001 | ||||||
| RAMM, John | Amministratore | Floor Holyer House 20-21 Red Lion Court EC4A 3EB London 4th | Wales | Bristish | 63882700001 | |||||
| RANDALL, Peter | Amministratore | 36 Palace Road KT8 9DL East Molesey Surrey | British | 14895890001 | ||||||
| SANDS, Michael George | Amministratore | Suite A, 1st Floor Midas House, 62 Goldsworth Road GU21 6LQ Woking Surrey | United Kingdom | British | 106494820002 | |||||
| SPIER, Robert Fitzhardinge Jenner | Amministratore | The Barn High Street North Stewkley LU7 0EZ Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 8842440001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di THE CENTRE FOR ACCESSIBLE ENVIRONMENTS?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habinteg Housing Association Limited | 06 apr 2016 | Red Lion Court EC4A 3EB London Holyer House England | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
THE CENTRE FOR ACCESSIBLE ENVIRONMENTS ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Legal charge | Creato il 22 lug 2008 Consegnato il 25 lug 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Suite 1 ground floor 70 south lambeth rd london by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 30 giu 2004 Consegnato il 15 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £60,000.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari L/H property known as ground floor suite 70 south lambeth road vauxhall london. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 30 giu 2004 Consegnato il 15 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £290,000.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari L/H property known as ground floor suite 70 south lambeth road vauxhall london. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0