BIOSEEK UK LIMITED
Panoramica
Nome della società | BIOSEEK UK LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 03113041 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BIOSEEK UK LIMITED?
- Altre ricerche e sviluppo sperimentale in scienze naturali e ingegneria (72190) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova BIOSEEK UK LIMITED?
Indirizzo della sede legale | C/O HARRISONS BUSINESS RECOVERY & INSOLVENCY (LONDON) LIMITED 3rd Floor, Office 305 31 Southampton Row Holborn WC1B 5HJ London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BIOSEEK UK LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ASTERAND UK LIMITED | 03 gen 2006 | 03 gen 2006 |
PHARMAGENE LABORATORIES LIMITED | 19 dic 1995 | 19 dic 1995 |
PHARMAGENE CONTRACT RESEARCH LIMITED | 12 ott 1995 | 12 ott 1995 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BIOSEEK UK LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per BIOSEEK UK LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 13 pagine | 4.71 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Harrisons Business Recovery & Insolvency (London) Limited 4th Floor 25 Shaftesbury Avenue London W1D 7EQ a 3rd Floor, Office 305 31 Southampton Row Holborn London WC1B 5HJ in data 07 nov 2016 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 mag 2016 | 13 pagine | 4.68 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 mag 2015 | 13 pagine | 4.68 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 mag 2014 | 11 pagine | 4.68 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 15 Fetter Lane London EC4A 1JP United Kingdom* in data 04 giu 2013 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 4 pagine | 4.70 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 2 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * 2 Orchard Road Royston Hertfordshire SG8 5HD* in data 03 set 2012 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 4 pagine | MG02 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed asterand uk LIMITED\certificate issued on 03/08/12 | 4 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Nomina di Dr. Peter Bailey Coggins come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 ott 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr John Davis come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr John Davis come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Stchur come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Martyn Coombs come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Stchur come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BIOSEEK UK LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVIS, John | Segretario | 440 Burroughs Detroit Mi Techone Suite 501 48202-3420 Usa | 162882900001 | |||||||
COGGINS, Peter Bailey, Dr | Amministratore | Glyn-Y-Mel Road Lower Town SA65 9LY Fishguard The Walled Garden Dyfed United Kingdom | Wales | British | Director | 122934550001 | ||||
DAVIS, John | Amministratore | 440 Burroughs Detroit Mi Techone Suite 501 48202-3420 Usa | Usa | American | Director | 162866090001 | ||||
BAXTER, Carol, Dr | Segretario | 16 Birchall Lane Cole Green SG14 2NR Hertford Hertfordshire | British | Research Scientist | 64509670001 | |||||
BAXTER, Gordon Smith, Dr | Segretario | 1 The Green Foxton CB2 6ST Cambridge | British | 53199280003 | ||||||
BUCKIE, James William, Dr | Segretario | 20 Victoria Square Kings Park FK8 2RB Stirling Stirlingshire | British | 103102300001 | ||||||
JOHNSTON, Neil Gerard, Dr | Segretario | 83 Coxs End Over CB4 5TY Cambridge Cambridgeshire | British | Accountant | 70672340001 | |||||
MURPHY, John | Segretario | 2 Orchard Road SG8 5HD Royston Pharmagene Laboratories Ltd Herts | British | Solicitor | 22243940001 | |||||
OPENSHAW, James Ronald | Segretario | 2 Orchard Road SG8 5HD Royston Hertfordshire | British | 82842080003 | ||||||
PELTON, Kenneth Oakley | Segretario | Manor Farm OX3 9TU Noke Oxfordshire | British | 79004970001 | ||||||
STCHUR, John | Segretario | Asterand Plc Techone Suite 501 440 Burroughs FOREIGN Detroit Mi 48202 3420 United States | American | Accountant | 119933680001 | |||||
NOMINEE SECRETARIES LTD | Segretario nominato | 3 Garden Walk EC2A 3EQ London | 900006780001 | |||||||
BAXTER, Gordon Smith, Dr | Amministratore | 1 The Green Foxton CB2 6ST Cambridge | England | British | Molecular Pharmacologist | 53199280003 | ||||
BRISCOE, Peter David | Amministratore | The Moat House New Hall Green SG12 7SD Wareside Hertfordshire | United Kingdom | British | Commercial Dir | 83702320002 | ||||
CHARLTON, Randal Christopher John | Amministratore | Asterand Plc, Techone Suite 501, 440 Burroughs. FOREIGN Detroit M148202-3420 Usa | British | Ceo | 111199280001 | |||||
COLEMAN, Robert Alexander | Amministratore | 54 London Road SG8 9EL Royston Hertfordshire | British | Company Director | 51055810001 | |||||
COOMBS, Martyn Stephen | Amministratore | The Old Bakehouse 28 Winslow Road, Granborough MK18 3NJ Buckingham Buckinghamshire | England | British | Director | 120617420001 | ||||
JOHNSTON, Neil Gerard, Dr | Amministratore | 14 Long Furlong Over CB4 5PG Cambridge | United Kingdom | British | Accountant | 321751730001 | ||||
LEE, David Gordon | Amministratore | The Bell House Rectory Farm Road Rectory Farm Road CB1 5LB Little Wilbraham Cambridgeshire | British | Independent Director | 48823070001 | |||||
LONG, Ronald Eric | Amministratore | Cedar Tree House Manor Road HP10 8JA Penn Buckinghamshire | England | British | Director | 30509730002 | ||||
MOYSES, Christopher, Dr | Amministratore | Btg International Limited 10 Fleet Place Limeburner Lane EC4M 7SB London | British | Company Director | 99754190001 | |||||
MURPHY, John | Amministratore | 2 Orchard Road SG8 5HD Royston Pharmagene Laboratories Ltd Herts | British | Solicitor | 22243940001 | |||||
OPENSHAW, James Ronald | Amministratore | 2 Orchard Road SG8 5HD Royston Hertfordshire | British | Company Director | 82842080003 | |||||
PELTON, Kenneth Oakley | Amministratore | Manor Farm OX3 9TU Noke Oxfordshire | United Kingdom | British | Director | 79004970001 | ||||
PRICE, Barry John, Dr | Amministratore | Warren Farmhouse Warren Cottages Warren Lane Cottered SG9 9QG Buntingford Hertfordshire | England | British | Director | 41700510001 | ||||
REID, John Anthony | Amministratore | The Old Vicarage Barnby In The Willows NG24 2SA Newark Nottinghamshire | British | Company Director | 72390510001 | |||||
RIDDELL, Alastair James, Dr | Amministratore | Cambridge Science Park 418 Milton Road CB4 0PA Cambridge Cambridgeshire | British | Managing Director | 105537260002 | |||||
STCHUR, John | Amministratore | Asterand Plc Techone Suite 501 440 Burroughs FOREIGN Detroit Mi 48202 3420 United States | Usa | American | Accountant | 119933680001 | ||||
STEBBING, Nowell, Dr | Amministratore | Tower House New Pale Road WA6 9EX Manley Cheshire | British | Company Director | 99515760001 | |||||
STEFANELLI, Martin James | Amministratore | Techone Suite 501, 440 Burroughs FOREIGN Detroit M148202-3420 Usa | American | Coo | 111199040001 | |||||
NOMINEE DIRECTORS LTD | Amministratore delegato nominato | 3 Garden Walk EC2A 3EQ London | 900006850001 |
BIOSEEK UK LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 22 ott 2010 Consegnato il 05 nov 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery (for details of actual properties charged please refer to the form MG01). See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 16 apr 2007 Consegnato il 21 apr 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari For details of property charged please R. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 03 gen 1997 Consegnato il 21 gen 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee and the investors as defined) under the investment agreements (as defined) and as the holders of the company's 1997 convertible loanstock created by an instrument dated 3RD december 1996 | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Rent deposit deed | Creato il 07 ago 1996 Consegnato il 13 ago 1996 | In corso | Importo garantito £12,500 under the terms of the deed | |
Brevi particolari The initial deposit being £12,500 which is lodged in accordance with the terms of the deed within an interest bearing deposit account opened by the landlord at its bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
BIOSEEK UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0