SOUTHEATH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOUTHEATH LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 03113713
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOUTHEATH LIMITED?

    • Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova SOUTHEATH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Park Hall Manor Park Hall Estate
    Little Hayfield
    SK22 2NN High Peak
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOUTHEATH LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per SOUTHEATH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 ott 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Woodville Calf Hill Road Thongsbridge Holmfirth West Yorkshire HD9 3UB England a Park Hall Manor Park Hall Estate Little Hayfield High Peak SK22 2NN in data 21 nov 2017

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 13 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015

    5 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 031137130010 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 031137130009 in pieno

    1 pagineMR04

    Indirizzo della sede legale modificato da Hollin Hall Hotel Jackson Lane Kerridge Macclesfield Cheshire SK10 5BG a Woodville Calf Hill Road Thongsbridge Holmfirth West Yorkshire HD9 3UB in data 12 ago 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 13 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 nov 2015

    Stato del capitale al 19 nov 2015

    • Capitale: GBP 150,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 dic 2014

    Stato del capitale al 27 dic 2014

    • Capitale: GBP 150,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 031137130009

    31 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 031137130010

    27 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 13 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 dic 2013

    Stato del capitale al 23 dic 2013

    • Capitale: GBP 150,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Steven Antony Ellis il 01 ott 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Steven Antony Ellis il 01 ott 2013

    1 pagineCH03

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio annuale redatto al 13 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di SOUTHEATH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ELLIS, Steven Antony
    Park Hall Estate
    Little Hayfield
    SK22 2NN High Peak
    Park Hall Manor
    England
    Segretario
    Park Hall Estate
    Little Hayfield
    SK22 2NN High Peak
    Park Hall Manor
    England
    British120170370002
    CLAYTON, Kris Harold Laurence
    Park Hall Estate
    Little Hayfield
    SK22 2NN High Peak
    Park Hall Manor
    England
    Amministratore
    Park Hall Estate
    Little Hayfield
    SK22 2NN High Peak
    Park Hall Manor
    England
    EnglandBritish51233000007
    ELLIS, Steven Antony
    Park Hall Estate
    Little Hayfield
    SK22 2NN High Peak
    Park Hall Manor
    England
    Amministratore
    Park Hall Estate
    Little Hayfield
    SK22 2NN High Peak
    Park Hall Manor
    England
    EnglandBritish120170370002
    DRAPER, Eileen Jane
    Gin Clough Farm
    Gin Clough, Rainow
    SK10 5XQ Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    Gin Clough Farm
    Gin Clough, Rainow
    SK10 5XQ Macclesfield
    Cheshire
    British69268880001
    IBBOTSON, Richard Walter
    52 School Green Lane
    S10 4GR Sheffield
    Segretario
    52 School Green Lane
    S10 4GR Sheffield
    British13153460002
    RM REGISTRARS LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Segretario nominato
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900000760001
    HAWKINS, James
    8 The Coppice
    Harley
    S61 3BS Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    8 The Coppice
    Harley
    S61 3BS Rotherham
    South Yorkshire
    British32961790002
    HAWKINS, Jonathon James
    19 Stoney Croft
    Hoyland Common
    S74 0LZ Barnsley
    South Yorkshire
    Amministratore
    19 Stoney Croft
    Hoyland Common
    S74 0LZ Barnsley
    South Yorkshire
    British108398630001
    HAWKINS, Paul
    74 Brooklands Avenue
    Fulwood
    S10 4GD Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    74 Brooklands Avenue
    Fulwood
    S10 4GD Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritish44835270002
    IBBOTSON, Richard Walter
    52 School Green Lane
    S10 4GR Sheffield
    Amministratore
    52 School Green Lane
    S10 4GR Sheffield
    United KingdomBritish13153460002
    RM NOMINEES LIMITED
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    Amministratore delegato nominato
    Second Floor
    80 Great Eastern Street
    EC2A 3RX London
    900009140001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SOUTHEATH LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Kris Harold Clayton
    Calf Hill Road
    Thongsbridge
    HD9 3UB Holmfirth
    Woodville
    West Yorkshire
    England
    06 apr 2016
    Calf Hill Road
    Thongsbridge
    HD9 3UB Holmfirth
    Woodville
    West Yorkshire
    England
    No
    Nazionalità: English
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    SOUTHEATH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 11 feb 2014
    Consegnato il 18 feb 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    F/H property k/a hollin hall jackson lane bollington macclesfield t/no CH372877. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 18 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 11 feb 2014
    Consegnato il 18 feb 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    F/H property k/a hollin hall jackson lane bollington macclesfield t/no CH372877. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 18 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 15 set 2008
    Consegnato il 19 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 15 set 2008
    Consegnato il 19 set 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Hollin hall hotel jackson lane bollington macclesfield cheshire t/no CH372877.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 set 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge over licensed premises
    Creato il 24 gen 2007
    Consegnato il 07 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a hollin hall hotel, jackson lane, bollington, macclesfield by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. The benefit of all justices excise or other licences or registration certificates held from time to time in connection with the business carried on at the property and the right to recover and receive any compensation payable at any time on account of the non-renewal of such licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 27 ott 2006
    Consegnato il 02 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 06 gen 2003
    Consegnato il 09 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property known as 2 lymmcroft terrace jacksons lane kerridge. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 09 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 19 giu 2000
    Consegnato il 23 giu 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money and liabilities due from regency hotel (ecclesfield) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold land - belgrade hotel,jackson lane,kerridge. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 23 giu 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 15 gen 1996
    Consegnato il 23 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The belgrade hotel bollington cheshire t/n-CH205520 and CH372877 with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 15 gen 1996
    Consegnato il 18 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 18 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0